Buscador CIF Logo

Actos BORME Tuin Zonne Veguilla Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tuin Zonne Veguilla Sl

Actos BORME Tuin Zonne Veguilla Sl - B14832299

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tuin Zonne Veguilla Sl con CIF B14832299

馃敊 Perfil de Tuin Zonne Veguilla Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tuin Zonne Veguilla Sl

22 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: T-SOLAR GLOBAL OPERATING ASSETS SL. Representan: CANALES TRENAS JOSE JUAN.Revocaciones. Apo.Man.Soli: PE脩A GUTIERREZ JODRA ALICIA. Nombramientos. Adm. Mancom.: PICAZO MURPABLO;PASTOR MIRA MARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 35216 , F 119, S 8, H M 491384, I/A 28 (15.12.23).

09 de Mayo de 2023
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35216 , F 118, S 8, H M 491384, I/A 27 (29.04.23).

17 de Febrero de 2023
Fusi贸n por uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: WINDMILL FOTOVOLTAICA SOCIEDAD LIMITADA. TUIN ZONNE LOSMOCHUELOS SL. TZ CASTILLO DE ALCOLEA SL. TZ ARCHIDONA I SL. TZ LA POZA SL. TZ BUENAVISTA SL. TZ ALCOLEALANCHA SL. TZ MORITA SL. ELDUAYEN FOTOVOLTAICA SL. PARQUE SOLAR HUERTO SON FALCONER SL. BOREALISSOLAR SL. EUROPEAN SUN PARK ARNEDO SL. PENTASOLAR SL. ASPA ENERGIAS RENOVABLES SL. PENSOLARPOZOHONDO SOCIEDAD LIMITADA. PENSOLAR POZOCA脩ADA SOCIEDAD LIMITADA. GRANADASOLAR ENERGIASRENOVABLES SOCIEDAD LIMITADA. TUIN ZONNE MEDINA SL. TZ EL CARPIO SL. Datos registrales. T 35216 , F 116, S 8, H M491384, I/A 26 (10.02.23).

21 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: PUNZON LORENZO DAVID;VERA SANCHIDRIAN ANA;IZQUIERDO GARCIA RAMONNICOLAS;VERA SANCHIDRIAN ANA;PASTOR MIRA MARIA. Datos registrales. T 35216 , F 116, S 8, H M 491384, I/A 25(14.11.22).

03 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANALES TRENAS JOSE JUAN;PICAZO MUR PABLO;PASTOR MIRA MARIA;BIDAGURENURBIETA MIREN;PE脩A GUTIERREZ JODRA ALICIA;COBOS ULVIUS NICOLAS;FUENTES MINGUEZ ANDREA;PONCE DE LEONPEREZ DANIEL. Apo.Manc.: CANALES TRENAS JOSE JUAN;PICAZO MUR PABLO;PASTOR MIRA MARIA;BIDAGUREN URBIETAMIREN. Datos registrales. T 35216 , F 113, S 8, H M 491384, I/A 24 (27.07.21).

02 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: CANALES TRENAS JOSE JUAN;PICAZO MUR PABLO;PASTOR MIRA MARIA;BIDAGUREN URBIETAMIREN. Datos registrales. T 35216 , F 113, S 8, H M 491384, I/A 23 (26.07.21).

20 de Abril de 2021
Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 34 5陋 (MADRID). Datos registrales. T 35216 , F 113, S 8, H M 491384, I/A 22 (13.04.21).

19 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA;BARBUDO SEPULVEDA ENRIQUE;HERREROVISAIRAS ORTEGA ELENA. Apo.Manc.: FERNANDEZ DURAN MANUEL;GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO;HERREROVISAIRAS ORTEGA ELENA;MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA. Datos registrales. T 35216 , F 112, S 8, H M 491384,I/A 20 (12.04.21).

Nombramientos. Apo.Manc.: CANALES TRENAS JOSE JUAN;PICAZO MUR PABLO;PASTOR MIRA MARIA;BIDAGUREN URBIETAMIREN. Datos registrales. T 35216 , F 112, S 8, H M 491384, I/A 21 (12.04.21).

15 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA. Nombramientos. Representan: CANALESTRENAS JOSE JUAN. Datos registrales. T 35216 , F 111, S 8, H M 491384, I/A 19 ( 8.04.21).

25 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ DURAN MANUEL;GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO;HERRERO VISAIRAS ORTEGAELENA;MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA. Datos registrales. T 35216 , F 111, S 8, H M 491384, I/A 18 (17.05.18).

30 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35216 , F 111, S 8, H M 491384,I/A 17 (22.11.17).

31 de Julio de 2017
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 67 - 6陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 35216 , F 110, S 8, H M 491384, I/A 16(20.07.17).

28 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ PARRA MARIA ENCINA;ALCARAZ GARCIA BARRERA HELIODORO. Datos registrales.T 35216 , F 110, S 8, H M 491384, I/A 15 (20.12.16).

04 de Noviembre de 2016
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TZ VEGUILLA 1 SL. TZ VEGUILLA 2 SL. TZ VEGUILLA 3 SL. TZ VEGUILLA 4 SL.TZ VEGUILLA 5 SL. TZ VEGUILLA 6 SL. TZ VEGUILLA 7 SL. Datos registrales. T 27273 , F 100, S 8, H M 491384, I/A 14(26.10.16).

03 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27273 , F 99, S 8, H M 491384,I/A 13 (26.10.16).

21 de Junio de 2016
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TUIN ZONNE ORIGEN SL. Datos registrales. T 27273 , F 99, S 8, H M 491384, I/A12 (13.06.16).

04 de Septiembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 263.763,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.553.727,00 Euros. Datos registrales. T 27273 , F 98, S 8,H M 491384, I/A 11 (26.08.15).

06 de Abril de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 625.478,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.289.964,00 Euros. Datos registrales. T 27273 , F 97, S 8,H M 491384, I/A 10 (26.03.15).

25 de Marzo de 2015
Nombramientos. Auditor: GRANERO YEPES ANTONIO. Datos registrales. T 27273 , F 97, S 8, H M 491384, I/A 9 (16.03.15).

13 de Febrero de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.081.751,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.664.486,00 Euros. Datos registrales. T 27273 , F 59, S8, H M 491384, I/A 8 ( 5.02.14).

22 de Febrero de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: LASO RODRIGUEZ JUAN MANUEL. Nombramientos. Representan: MARTINEZQUEIMADELOS MARTA. Datos registrales. T 27273 , F 59, S 8, H M 491384, I/A 7 (14.02.13).

26 de Septiembre de 2012
Cambio de domicilio social. C/ CABALLERO ANDANTE 8 (MADRID). Datos registrales. T 27273 , F 59, S 8, H M 491384, I/A 6(17.09.12).

17 de Enero de 2012
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27273 , F 58, S 8, H M 491384,

20 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LASO RODRIGUEZ JUAN MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: T-SOLAR GLOBALOPERATING ASSETS SL. Representan: LASO RODRIGUEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 27273 , F 58, S 8, H M 491384,I/A 4 ( 9.12.11).

23 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 852.192,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.582.735,00 Euros. Datos registrales. T 27273 , F 57, S 8,H M 491384, I/A 3 (11.02.10).

24 de Diciembre de 2009
Cambio de domicilio social. AVDA ARROYO DEL SANTO 6 3潞 (MADRID). Datos registrales. T 27273 , F 57, S 8, H M 491384, I/A2 (14.12.09).

04 de Agosto de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ QUEIMADELOS MARTA VIOLETA;BARBUDO SEPULVEDA ENRIQUE;ALVAREZPARRA MARIA ENCINA;ALCARAZ GARCIA BARRERA HELIODORO;HERRERO VISAIRAS ORTEGA ELENA. Datos registrales. T2070 , F 96, S 8, H CO 27617, I/A 6 (24.07.09).

23 de Abril de 2009
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2070 , F 96, S 8, H CO 27617,I/A 5 (14.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n