Buscador CIF Logo

Actos BORME Turiprom Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Turiprom Sa

Actos BORME Turiprom Sa - A12520284

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Castellon para Turiprom Sa con CIF A12520284

🔙 Perfil de Turiprom Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Castellon

Actos BORME de Turiprom Sa

24 de Septiembre de 2014
Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 1005, L 569, F 221, S 8, H CS15844, I/A NOTA (10.09.14).

27 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN PEREZ JOSE ANGEL;GARCIA TELLEZ JORGE;AIMEUR BELKHIS CARLOS. Presidente:MARTIN PEREZ JOSE ANGEL. Secretario: GARCIA TELLEZ JORGE. Con.Delegado: AIMEUR BELKHIS CARLOS. Nombramientos.Adm. Unico: PARDO MANRIQUE JOSE ENRIQUE. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: MODIFICADO ELARTICULO 15 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA DE ORGANO DE ADMINISTRACION.AMBIO DE DURACION DEL PLAZO DELORGANO DE ADMINISTRACION.MODIFICACION TOTALIDAD DE ESTATUTOS SOCIALES, CONFORME A LALEY DESOCIEDADES DE CAPITAL. Datos registrales. T 1005, L 569, F 64, S 8, H CS 15844, I/A 21 (16.09.11).

19 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: LOSADA CASTELL IVAN MANUEL. Datos registrales. T 1005, L 569, F 64, S 8, H CS 15844, I/A 20 (6.05.11).

18 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: LOSADA CASTELL IVAN MANUEL. Datos registrales. T 1005, L 569, F 64, S 8, H CS 15844, I/A 19 (8.11.10).

25 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA. Presidente: GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSEMARIA. Consejero: LOSADA CASTELL IVAN MANUEL. Secretario: LOSADA CASTELL IVAN MANUEL. Consejero: GONZALEZ DECALDAS MENDEZ JOSE MARIA;SANCHEZ GOMEZ PEDRO;LOSADA CASTELL JAIME LUIS. Nombramientos. Consejero:MARTIN PEREZ JOSE ANGEL;GARCIA TELLEZ JORGE;AIMEUR BELKHIS CARLOS. Presidente: MARTIN PEREZ JOSE ANGEL.Secretario: GARCIA TELLEZ JORGE. Con.Delegado: AIMEUR BELKHIS CARLOS. Datos registrales. T 1005, L 569, F 64, S 8, H CS15844, I/A 17 (16.08.10).

Revocaciones. Apoderado: MARQUEZ CARRASCAL RAFAEL. Datos registrales. T 1005, L 569, F 64, S 8, H CS 15844, I/A 18(16.08.10).

25 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apoderado: BASCO PASCUAL DIEGO;BASCO PASCUAL DIEGO. Apo.Manc.: SANCHEZ GOMEZPEDRO;SERRANO TELLO SALVADOR. Apo.Man.Soli: VELLON LAHOZ JUSTO. Datos registrales. T 1005, L 569, F 64, S 8, H CS15844, I/A 16 (12.02.10).

03 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZ JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: GONZALEZ DE CALDAS MUÑOZJOSE MARIA. Consejero: GONZALEZ DE CALDAS MENDEZ JOSE MARIA;SANCHEZ GOMEZ PEDRO;BASCO PASCUAL DIEGO.

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información