Buscador CIF Logo

Actos BORME U Hostels Albergues Juveniles Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera U Hostels Albergues Juveniles Sl

Actos BORME U Hostels Albergues Juveniles Sl - B86430626

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para U Hostels Albergues Juveniles Sl con CIF B86430626

馃敊 Perfil de U Hostels Albergues Juveniles Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de U Hostels Albergues Juveniles Sl

04 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DE OLIVEIRA SACRAMENTO NUNO RODOLFO. Nombramientos. Adm. Solid.: HINGSTONPAUL ANTHONY. Datos registrales. T 29872 , F 219, S 8, H M 535869, I/A 16 (27.09.22).

20 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apoderado: DELIGNY HERVE OLIVIER ARNAUD. Nombramientos. Apoderado: JAMES HARVEY PETER. Datosregistrales. T 29872 , F 219, S 8, H M 535869, I/A 15 (14.08.21).

10 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ ANA. Datos registrales. T 29872 , F 219, S 8, H M 535869, I/A 14 (30.10.20).

14 de Febrero de 2019
Cambio de objeto social. a) La adquisici贸n, tenencia, explotaci贸n, promoci贸n, comercializaci贸n, desarrollo, administraci贸n y cesi贸npor cualquier t铆tulo de establecimientos tur铆sticos y hoteleros, incluidos hostales, y de cualesquiera otros destinados a actividadesrelacionadas con el turismo, el ocio y el esparcimiento o r. Datos registrales. T 29872 , F 218, S 8, H M 535869, I/A 13 ( 7.02.19).

08 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: DE PABLO CAJAL JOSE RAMON;MORENO PEREZ MARIA ISABEL. Nombramientos. Apoderado:MORENO PEREZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 29872 , F 217, S 8, H M 535869, I/A 12 ( 1.02.19).

17 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: SEGAL SHARON NATALIE. Nombramientos. Apoderado: DELIGNY HERVE OLIVIER ARNAUD.Datos registrales. T 29872 , F 217, S 8, H M 535869, I/A 11 (10.12.18).

21 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ ANA. Datos registrales. T 29872 , F 215, S 8, H M 535869, I/A 9 (11.05.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARINEL-LO JORDAN ENRIQUE;HERNANDEZ SANTOS LETICIA;LAZARO MONGE ASUNCION.Datos registrales. T 29872 , F 216, S 8, H M 535869, I/A 10 (11.05.18).

04 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: BEVERIDGE DAVID MARK ANDREW. Nombramientos. Apoderado: SEGAL SHARON NATALIE. Datosregistrales. T 29872 , F 215, S 8, H M 535869, I/A 8 (24.11.17).

02 de Octubre de 2017
Nombramientos. Apoderado: MORENO PEREZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 29872 , F 214, S 8, H M 535869, I/A 7(21.09.17).

27 de Julio de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: BEVERIDGE DAVID MARK ANDREW. Datos registrales. T 29872 , F 214, S 8, H M 535869, I/A 6(19.07.17).

05 de Julio de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SAFESTAY HOSTELS MADRID SL. Datos registrales. T 29872 , F 213, S 8, H M535869, I/A 5 (27.06.17).

04 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CRESPO MORALES MERCEDES. Consejero: HINOJOSA POCH ALVARO;GARCIA FAUBELJAVIER;BIDENS HOLDING 2010 SL;OLHOM INVESTMENTS SL;GUSPAT SL;ALTEI INVESTMENTS SL;HINOJOSA POCH LUIS.Presidente: HINOJOSA POCH ALVARO. Con.Delegado: HINOJOSA POCH ALVARO. Representan: PEREZ LOPEZ GUSTAVO;DEPABLO CAJAL JOSE RAMON;NAVARRO HOMET ALBERTO;BALTANAS GONZALEZ OSCAR. Nombramientos. Adm. Solid.:LIPMAN LARRY GLENN;DE OLIVEIRA SACRAMENTO NUNO RODOLFO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Cambio de domicilio social. C/ SAGASTA 22 (MADRID).Datos registrales. T 29872 , F 213, S 8, H M 535869, I/A 4 (27.06.17).

22 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: HINOJOSA POCH ALVARO. Nombramientos. Consejero: HINOJOSA POCH ALVARO;GARCIAFAUBEL JAVIER;BIDENS HOLDING 2010 SL;OLHOM INVESTMENTS SL;GUSPAT SL;ALTEI INVESTMENTS SL;HINOJOSA POCHLUIS. Presidente: HINOJOSA POCH ALVARO. Con.Delegado: HINOJOSA POCH ALVARO. SecreNoConsj: CRESPO MORALESMERCEDES. Representan: DE PABLO CAJAL JOSE RAMON;BALTANAS GONZALEZ OSCAR;NAVARRO HOMETALBERTO;PEREZ LOPEZ GUSTAVO. Apoderado: DE PABLO CAJAL JOSE RAMON. Ampliaci贸n de capital. Capital: 900.000,00Euros. Resultante Suscrito: 903.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Se modifican los estatutos sociales mediante laaprobaci贸nde un nuevo texto.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 29783 , F 81, S 8, H M 535869, I/A 2 (12.06.12).

P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 29872 , F 212, S 8, H M 535869, I/A 3 (12.06.12).

03 de Abril de 2012
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.03.12. Objeto social: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCIONCOMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION., TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION., PRESTACION DE SERVICIOS.ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION. SERVICIOS EDUCATIVOS, SANITARIOS, DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO.Domicilio: PASEO DE LA CASTELLANA 140 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:HINOJOSA POCH ALVARO. Nombramientos. Adm. Unico: HINOJOSA POCH ALVARO. Datos registrales. T 29783 , F 80, S 8, HM 535869, I/A 1 (23.03.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n