Buscador CIF Logo

Actos BORME Umas Union Mutua Asistencial De Seguros A Prima Fija

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Umas Union Mutua Asistencial De Seguros A Prima Fija

Actos BORME Umas Union Mutua Asistencial De Seguros A Prima Fija - G28747574

Tenemos registrados 44 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Umas Union Mutua Asistencial De Seguros A Prima Fija con CIF G28747574

馃敊 Perfil de Umas Union Mutua Asistencial De Seguros A Prima Fija
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Umas Union Mutua Asistencial De Seguros A Prima Fija

05 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERNADES EROLES MANUEL SEGISMUNDO;NISTAL HERNANDEZ ANTONIO;CRIADO RECAEDUARDO. Secretario: CRIADO RECA EDUARDO. Nombramientos. Consejero: SEGARRA TORNE CARLOS;RILOVA DE LAHERA ANA MARIA DE LA O;ALBADALEJO SAMPER DANIEL TOMAS;CRIADO RECA EDUARDO;NISTAL HERNANDEZ ANTONIO.Datos registrales. T 40450 , F 224, S 1, H 10, I/A 92 (29.08.23).

Nombramientos. Secretario: CRIADO RECA EDUARDO. Datos registrales. T 40450 , F 224, S 1, H 10, I/A 93 (29.08.23).

05 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: ELLACURIA BEASCOECHEA JESUS;ELLACURIA BEASCOECHEA JESUS;BA脩ULS FONTANABERNARDO;SANCHEZ LOPEZ ANTONIO;POZA LOZANO BENEDICTO;GARCIA DEL CUETO ANTONIO;SAN JUAN CALLEJA

14 de Febrero de 2023
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T40450 , F 223, S 1, H 10, I/A 90 ( 7.02.23).

22 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: BENITO PEREGRINA ALBERTO. Vicepresid.: AYERRA SOLA CARLOS. Nombramientos.Presidente: AYERRA SOLA CARLOS. Vicepresid.: BENITO PEREGRINA ALBERTO. Secretario: CRIADO RECA EDUARDO. Datosregistrales. T 40450 , F 222, S 1, H 10, I/A 89 (15.12.22).

07 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BASAGOITI OLANO EDUARDO. Apo.Manc.: SOLIS SUPLE GORKA. Datos registrales. T 40450 ,F 220, S 1, H 10, I/A 88 (28.10.22).

20 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BASAGOITI OLANO EDUARDO. Datos registrales. T 40450 , F 218, S 1, H 10, I/A 86 (13.09.22).

25 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO. Consejero: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO;CERASRODRIGUEZ MEDINA CIRIACO;BRAVO DURO JOSE LUIS;REBOLLO MOZOS VICENTE;GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO.Presidente: REBOLLO MOZOS VICENTE. Nombramientos. Consejero: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO;BRAVO DURO JOSE LUIS.Con.Delegado: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO. Consejero: RODRIGUEZ MEDINA CIRIACO CESAR. Reelecciones. Consejero:SALES TRIGUERO ANTONIO;PE脩A RIPADO JULIAN. Datos registrales. T 40450 , F 217, S 1, H 10, I/A 85 (18.08.22).

02 de Septiembre de 2021
Fe de erratas: SE PUBLICARON POR ERROR LAS INSCRIPCIONES 83 Y 84 EN EL TOMO 34440 FOLIOS 112 Y 114, SIENDO LOCORRECTO TOMO 40450, FOLIOS 215 Y 217 RESPECTIVAMENTE. Datos registrales. T 40450 , F 215, S 1, H 10, I/A 83(24.08.21).

31 de Agosto de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CONDE POBES JOSE MARIA;SANAU VILLAROYA JAIME;LAGE GONZALEZ JULIO.Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GARCES MARTINEZ JOSE RAMON;GONZALEZ DIAZ PABLO.Nombramientos. Consejero: CERAS RODRIGUEZ MEDINA CIRIACO;ABELLANAS PELLEJERO JOAQUIN;BRAVO DURO JOSELUIS. Reelecciones. Consejero: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO;BENITO PEREGRINA ALBERTO;AYERRA SOLACARLOS;SOBRADILLO CARDONA JOSE DANIEL;QUINTAS FERNANDEZ PATRICIA. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 12潞, 28潞 Y 30潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 34440 , F 112, S 1, H10, I/A 83 (24.08.21).

Reelecciones. Cons.Del.Sol: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO. Vicesecret.: SOBRADILLO CARDONA JOSE DANIEL. Vicepresid.:AYERRA SOLA CARLOS. Secretario: BENITO PEREGRINA ALBERTO. Datos registrales. T 34440 , F 114, S 1, H 10, I/A 84(24.08.21).

12 de Febrero de 2021
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MUTUALIDAD DEL CLERO ESPA脩OL DE PREVISION SOCIAL. Datos registrales.T 34440 , F 108, S 1, H 10, I/A 82 ( 5.02.21).

12 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ PEREZ JOSE ALBERTO. Secretario: FERNANDEZ PEREZ JOSE ALBERTO.Vicepresid.: BENITO PEREGRINA ALBERTO. Nombramientos. Vicepresid.: AYERRA SOLA CARLOS. Secretario: BENITOPEREGRINA ALBERTO. Consejero: CRIADO RECA EDUARDO. Reelecciones. Consejero: REBOLLO MOZOSVICENTE;BERNADES EROLES MANUEL SEGISMUNDO;LAGE GONZALEZ JULIO;NISTAL HERNANDEZ ANTONIO;GIMENEZBARRIOCANAL FERNANDO. Presidente: REBOLLO MOZOS VICENTE. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA ELARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 34440 , F 108, S 1, H 10, I/A 81 ( 5.08.20).

06 de Mayo de 2020
Reelecciones. Consejero: PE脩A RIPADO JULIAN. Datos registrales. T 34440 , F 107, S 1, H 10, I/A 80 (28.04.20).

18 de Julio de 2019
Fe de erratas: Se public贸 por error las reelecciones como Consejeros de GARCES MARTINEZ JOSE RAMON y de GONZALEZ DIAZPABLO, siendo lo correcto su cese de miembro de organo. Datos registrales. T 34440 , F 104, S 1, H 10, I/A 77 (27.10.17).

21 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MACEIRA FERNANDEZ DICTINO;MELENDEZ PEREZ ERNESTO. Vicesecret.: MELENDEZ PEREZERNESTO. Nombramientos. Consejero: SANAU VILLAROYA JAIME;QUINTAS FERNANDEZ PATRICIA. Vicesecret.: SOBRADILLOCARDONA JOSE DANIEL. Reelecciones. Consejero: CONDE POBES JOSE MARIA;GOMEZ HIDALGO ANASTASIO;BENITOPEREGRINA ALBERTO;AYERRA SOLA CARLOS;SOBRADILLO CARDONA JOSE DANIEL;SALES TRIGUERO ANTONIO.Vicepresid.: BENITO PEREGRINA ALBERTO. Cons.Del.Sol: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO. Datos registrales. T 34440 , F 106, S1, H 10, I/A 79 (13.11.18).

07 de Febrero de 2018
Otros conceptos: Cesi贸n parcial de cartera de seguros de decesos de UMAS UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS APRIMA FIJA entidad Mutua de seguros, como parte cedente a ETERNA ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA, COMPA脩IA DESEGUROS Y REASEGUROS, como cesionaria.- Datos registrales. T 34440 , F 105, S 1, H 10, I/A 78 (29.01.18).

06 de Noviembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: POZA LOZANO BENEDICTO. Nombramientos. Consejero: NISTAL HERNANDEZ ANTONIO;LAGEGONZALEZ JULIO;GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Vicepresid.: BENITO PEREGRINA ALBERTO. Reelecciones.Consejero: GARCES MARTINEZ JOSE RAMON;FERNANDEZ PEREZ JOSE ALBERTO;REBOLLO MOZOS VICENTE;BERNADESEROLES MANUEL SEGISMUNDO;GONZALEZ DIAZ PABLO. Presidente: REBOLLO MOZOS VICENTE. Secretario: FERNANDEZPEREZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 34440 , F 104, S 1, H 10, I/A 77 (27.10.17).

24 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Vicepresid.: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Datosregistrales. T 34440 , F 102, S 1, H 10,1 , I/ 75 .(16.01.17).

Nombramientos. Apoderado: BASAGOITI OLANO EDUARDO. Datos registrales. T 34440 , F 102, S 1, H 10,1 , I/ 76 .(16.01.17).

25 de Octubre de 2016
Reelecciones. Consejero: MACEIRA FERNANDEZ DICTINO;PE脩A RIPADO JULIAN;MELENDEZ PEREZ ERNESTO;SALESTRIGUERO ANTONIO. Datos registrales. T 34440 , F 101, S 1, H 10,1 , I/ 72 .(17.10.16).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MELENDEZ PEREZ ERNESTO. Vicesecret.: PE脩A RIPADO JULIAN. Nombramientos.Cons.Del.Sol: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO. Vicesecret.: MELENDEZ PEREZ ERNESTO. Datos registrales. T 34440 , F 101, S 1,H 10,1 , I/ 73 .(17.10.16).

Ceses/Dimisiones. Secretario: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ PEREZ JOSEALBERTO. Datos registrales. T 34440 , F 102, S 1, H 10,1 , I/ 74 .(17.10.16).

13 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUINART FERNANDEZ JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: SALES TRIGUERO ANTONIO.Modificaciones estatutarias. NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 28577 , F 191, S 1, H 10,1 , I/ 71 .( 5.04.16).

26 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: BASAGOITI OLANO EDUARDO. Datos registrales. T 28577 , F 190, S 1, H 10,1 , I/ 70 .(16.10.15).

02 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: BASAGOITI OLANO EDUARDO;APARICIO SANCHEZ MARIA CARMEN. Datos registrales. T 28577, F 190, S 1, H 10,1 , I/ 69 .(25.09.15).

01 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: AIZPUN BOBADILLA FRANCISCO JAVIER;FORTUNY VIZCARRO JOAQUIM. Con.Delegado:FORTUNY VIZCARRO JOAQUIM. Secretario: CONDE POBES JOSE MARIA. Vicesecret.: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO.Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: GARCIA IGLESIAS DIODORO;RE脩E I BACH RAMON;PELLICERCASANOVA SALVADOR. Mmbr.Com.Del: DEL RINCON CIBRIAN JOSE LUIS;SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN;POZA LOZANOBENEDICTO;CONDE POBES JOSE MARIA;JUAREZ GARCIA-GASCO TOMAS. Nombramientos. Consejero: AYERRA SOLACARLOS;SOBRADILLO CARDONA JOSE DANIEL. Con.Delegado: MELENDEZ PEREZ ERNESTO. Secretario: GOMEZ HIDALGOANASTASIO. Vicesecret.: PE脩A RIPADO JULIAN. Reelecciones. Consejero: CONDE POBES JOSE MARIA;GOMEZ HIDALGOANASTASIO;BENITO PEREGRINA ALBERTO. Datos registrales. T 28577 , F 189, S 1, H 10,1 , I/ 68 .(23.09.15).

01 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: FORTUNY VIZCARRO JOAQUIM. Datos registrales. T 28577 , F 188, S 1, H 10,1 , I/ 67 .(24.03.15).

26 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Auditor: QUORUM AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 28577 , F 188, S 1, H 10,1 , I/ 66 .(18.02.15).

17 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Dir. General: POZA LOZANO BENEDICTO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: POZA LOZANO BENEDICTO.Apoderado: POZA LOZANO BENEDICTO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: POZA MORICHE JUAN IGNACIO. Apo.Sol.: FORTUNYVIZCARRO JOAQUIN. Apo.Man.Soli: FORTUNY VIZCARRO JOAQUIN. Datos registrales. T 28577 , F 187, S 1, H 10,1 , I/ 65 .(5.12.14).

15 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: POZA LOZANO BENEDICTO. Consejero: JUAREZ GARCIA-GASCO TOMAS;GARCES MARTINEZJOSE RAMON;POZA LOZANO BENEDICTO;GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO;FERNANDEZ PEREZ JOSEALBERTO;REBOLLO MOZOS VICENTE. Presidente: JUAREZ GARCIA-GASCO TOMAS. Vicepresid.: GIMENEZ BARRIOCANALFERNANDO. Nombramientos. Consejero: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO;POZA LOZANO BENEDICTO;GARCESMARTINEZ JOSE RAMON;FERNANDEZ PEREZ JOSE ALBERTO;REBOLLO MOZOS VICENTE;BERNADES EROLES MANUELSEGISMUNDO;GONZALEZ DIAZ PABLO. Presidente: REBOLLO MOZOS VICENTE. Vicesecret.: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO.Vicepresid.: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO. Datos registrales. T 28577 , F 186, S 1, H 10,1 , I/ 64 .( 4.12.14).

15 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apoderado: DEL RINCON CIBRIAN JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: JUAREZ GARCIA-GASCOTOMAS;GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO;FORTUNY VIZCARRO JOAQUIN. Otros conceptos: SE REVOCA EL PODERCONFERIDO A FAVOR DE D. JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ, EN ESCRITURA AUTORIZADA EL 26 DE JULIO DE 2.004, POR ELNOTARIO DE MADRID, D. MANUEL HURLE GONZALEZ, CON EL N潞 2.692, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 35&. Datosregistrales. T 28577 , F 185, S 1, H 10,1 , I/ 62 .( 7.10.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MATABOSCH SOLER ANTONIO;CANO ALCAIDE RAFAEL. Nombramientos. Consejero: BENITOPEREGRINA ALBERTO. Reelecciones. Consejero: MACEIRA FERNANDEZ DICTINO;GUINART FERNANDEZ JOSE MARIA;PE脩ARIPADO JULIAN;MELENDEZ PEREZ ERNESTO. Auditor: QUORUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28577 , F 185, S 1, H10,1 , I/ 63 .( 7.10.13).

23 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Con.Delegado: JUAREZ GARCIA-GASCO TOMAS. Consejero:SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Nombramientos. Consejero: GOMEZ HIDALGO ANASTASIO. Pres.Honorif: ROUCO VARELAANTONIO MARIA. Presidente: JUAREZ GARCIA-GASCO TOMAS. Vicepresid.: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO.Con.Delegado: FORTUNY VIZCARRO JOAQUIM. Reelecciones. Consejero: CANO ALCAIDE RAFAEL;CONDE POBES JOSEMARIA;FORTUNY VIZCARRO JOAQUIM;AIZPUN BOBADILLA FRANCISCO JAVIER. Secretario: CONDE POBES JOSE MARIA.Datos registrales. T 28577 , F 184, S 1, H 10,1 , I/ 61 .(11.07.12).

21 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Vicepresid.: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Cons.Del.Man:SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Nombramientos. Presidente: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Con.Delegado: JUAREZ GARCIA-GASCO TOMAS. Reelecciones. Secretario: CONDE POBES JOSE MARIA. Otros conceptos: RATIFICACION DEL CARGO DEVICESECRETARIO DE DON BENEDICTO POZA LOZANO. Datos registrales. T 28577 , F 184, S 1, H 10,1 , I/ 60 .( 8.07.11).

13 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL RINCON CIBRIAN JOSE LUIS. Presidente: DEL RINCON CIBRIAN JOSE LUIS.Nombramientos. Consejero: GIMENEZ BARRIOCANAL FERNANDO;FERNANDEZ PEREZ JOSE ALBERTO;REBOLLO MOZOSVICENTE;MELENDEZ PEREZ ERNESTO;AIZPUN BOBADILLA FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: JUAREZ GARCIA-GASCO TOMAS;GARCES MARTINEZ JOSE RAMON;POZA LOZANO BENEDICTO. Datos registrales. T 28577 , F 183, S 1, H 10,1, I/ 59 .(30.06.11).

07 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRETE MURRIA RAFAEL. Secretario: NAVARRETE MURRIA RAFAEL. Consejero: SANCHEZSANCHO LUIS MARIA. Nombramientos. Secretario: CONDE POBES JOSE MARIA. Consejero: MELENDEZ PEREZ ERNESTO.Datos registrales. T 28577 , F 182, S 1, H 10,1 , I/ 58 .(26.05.11).

10 de Mayo de 2011
Nombramientos. Apoderado: POZA LOZANO BENEDICTO;SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Datos registrales. T 28577 , F 182, S1, H 10,1 , I/ 57 .(27.04.11).

06 de Abril de 2011
Nombramientos. Auditor: QUORUM AUDITORES SLP. Consejero: MACEIRA FERNANDEZ DICTINO;MATABOSCH SOLERANTONIO. Reelecciones. Consejero: GUINART FERNANDEZ JOSE MARIA;PE脩A RIPADO JULIAN;SANCHEZ SANCHO LUISMARIA. Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 28577, F 182, S 1, H 10,1 , I/ 56 .(28.03.11).

05 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERREIRO FERNANDEZ SANTIAGO;LANUZA MESEGUER JOSE ANTONIO. Nombramientos.Consejero: SANCHEZ SANCHO LUIS MARIA. Reelecciones. Consejero: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN;CANO ALCAIDERAFAEL;CONDE POBES JOSE MARIA;FORTUNY VIZCARRO JOAQUIM;NAVARRETE MURRIA RAFAEL. Vicepresid.: SANCHEZRODRIGUEZ JUAN. Cons.Del.Sol: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Cons.Del.Man: SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN. Secretario:NAVARRETE MURRIA RAFAEL. Datos registrales. T 19961 , F 24, S 1, H 10,1 , I/ 55 .(24.03.11).

11 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: BGT AUDITORES SL. Datos registrales. T 19961 , F 24, S 1, H 10,1 , I/ 54 .(28.12.09).

08 de Enero de 2010
Reelecciones. Consejero: RE脩E I BACH RAMON;GARCIA IGLESIAS DIODORO;DEL RINCON CIBRIAN JOSE LUIS;JUAREZGARCIA-GASCO TOMAS;GARCES MARTINEZ JOSE RAMON;POZA LOZANO BENEDICTO. Presidente: DEL RINCON CIBRIANJOSE LUIS. Vicesecret.: POZA LOZANO BENEDICTO. Datos registrales. T 19961 , F 23, S 1, H 10,1 , I/ 53 .(23.12.09).

12 de Febrero de 2009
Reelecciones. Auditor: BGT AUDITORES SL. Datos registrales. T 19961 , F 23, S 1, H 10,1 , I/ 52 .( 2.02.09).

09 de Febrero de 2009
Reelecciones. Auditor: BGT AUDITORES SL. Datos registrales. T 19961 , F 22, S 1, H 10,1 , I/ 51 .(29.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n