Actos BORME de Uniarte Sa
03 de Abril de 2019Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: UNIARTE DOORS SL. OCA脩A LOGISTICA SL. Disoluci贸n. Escision.Extinci贸n. Datos registrales. T 1642 , F 190, S 8, H TO 706, I/A 76 (27.03.19).
13 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ALARCON ALEJANDRE JORGE. Datos registrales. T 1642 , F 190, S 8, H TO 706, I/A 75(29.10.18).
05 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: ESPADA SAELICES LEONCIO. Apo.Sol.: ESPADA SAELICES LEONCIO. Apo.Manc.: ESCOLAR ORTIZVICTORIANO. Apo.Sol.: ESCOLAR ORTIZ VICTORIANO. Nombramientos. Apo.Sol.: ESCOLAR ORTIZ VICTORIANO;PARDOBENAVENTE JOSE LUIS;TARRAGO PUJOL JORGE. Apo.Manc.: ESCOLAR ORTIZ VICTORIANO;PARDO BENAVENTE JOSE
05 de Octubre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 689.141,70 Euros. Desembolsado: 689.141,70 Euros. Resultante Suscrito: 1.863.655,30 Euros.Resultante Desembolsado: 1.863.655,30 Euros. Datos registrales. T 1642 , F 190, S 8, H TO 706, I/A 73 (27.09.18).
07 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: ANTON LOPEZ RAMON;NIETO ROSALES DAVID. Datos registrales. T 1642 , F 190, S 8, H TO 706,I/A 72 (27.08.18).
22 de Enero de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 549.250,00 Euros. Desembolsado: 549.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.174.513,60 Euros.Resultante Desembolsado: 1.174.513,60 Euros. Datos registrales. T 1642 , F 189, S 8, H TO 706, I/A 71 (15.01.18).
07 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDUJAR SANTOS JOSE JUAN. Secretario: ANDUJAR SANTOS JOSE JUAN. Nombramientos.SecreNoConsj: ANDUJAR SANTOS JOSE JUAN. Consejero: ALARCON ALEJANDRE JORGE. Reelecciones. Auditor: HORWATHAUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 1642 , F 189, S 8, H TO 706, I/A 70 (30.11.17).
05 de Junio de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 845/2009. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 5/12/2012. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 1 1陋 INSTANCIA N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ.Resoluciones: La anotaci贸n preventiva letra A, referente a la aprobaci贸n del Convenio, ha quedado convertida en inscripci贸n definitiva,seg煤n diligencia de ordenaci贸n dictada el 05/03/2015 por la Letrado de la Administraci贸n de Justicia del Juzgado D陋. Mar铆a JesusGracia Guerrero. Datos registrales. T 1642 , F 189, S 8, H TO 706, I/A 69 (29.05.17).
09 de Mayo de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 399.750,00 Euros. Desembolsado: 399.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 625.263,60 Euros.Resultante Desembolsado: 625.263,60 Euros. Datos registrales. T 1613 , F 205, S 8, H TO 706, I/A 68 ( 3.05.17).
06 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ-GASCO GARCIA JUAN ANTONIO;CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER. Presidente:LOPEZ-GASCO GARCIA JUAN ANTONIO. Secretario: ANDUJAR SANTOS JOSE JUAN. Nombramientos. Consejero: ENCINASPLIEGO VICTOR;ANDUJAR SANTOS JOSE JUAN. Secretario: ANDUJAR SANTOS JOSE JUAN. Presidente: EUROPEANCONSULTING ADVISORS SL. Datos registrales. T 1613 , F 205, S 8, H TO 706, I/A 66 (23.02.17).
03 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 1613 , F 205, S 8, H TO 706, I/A 65(22.12.16).
04 de Octubre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 274.622,40 Euros. Resultante Suscrito: 30.513,60 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 195.000,00 Euros. Desembolsado: 195.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 225.513,60 Euros. Resultante Desembolsado:225.513,60 Euros. Datos registrales. T 1613 , F 204, S 8, H TO 706, I/A 64 (26.09.16).
19 de Agosto de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ESPADA SAELICES LEONCIO;ESCOLAR ORTIZ VICTORIANO. Apo.Manc.: ESPADA SAELICESLEONCIO;ESCOLAR ORTIZ VICTORIANO. Datos registrales. T 1613 , F 204, S 8, H TO 706, I/A 63 (11.08.16).
21 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DOOR CAPITAL PARTNERS SL;ESPADA SAELICES LEONCIO;FERNANDEZ DE GOROSTIZAISBERT FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: DOOR CAPITAL PARTNERS SL. Presidente: ESPADA SAELICES LEONCIO.Cons.Del.Man: ESPADA SAELICES LEONCIO. Secretario: FERNANDEZ DE GOROSTIZA ISBERT FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER;EUROPEAN CONSULTING ADVISORS SL. Presidente:LOPEZ-GASCO GARCIA JUAN ANTONIO. Con.Delegado: EUROPEAN CONSULTING ADVISORS SL. Secretario: ANDUJARSANTOS JOSE JUAN. Consejero: LOPEZ-GASCO GARCIA JUAN ANTONIO;GRAELLS MARCH JOSEP. Datos registrales. T 1613 ,F 204, S 8, H TO 706, I/A 62 (14.07.16).
04 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: NU脩EZ DE VILLAVICENCIO ALVARO. Secretario: NU脩EZ DE VILLAVICENCIO ALVARO.Cons.Del.Man: NU脩EZ DE VILLAVICENCIO ALVARO. Vicepresid.: FERNANDEZ DE GOROSTIZA ISBERT FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: DOOR CAPITAL PARTNERS SL. Vicepresid.: DOOR CAPITAL PARTNERS SL. Secretario:FERNANDEZ DE GOROSTIZA ISBERT FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1592 , F 141, S 8, H TO 706, I/A 61 (26.11.15).
29 de Julio de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 101.712,00 Euros. Desembolsado: 101.712,00 Euros. Resultante Suscrito: 305.136,00 Euros.Resultante Desembolsado: 305.136,00 Euros. Datos registrales. T 1592 , F 141, S 8, H TO 706, I/A 60 (20.07.15).
14 de Noviembre de 2014Revocaciones. Auditor: AUDINEX SA. Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T1592 , F 141, S 8, H TO 706, I/A 59 ( 6.11.14).
03 de Noviembre de 2014Otros conceptos: Modificado el art铆culo 6 de los estatutos sociales al objeto de permitir la libre transmisibilidad de las acciones.Datos registrales. T 1592 , F 140, S 8, H TO 706, I/A 58 (23.10.14).
09 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: CUESTA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1492 , F 140, S 8, H TO 706, I/A 57 (2.10.14).
14 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPADA SAELICES LEONCIO;CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER;NIETO JIMENEZEMILIANO;NEVADO CAMPOS JOAQUIN;ENCINAS PLIEGO VICTOR-MANUEL. Presidente: ESPADA SAELICES LEONCIO.Cons.Del.Man: ESPADA SAELICES LEONCIO. Secretario: ENCINAS PLIEGO VICTOR-MANUEL. Vicepresid.: CUESTA MARTINEZFRANCISCO-JAVIER. Cons.Del.Man: CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER. Nombramientos. Consejero: ESPADASAELICES LEONCIO;NU脩EZ DE VILLAVICENCIO ALVARO;FERNANDEZ DE GOROSTIZA ISBERT FRANCISCO JAVIER.Presidente: ESPADA SAELICES LEONCIO. Vicepresid.: FERNANDEZ DE GOROSTIZA ISBERT FRANCISCO JAVIER. Secretario:
26 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SESMERO VALIENTE JESUS. Datos registrales. T 1457 , F 185, S 8, H TO 706, I/A 55 (18.06.14).
21 de Marzo de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.558.355,20 Euros. Resultante Suscrito: 203.424,00 Euros. Datos registrales. T 1457 , F185, S 8, H TO 706, I/A 54 (13.03.14).
26 de Diciembre de 2013Reelecciones. Presidente: ESPADA SAELICES LEONCIO. Vicepresid.: CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER. Secretario:ENCINAS PLIEGO VICTOR-MANUEL. Cons.Del.Man: ESPADA SAELICES LEONCIO;CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER.Datos registrales. T 1457 , F 134, S 8, H TO 706, I/A 53 (16.12.13).
28 de Octubre de 2013Revocaciones. Aud.C.Con.: AD VERITAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1457 , F 134, S 8, H TO 706, I/A 50 (21.10.13).
Nombramientos. Auditor: AUDINEX SA. Datos registrales. T 1457 , F 134, S 8, H TO 706, I/A 51 (21.10.13).
Reelecciones. Consejero: CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER;SESMERO VALIENTE JESUS;NIETO JIMENEZ EMILIANO.Datos registrales. T 1457 , F 134, S 8, H TO 706, I/A 52 (21.10.13).
02 de Septiembre de 2013Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 845/2009. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 5/12/2012. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ.Resoluciones: Practicada anotaci贸n preventiva de la aprobaci贸n judicial del convenio propuesto por UNIARTE, S.A. La Administraci贸nconcursal continuar谩 en funciones exclusivamente para la tramitaci贸n de la Secci贸n de calificaci贸n, incluida la ejecuci贸n.de lospronunciamientos condenatorios de la sentencia. Datos registrales. T 1457 , F 118, S 8, H TO 706, I/A A (26.08.13).
31 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: AD VERITAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1457 , F 118, S 8, H TO 706, I/A 49 (22.10.12).
30 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: AD VERITAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1457 , F 118, S 8, H TO 706, I/A 48 (21.11.11).
21 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: OLAYA SERRADILLA ANGEL ENRIQUE. Consejero: OLAYA SERRADILLA ANGEL ENRIQUE.Vicepresid.: ESPADA SAELICES LEONCIO. Nombramientos. Presidente: ESPADA SAELICES LEONCIO. Vicepresid.: CUESTAMARTINEZ FRANCISCO-JAVIER. Datos registrales. T 1457 , F 118, S 8, H TO 706, I/A 47 (10.11.11).
03 de Agosto de 2011Nombramientos. Aud.C.Con.: AD VERITAS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1457 , F 118, S 8, H TO 706, I/A 46 (20.07.11).
04 de Octubre de 2010Reelecciones. Consejero: OLAYA SERRADILLA ANGEL ENRIQUE;NEVADO CAMPOS JOAQUIN. Vicepresid.: ESPADA SAELICESLEONCIO. Cons.Del.Man: CUESTA MARTINEZ FRANCISCO-JAVIER;ESPADA SAELICES LEONCIO. Consejero: ESPADASAELICES LEONCIO;ENCINAS PLIEGO VICTOR-MANUEL. Presidente: OLAYA SERRADILLA ANGEL ENRIQUE. Secretario:ENCINAS PLIEGO VICTOR-MANUEL. Datos registrales. T 1457 , F 117, S 8, H TO 706, I/A 45 (23.09.10).
18 de Enero de 2010Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 845/2009. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 26/11/2009. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANOMARTINEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 845/2009. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 26/11/2009. Resolucionesacordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 1 1&INSTANCIA N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ. Resoluciones: El deudorconservar谩 las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de 茅stas a laintervenci贸n de los administradores concursales, mediante su autorizaci贸n o conformidad. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 845/2009. Fecha de resoluci贸n 26/11/2009. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA N潞 1 Y DELO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ. Administrador Concursal. Fecha 26/11/2009, NIF/CIF3743700J. GOMEZ DE LAS HERAS MARTIN MAESTRO LUIS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 845/2009. Fecha deresoluci贸n 26/11/2009. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO.Juez: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ. Administrador Concursal. Fecha 26/11/2009, NIF/CIF 3868524Q. GARCIA BARGUE脩OJAVIER. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 845/2009. Fecha de resoluci贸n 26/11/2009. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANOMARTINEZ. Administrador Concursal. Fecha 26/11/2009, NIF/CIF A48265169. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA. Datosregistrales. T 1457 , F 117, S 8, H TO 706, I/A 44 ( 4.01.10).