Buscador CIF Logo

Actos BORME Unidad De Servicios Logisticos Integrales Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Unidad De Servicios Logisticos Integrales Sl

Actos BORME Unidad De Servicios Logisticos Integrales Sl - B83288175

Tenemos registrados 44 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Unidad De Servicios Logisticos Integrales Sl con CIF B83288175

🔙 Perfil de Unidad De Servicios Logisticos Integrales Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Unidad De Servicios Logisticos Integrales Sl

21 de Octubre de 2022
Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LOPRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL VIGENTE REGLAMENTO. Datos registrales. T 17520 , F 215, S 8, H M 301020, I/A51M (14.10.22).

04 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17520 , F 214, S 8, H M 301020, I/A 51 (27.09.21).

02 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ GARCIA JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 17520 , F 213, S 8, H M 301020, I/A49 (26.08.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELGADO RODRIGUEZ AMADOR. Datos registrales. T 17520 , F 213, S 8, H M 301020, I/A 50(26.08.21).

17 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS FELIPE;LUCAS ROMERO JAVIER;MORENO MARTINEZRAUL;BONASTRE ESQUIA SUSANA. Datos registrales. T 17520 , F 213, S 8, H M 301020, I/A 48 (10.08.21).

12 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17520 , F 213, S 8, H M 301020, I/A 47 ( 4.01.21).

01 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ GAVALDA JOAQUIN. Datos registrales. T 17520 , F 212, S 8, H M 301020, I/A 45 (24.11.20).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTELLA GIL ERNESTO. Datos registrales. T 17520 , F 212, S 8, H M 301020, I/A 46 (24.11.20).

21 de Enero de 2020
Nombramientos. Apoderado: SERRANO DURAN MONICA. Datos registrales. T 17520 , F 211, S 8, H M 301020, I/A 44 (14.01.20).

14 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JORGE PEREZ AROA. Datos registrales. T 17520 , F 209, S 8, H M 301020, I/A 40 ( 7.11.19).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: QUINTANA LOPEZ-AYALA JUAN ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: MOREIRA E SILVACELESTINO. Datos registrales. T 17520 , F 210, S 8, H M 301020, I/A 41 ( 7.11.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: QUINTANA LOPEZ-AYALA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 17520 , F 210, S 8, H M 301020,I/A 42 ( 7.11.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA IVAN. Datos registrales. T 17520 , F 210, S 8, H M 301020, I/A 43 ( 7.11.19).

25 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANZ CRESPI CARLOS. Datos registrales. T 17520 , F 208, S 8, H M 301020, I/A 38 (16.04.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHANCA MERINO MARTA. Datos registrales. T 17520 , F 208, S 8, H M 301020, I/A 39 (16.04.19).

19 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: BLANCO LAIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 17520 , F 208, S 8, H M 301020, I/A 37 (10.10.18).

22 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GAVALDA JOAQUIN. Datos registrales. T 17520 , F 207, S 8, H M 301020, I/A 36(15.06.18).

11 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17520 , F 207, S 8, H M 301020, I/A 35 (29.11.17).

21 de Junio de 2017
Cambio de objeto social. La sociedad tiene por objeto la prestación, a las sociedades integrantes del Grupo y vinculadas, de losservicios logísticos, de organización, gestión de recursos humanos, administración, soporte técnico, sistemas y demás servicios deapoyo necesarios para el desarrollo de su objeto social, tanto en. Datos registrales. T 17520 , F 207, S 8, H M 301020, I/A 34(12.06.17).

14 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: MARCELO GARCIA ANA MARIA. Otros conceptos: Revocada la ampliación de poder a favor de DoñaAna María Marcelo García, que causó la inscripción 30ª. Datos registrales. T 17520 , F 206, S 8, H M 301020, I/A 33 ( 5.06.17).

09 de Diciembre de 2016
Otros conceptos: SE MODIFICA Y AMPLIA LA FORMA DE ACTUACION DE LAS FACULTADES CONFERIDAS A LOSAPODERADOS NOMBRADOS MEDIANTE LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 29ª DE ESTA HOJA. Datos registrales.T 17520 , F 206, S 8, H M 301020, I/A 32 (29.11.16).

05 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA LAFUENTE PEDRO ANGEL;RODRIGUEZ GARCIA JUAN FRANCISCO. Fe de erratas: SEOMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 29ª LA PUBLICACION DE LOS PODERES ASIGNADOS A PEDRO ANGEL GARCIALAFUENTE Y JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA. Datos registrales. T 17520 , F 205, S 8, H M 301020, I/A 29 ( 1.08.16).

Nombramientos. Apo.Manc.: MARCELO GARCIA ANA MARIA;LAIZ PABLOS ANUNCIACION;CHANCA MERINO MARTA;BLANCOLAIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 17520 , F 206, S 8, H M 301020, I/A 31 (24.11.16).

02 de Diciembre de 2016
Otros conceptos: SE MODIFICA Y AMPLIA LA FORMA DE ACTUACION DE LAS FACULTADES CONFERIDAS A LOSAPODERADOS NOMBRADOS MEDIANTE LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 27ª DE ESTA HOJA. Datos registrales.T 17520 , F 206, S 8, H M 301020, I/A 30 (23.11.16).

08 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ GARCIA IVAN;DELGADO RODRIGUEZ AMADOR. Datos registrales. T 17520 , F 205, S8, H M 301020, I/A 29 ( 1.08.16).

24 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: GARCIA LAFUENTE PEDRO ANGEL;QUINTANA LOPEZ JUAN ANTONIO;RODRIGUEZ GARCIA JUANFRANCISCO;CARCELEN ESPARCIA ESTHER;SANZ CRESPI CARLOS. Datos registrales. T 17520 , F 205, S 8, H M 301020, I/A28 (15.06.16).

06 de Junio de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: MARCELO GARCIA ANA MARIA;LAIZ PABLOS ANUNCIACION;CHANCA MERINO MARTA;BLANCOLAIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 17520 , F 205, S 8, H M 301020, I/A 27 (30.05.16).

21 de Enero de 2016
Revocaciones. Apoderado: LAIN JOSE MARIA BLANCO. Apo.Sol.: MARCELO GARCIA ANA MARIA;LAIZ PABLOSANUNCIACION;CHANCA MERINO MARTA. Apo.Man.Soli: BLANCO LAIN JOSE MARIA;LAIZ PABLOS ANUNCIACION;MARCELOGARCIA ANA MARIA;CHANCA MERINO MARTA. Datos registrales. T 17520 , F 204, S 8, H M 301020, I/A 26 (13.01.16).

28 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OROZCO FERNANDEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: QUINTANA LOPEZ-AYALA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 17520 , F 204, S 8, H M 301020, I/A 25 (17.12.15).

15 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLANCO LAIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 17520 , F 201, S 8, H M 301020, I/A 20 (

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANZ CRESPI CARLOS. Datos registrales. T 17520 , F 201, S 8, H M 301020, I/A 21 ( 1.09.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAIZ PABLOS ANUNCIACION. Datos registrales. T 17520 , F 202, S 8, H M 301020, I/A 22 (1.09.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCELO GARCIA ANA MARIA. Datos registrales. T 17520 , F 203, S 8, H M 301020, I/A 23 (1.09.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CHANCA MERINO MARTA. Datos registrales. T 17520 , F 204, S 8, H M 301020, I/A 24 ( 1.09.15).

31 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARCELEN ESPARCIA ESTHER. Datos registrales. T 17520 , F 163, S 8, H M 301020, I/A 16(21.08.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA LAFUENTE PEDRO ANGEL. Datos registrales. T 17520 , F 163, S 8, H M 301020, I/A 17(21.08.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUINTANA LOPEZ-AYALA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 17520 , F 165, S 8, H M 301020,I/A 18 (21.08.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ GARCIA JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 17520 , F 200, S 8, H M 301020,I/A 19 (21.08.15).

15 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17520 , F 163, S 8, H M 301020,I/A 15 ( 5.09.14).

23 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 17520 , F 162, S 8, H M 301020, I/A 14 (16.09.13).

24 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 17520 , F 162, S 8, H M 301020, I/A 13 (11.10.12).

06 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apoderado: SANZ CRESPI CARLOS. Datos registrales. T 17520 , F 162, S 8, H M 301020, I/A 12 (28.07.10).

05 de Enero de 2010
Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 17520 , F 161, S 8, H M 301020, I/A 11(23.12.09).

18 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: CARCELEN ESPARCIA ESTHER. Datos registrales. T 17520 , F 161, S 8, H M 301020, I/A 10 (9.12.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información