Buscador CIF Logo

Actos BORME Unidad De Vehiculos Industriales Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Unidad De Vehiculos Industriales Sa

Actos BORME Unidad De Vehiculos Industriales Sa - A32154015

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Orense para Unidad De Vehiculos Industriales Sa con CIF A32154015

馃敊 Perfil de Unidad De Vehiculos Industriales Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Orense

Actos BORME de Unidad De Vehiculos Industriales Sa

24 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Apo.Manc.: GONZALEZ PEREIRA FRANCISCOJAVIER;GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO. Apo.Sol.: GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO;PADRON CONDE JUAN CARLOS.Apo.Manc.: PEREZ MARTINEZ ELOY;PADRON CONDE JUAN CARLOS;GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO;GONZALEZ PEREIRAFRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: PADRON CONDE JUAN CARLOS;LEGIDO MARI脩O EVA MARIA;PEREZ BARCA JUANCARLOS;GONZALEZ VILLAR TANIA. Apo.Manc.: LECOMPTE ALEXANDER. Apo.Sol.: PEREZ BARCA JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 905 , F 51, S 8, H OR 2997, I/A 51 ( 8.03.22).

02 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ PEREIRA FRANCISCO JAVIER;GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO;PADRON CONDEJUAN CARLOS. Apo.Sol.: GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO;GONZALEZ PEREIRA FRANCISCO JAVIER;PADRON CONDE JUANCARLOS. Datos registrales. T 905 , F 50, S 8, H OR 2997, I/A 50 (22.02.22).

04 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 905 , F 50, S 8, H OR 2997, I/A 49 (26.01.22).

28 de Agosto de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: UNVI CARROCEROS SL. Nombramientos. Adm. Unico: UNVI CARROCEROS SL. Datosregistrales. T 905 , F 50, S 8, H OR 2997, I/A 48 (19.08.20).

13 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: CABO PAREJO PATRICIA;CONDE GONZALEZ ANABEL. Datos registrales. T 905 , F 50, S 8, H OR2997, I/A 47 ( 1.02.19).

14 de Enero de 2019
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 764 , F 176, S 8, H OR 2997, I/A 46 (27.12.18).

14 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: RODAS MEIRA NURIA. Nombramientos. Apo.Sol.: PADRON CONDE JUAN CARLOS;FERNANDEZCONDE SONIA;LEGIDO MARI脩O EVA MARIA;PEREZ BARCA JUAN CARLOS;GONZALEZ VILLAR TANIA. Datos registrales. T764 , F 176, S 8, H OR 2997, I/A 45 ( 3.09.18).

14 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 175, S 8, H OR 2997, I/A 43 ( 2.02.18).

Nombramientos. Apo.Manc.: LECOMPTE ALEXANDER. Datos registrales. T 764 , F 176, S 8, H OR 2997, I/A 44 ( 6.02.18).

03 de Marzo de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 175, S 8, H OR 2997, I/A 42 (22.02.17).

10 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: PADRON CONDE JUAN CARLOS;RODAS MEIRA NURIA;LEGIDO MARI脩O EVA MARIA;PEREZBARCA JUAN CARLOS;GONZALEZ VILLAR TANIA. Datos registrales. T 764 , F 175, S 8, H OR 2997, I/A 41 (30.01.17).

26 de Febrero de 2016
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 175, S 8, H OR 2997, I/A 40 (16.02.16).

25 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 174, S 8, H OR 2997, I/A 39 ( 6.03.15).

01 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: UNVI CARROCEROS SL. Nombramientos. Adm. Unico: UNVI CARROCEROS SL. Datosregistrales. T 764 , F 174, S 8, H OR 2997, I/A 38 (17.09.14).

14 de Marzo de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 174, S 8, H OR 2997, I/A 37 ( 3.03.14).

18 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 174, S 8, H OR 2997, I/A 36 ( 7.01.13).

09 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 173, S 8, H OR 2997, I/A 35 (23.12.11).

08 de Junio de 2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 173, S 8, H OR 2997, I/A 34 (16.05.11).

15 de Marzo de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 173, S 8, H OR 2997, I/A 33 ( 1.03.10).

19 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: GONZALEZ DONIZ RAMON FELIPE. Consejero: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Presidente:PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Consejero: PEREZ RUMBAO SA;SODIGA GALICIA SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGOSA. Nombramientos. Adm. Unico: UNVI CARROCEROS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Otros conceptos: Modificaci贸n de los art铆culos 12, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de losEstatutos Sociales como consecuencia del cambio de sistema de administraci贸n. Ampliacion del objeto social. La prestaci贸n detoda clase de servicios t茅cnicos, comerciales, de direcci贸n empresarial, de investigaci贸n y asesoramiento industrial, comercial,marketing y organizaci贸n en general. Datos registrales. T 764 , F 173, S 8, H OR 2997, I/A 32 ( 6.10.09).

29 de Abril de 2009
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 764 , F 172, S 8, H OR 2997, I/A 31 (15.04.09).

21 de Abril de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: OCAMPO SALGADO JUAN MANUEL;MARTINEZ COSTA JUAN MANUEL. Apoderado: ARMESTOVILANOVA JESUS;ARMESTO VILANOVA JESUS. Datos registrales. T 764 , F 172, S 8, H OR 2997, I/A 30 ( 8.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n