Actos BORME de Unify Communications Sa
27 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ATOS SPAIN SA. Representan: SANTOS CALDERON JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico:
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MITEL SPAIN SL. Datos registrales. T 44427 , F 190, S 8, H M415502, I/A 93 (22.10.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN TERESO DIAZ ANTONIO FRANCISCO. Apo.Sol.: APARICIO PRIETO FATIMA;LOPEZCRESPO RICARDO ESTEBAN;BEKAURI LELA;TORRES TORRES MARIA DEL PILAR. Apo.Manc.: TORRES TORRES MARIA DELPILAR. Apo.Man.Soli: VON PRABUCKI HURTADO CARLOS. Apoderado: VON PRABUCKI HURTADO CARLOS;RABESRODRIGUEZ MARTA;BEKAURI LELA. Apo.Sol.: GONZALEZ MOCHALES EVA MARIA. Datos registrales. T 44427 , F 190, S 8, H M415502, I/A 94 (22.10.23).
14 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: PITA BARROS FERNANDO;SANMARTIN BANOBRE JOSE ANTONIO;SANMARTIN BANOBRE JOSEANTONIO. Apo.Man.Soli: COBOS ALONSO SONIA. Apo.Sol.: GONZALEZ RODRIGUEZ BELEN. Apo.Man.Soli: GUISADO DEMONTIS JOSE LUIS. Apoderado: SANMARTIN BAÑOBRE JOSE ANTONIO;GOMARIZ SERRANO LAURA. Apo.Sol.: CARACENABENITO PILAR;AVILA JIMENEZ JAVIER;LAVANDEIRA HERMOSO ALVARO MARIA;RUIZ CANAL JAVIER. Apoderado: MONTEROCASTRO ESTELA. Datos registrales. T 44427 , F 189, S 8, H M 415502, I/A 91 ( 7.06.23).
29 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GARRIDO SALOME. Datos registrales. T 44427 , F 187, S 8, H M 415502, I/A 88(22.05.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GARRIDO SALOME. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GARRIDO SALOME. Datos registrales. T44427 , F 187, S 8, H M 415502, I/A 89 (22.05.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES LEON GEMA. Apo.Manc.: MORALES LEON GEMA. Datos registrales. T 44427 , F 189, S 8,H M 415502, I/A 90 (22.05.23).
19 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ MOCHALES EVA MARIA. Datos registrales. T 44427 , F 187, S 8, H M 415502, I/A 87(12.04.23).
13 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOZANO JESUS. Datos registrales. T 44427 , F 185, S 8, H M 415502, I/A 85 ( 6.03.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LOZANO JESUS. Datos registrales. T 44427 , F 187, S 8, H M 415502, I/A 86 ( 6.03.23).
21 de Febrero de 2023Reelecciones. Representan: SANTOS CALDERON JAVIER. Adm. Unico: ATOS SPAIN SA. Datos registrales. T 39933 , F 224, S 8,H M 415502, I/A 71 (14.02.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VON PRABUCKI HURTADO CARLOS. Datos registrales. T 39933 , F 224, S 8, H M 415502, I/A 72(14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: VON PRABUCKI HURTADO CARLOS. Datos registrales. T 44427 , F 180, S 8, H M 415502, I/A 73(14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: SEVILLANO MENDOZA MARIA EUGENIA. Datos registrales. T 44427 , F 180, S 8, H M 415502, I/A74 (14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: GIL PARIS MARCOS. Datos registrales. T 44427 , F 180, S 8, H M 415502, I/A 75 (14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: ARIZA CONEJERO CARLOS. Datos registrales. T 44427 , F 181, S 8, H M 415502, I/A 76 (14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: RABES RODRIGUEZ MARTA. Datos registrales. T 44427 , F 181, S 8, H M 415502, I/A 77(14.02.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARIAS CRUZ FEDERICO-CARLOS;CANTON POLINIO GREGORIO. Apo.Sol.: CANTON POLINIOGREGORIO. Datos registrales. T 44427 , F 182, S 8, H M 415502, I/A 78 (14.02.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORALES DEL SALTO ELENA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES DEL SALTO ELENA.Datos registrales. T 44427 , F 182, S 8, H M 415502, I/A 79 (14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: BEKAURI LELA. Datos registrales. T 44427 , F 182, S 8, H M 415502, I/A 80 (14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: CARABIAS FUENTES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 44427 , F 183, S 8, H M 415502, I/A 81(14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: CARABIAS FUENTES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 44427 , F 184, S 8, H M 415502, I/A 82(14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: MONTERO CASTRO ESTELA. Datos registrales. T 44427 , F 184, S 8, H M 415502, I/A 83(14.02.23).
Nombramientos. Apoderado: VILLALIBRE LOBATO JOSEFINA. Datos registrales. T 44427 , F 185, S 8, H M 415502, I/A 84(14.02.23).
03 de Junio de 2022Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: ATOS SPAIN SA. Datos registrales. T 39933 , F 224, S 8, H M415502, I/A 70 (27.05.22).
17 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: SUAREZ ANTONA CRISTINA. Datos registrales. T 39933 , F 221, S 8, H M 415502, I/A 67 ( 9.05.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOZANO RODRIGUEZ IVAN FEDERICO;LLANOS CID MONTSERRAT. Apo.Sol.: ALONSO MARTINCESAR MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ ANTONA CRISTINA. Apo.Manc.: SUAREZ ANTONA CRISTINA. Datosregistrales. T 39933 , F 221, S 8, H M 415502, I/A 68 ( 9.05.22).
Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES TORRES MARIA DEL PILAR. Apo.Manc.: TORRES TORRES MARIA DEL PILAR. Datosregistrales. T 39933 , F 222, S 8, H M 415502, I/A 69 ( 9.05.22).
04 de Mayo de 2022Cambio de domicilio social. C/ ALBARRACIN 25 (MADRID). Datos registrales. T 39933 , F 221, S 8, H M 415502, I/A 66(26.04.22).
13 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 39933 , F 220, S 8, H M 415502, I/A 65 ( 5.01.22).
17 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ CANAL JAVIER. Datos registrales. T 39933 , F 218, S 8, H M 415502, I/A 61 (10.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALONSO MARTIN CESAR MANUEL. Datos registrales. T 39933 , F 219, S 8, H M 415502, I/A 62(10.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: BEKAURI LELA. Datos registrales. T 39933 , F 219, S 8, H M 415502, I/A 63 (10.05.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES DEL SALTO ELENA. Datos registrales. T 39933 , F 220, S 8, H M 415502, I/A 64(10.05.21).
22 de Julio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: CANTON POLINIO GREGORIO;HITOS DE CARDENAS EDUARDO. Datos registrales. T 39933 , F 218,S 8, H M 415502, I/A 60 (15.07.20).
21 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: APARICIO PRIETO FATIMA;LOPEZ CRESPO RICARDO ESTEBAN;LAVANDEIRA HERMOSO ALVAROMARIA. Datos registrales. T 39933 , F 217, S 8, H M 415502, I/A 59 (15.02.20).
11 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: BELLO CASAIS SANTIAGO. Datos registrales. T 28713 , F 135, S 8, H M 415502, I/A 57 ( 2.12.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: AZORES DE FRANCISCO SUSANA;AVILA JIMENEZ JAVIER. Datos registrales. T 39933 , F 217, S 8,H M 415502, I/A 58 ( 2.12.19).
10 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: MATEOS LLEDO MANUEL. Datos registrales. T 28713 , F 135, S 8, H M 415502, I/A 56 ( 3.05.19).
24 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28713 , F 134, S 8, H M 415502, I/A 54 (17.12.18).
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 28713 , F 135, S 8, H M 415502, I/A 55 (17.12.18).
22 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: SANTOS CALDERON JAVIER;PAMPYN MARTINEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 28713 , F134, S 8, H M 415502, I/A 53 (15.06.18).
22 de Diciembre de 2017Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 28713 , F 134, S 8, H M 415502, I/A 52(15.12.17).
30 de Noviembre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28713 , F 133, S 8, H M 415502, I/A 51 (22.11.17).
04 de Julio de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARACENA BENITO PILAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOZANO RODRIGUEZ IVANFEDERICO;ARIAS CRUZ FEDERICO-CARLOS;MARTIN TERESO DIAZ ANTONIO FRANCISCO;CANTON POLINIOGREGORIO;HITOS DE CARDENAS EDUARDO;LLANOS CID MONTSERRAT. Datos registrales. T 28713 , F 132, S 8, H M 415502,I/A 50 (27.06.17).
05 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SANTOS CALDERON JAVIER;PAMPYN MARTINEZ JESUS-MARIA. Con.Delegado: SANTOSCALDERON JAVIER. Presidente: SANTOS CALDERON JAVIER. Consejero: CONNELL TREVOR;VEIT THOMAS. Secretario:CARACENA BENITO PILAR. Nombramientos. Adm. Unico: ATOS SPAIN SA. Representan: SANTOS CALDERON JAVIER.Modificaciones estatutarias. Quedan modificados los artículos 18, 19 y 20 de los estatutos sociales. . Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 28713 , F 130, S 8, H M415502, I/A 49 (28.12.16).
28 de Junio de 2016Cambio de domicilio social. PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS 2 (MADRID). Datos registrales. T 28713 , F 130, S 8, H M415502, I/A 48 (20.06.16).
07 de Junio de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28713 , F 130, S 8, H M 415502, I/A 47 (27.05.16).
10 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: OCAÑA GOMEZ LUIS. Datos registrales. T 28713 , F 130, S 8, H M 415502, I/A 46 ( 3.02.16).
08 de Septiembre de 2015Nombramientos. Consejero: VEIT THOMAS. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28713 , F 129, S 8, H M415502, I/A 45 ( 1.09.15).
16 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA RODRIGUEZ RAUL. Apo.Sol.: GARCIA RODRIGUEZ RAUL. Datos registrales. T 28713 , F127, S 8, H M 415502, I/A 43 ( 6.02.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS CALDERON JAVIER;PAMPYN MARTINEZ JESUS MARIA;NICOLAS AGUADOPEDRO;CARACENA BENITO PILAR;GARCIA RODRIGUEZ RAUL;GIL PRADO MAR. Datos registrales. T 28713 , F 129, S 8, H M415502, I/A 44 ( 6.02.15).
06 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: GIL PRADO MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 28713 , F 126, S 8, H M 415502, I/A 42(29.07.14).
17 de Junio de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN BAÑOBRE JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28713 , F 125, S 8, H M 415502, I/A39 (10.06.14).
Nombramientos. Apoderado: GOMARIZ SERRANO LAURA. Datos registrales. T 28713 , F 125, S 8, H M 415502, I/A 40(10.06.14).
Revocaciones. Consejero: SANMARTIN BAÑOBRE JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28713 , F 126, S 8, H M 415502, I/A 41(10.06.14).
06 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: GORDON LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 28713 , F 124, S 8, H M 415502, I/A 37(22.04.14).
Nombramientos. Apoderado: SANMARTIN BAÑOBRE JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28713 , F 125, S 8, H M 415502, I/A38 (22.04.14).