Actos BORME de Union Compras Almacenistas De Ferreteria Aie
02 de Enero de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.404,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.020,00 Euros. Datos registrales. T 3137 , F 90, S8, H MU 89915, I/A 4 (23.12.22).
26 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: LUIS MENGUAL DIGON. Secretario: LUIS MENGUAL DIGON. Nombramientos. Consejero:CARLOS MENGUAL DIGON. Secretario: CARLOS MENGUAL DIGON. Datos registrales. T 3137 , F 90, S 8, H MU 89915, I/A 3(19.08.22).
16 de Noviembre de 2015Cambio de domicilio social. CTRA DE VILLENA Km 1,5 (YECLA). Datos registrales. T 3137 , F 90, S 8, H MU 89915, I/A 2 (5.11.15).
02 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: VEGA GUTIERREZ JACINTO. Presidente: VEGA GUTIERREZ JACINTO. Consejero: REDONDOPEREZ MIGUEL ANGEL. Secretario: REDONDO PEREZ MIGUEL ANGEL. Consejero: MENGUAL DIGON LUIS. Con.Delegado:VEGA GUTIERREZ JACINTO. Nombramientos. Consejero: VERDU CAMARASA JOAQUIN;MENGUAL DIGON LUIS;SANCHEZMARTINEZ JOSE LUIS. Presidente: VERDU CAMARASA JOAQUIN. Secretario: MENGUAL DIGON LUIS. Con.Delegado: VERDUCAMARASA JOAQUIN. Tesorero: SANCHEZ MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4124, L 3035, F 219, S 8, H MA 32413,I/A 13 (24.06.15).
11 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: PRIEGO SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 4124, L 3035, F 218, S 8, H MA 32413, I/A 12(28.03.11).
28 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DIEZ MEDRANO JOSE MIGUEL. Vicepresid.: DIEZ MEDRANO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T4124, L 3035, F 218, S 8, H MA 32413, I/A 11 (16.02.11).