Actos BORME de Union Sanyres Sl
21 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: BARCELO MAZARRON LUIS;VALCANERAS DE RODA IGNACIO;MORENO AYMI ENRIQUE;SERRANOBARRIO FERNANDO. Apo.Manc.: NAUDE HURTADO SUSANA;SERRANO BARRIO FERNANDO. Apo.Sol.: DUO DELGADO JOSELUIS;DOMINGUEZ SANTA MARIA FABIAN;ORTEGA COBO LUIS ANTONIO;CANTERO FRESNEDA CRISTINA;VICARIO LA CALLEALFONSO MARIA. Datos registrales. T 35983 , F 49, S 8, H M 646528, I/A 10 (14.04.23).
17 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MESNARD SEBASTIEN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE;CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE.Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. VsecrNoConsj: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Vsecr2.NC: VINTANEL CORZANLAURA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MESNARD SEBASTIAN. Nombramientos. Consejero: GUILLOT LAURENT;GIACCARDOBERENGERE;LEMAIRE LAURENT. Presidente: GUILLOT LAURENT. VsecrNoConsj: VICARIO LA CALLE ALFONSO MARIA.Apoderado: GUILLOT LAURENT;GIACCARDO BERENGERE;LEMAIRE LAURENT;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOSASUNCION;AZNAR AZNAR MANUEL;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION;GUILLOT LAURENT. Datos registrales. T 35983 , F 47, S8, H M 646528, I/A 9 (10.01.23).
06 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: LE MASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Nombramientos. Consejero: CHARRIERPHILIPPE JEAN PIERRE. Presidente: CHARRIER PHILIPPE JEAN PIERRE. Datos registrales. T 35983 , F 47, S 8, H M 646528, I/A
13 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35983 , F 46, S 8, H M 646528, I/A 7 ( 2.12.21).
29 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: BRDENK JEAN CLAUDE. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE. Datos registrales. T 35983 , F 46, S 8,H M 646528, I/A 6 (22.06.21).
12 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ORPEA IBERICA SA;BRDENK JEAN CLAUDE. Nombramientos. Consejero: MESNARDSEBASTIEN;BATTESTI LOIC DOMINIQUE. Datos registrales. T 35983 , F 46, S 8, H M 646528, I/A 5 ( 5.03.21).
24 de Enero de 2020Cambio de domicilio social. PASEO DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 46, 7陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 35983 ,F 46, S 8, H M 646528, I/A 4 (17.01.20).
16 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35983 , F 45, S 8, H M 646528, I/A 3 ( 8.11.18).
09 de Junio de 2017Cambio de domicilio social. C/ MIGUEL ANGEL 23 6陋 (MADRID). Datos registrales. T 35983 , F 45, S 8, H M 646528, I/A 2 (1.06.17).
05 de Abril de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 70.605.135,08 Euros. Resultante Suscrito: 53.776.212,20 Euros. Datos registrales. T2483 , F 58, S 8, H CO 26951, I/A 42 (29.03.17).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ORPEA IBERICA SA. Datos registrales. T 2483 , F 58, S 8, H CO 26951, I/A 41(29.03.17).
04 de Abril de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: BRDENK JEAN CLAUDE;MESNARD SEBASTIAN. Datos registrales. T 2483 , F 56, S 8, H CO26951, I/A 40 (28.03.17).
27 de Marzo de 2017Nombramientos. Vsecr2.NC: VINTANEL CORZAN LAURA. Datos registrales. T 2483 , F 56, S 8, H CO 26951, I/A 39 (20.03.17).
13 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ ALVAREZ IGNACIO JOSE. Apo.Man.Soli: BERRA UNAMUNO RAMON. Datos registrales. T2483 , F 55, S 8, H CO 26951, I/A 38 ( 6.02.17).
27 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: AZNAR AZNAR MANUEL;BRDENK JEAN CLAUDE;ZARAGOZA LLIRINOS ASUNCION. Datosregistrales. T 2483 , F 53, S 8, H CO 26951, I/A 37 (19.10.16).
30 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Secretario: COTTA MARTINEZ AZAGRA CRISTOBAL. Vicesecret.: JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER.Consejero: GRUPO PRA SA;CATALUNYACAIXA CAPITAL SA;GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA;INVERCARTERAINTERNACIONAL SL;COLUMBA 2010 SL;PRASA ANDALUCIA OCCIDENTAL SL. Cons.Del.Man: PRASA ANDALUCIAOCCIDENTAL SL;COLUMBA 2010 SL;INVERCARTERA INTERNACIONAL SL;GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA;GRUPO PRASA;CATALUNYACAIXA CAPITAL SA. Presidente: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Vicepresid.: CATALUNYACAIXA CAPITALSA. Nombramientos. Consejero: LE MASNE YVES. Presidente: LE MASNE YVES. Consejero: ORPEA IBERICA SA;BRDENK JEANCLAUDE. SecreNoConsj: SOLCHAGA LOPEZ SILANES FRANCISCO. VsecrNoConsj: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datosregistrales. T 2483 , F 52, S 8, H CO 26951, I/A 36 (22.09.16).
04 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Secretario: JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Vicesecret.: GARCIA VENA ANGELA PRISCA.Nombramientos. Secretario: COTTA MARTINEZ AZAGRA CRISTOBAL. Vicesecret.: JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 2483 , F 51, S 8, H CO 26951, I/A 35 (28.07.16).
27 de Octubre de 2015Fe de erratas: En el borme 197/2015 se public贸 err贸neamente la denominaci贸n de las sociedades que han fueron absorbidas porUNION SANYRES SL, siendo la denominaci贸n de las mismas PROMAR 21 SL, CENTROS RESIDENCIALES SANYRES SUR SL yALZAMBRA SANYRES SL. Datos registrales. T 2077 , F 18, S 8, H CO 26951, I/A 34 ( 8.10.15).
15 de Octubre de 2015Cambio de objeto social. 1.- La urbanizaci贸n, parcelaci贸n, construcci贸n, promoci贸n, rehabilitaci贸n por cuenta propia o ajena de todotipo de inmuebles. 2.- Promoci贸n y gesti贸n de toda clase de centros destinados a cualquier sector social y sociosanitario y, enparticular, a la tercera edad, tales como residencias, centros d. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SANIDAD YRESIDENCIAS 21 SA. PROMAR 21 SL. SANYRES SUR SL. CENTROS RESIDENCIALES SANYRES SUR SL. ALZAMBRASANYRES SL. Datos registrales. T 2077 , F 18, S 8, H CO 26951, I/A 34 ( 8.10.15).
16 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2077 , F 17, S 8, H CO 26951, I/A 32 ( 9.12.14).
13 de Noviembre de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 914.568,73 Euros. Resultante Suscrito: 124.381.347,28 Euros. Modificacionesestatutarias. 3. Domicilio.-. 18. Funcionamiento Junta Gral.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.sanyres.es. Datos registrales. T 2077 , F 16, S 8, H CO 26951, I/A 31 ( 6.11.14).
22 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Presidente: CATALUNYACAIXA CAPITAL SA. Vicepresid.: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA.Nombramientos. Presidente: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Vicepresid.: CATALUNYACAIXA CAPITAL SA. Datosregistrales. T 2077 , F 16, S 8, H CO 26951, I/A 29 (15.01.14).
06 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERRA UNAMUNO RAMON. Apo.Manc.: SANCHEZ ALVAREZ IGNACIO. Datos registrales. T2077 , F 13, S 8, H CO 26951, I/A 25 (26.07.12).
28 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Vicepresid.: CATALUNYACAIXA CAPITAL SA.Nombramientos. Presidente: CATALUNYACAIXA CAPITAL SA. Vicepresid.: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA. Datosregistrales. T 2077 , F 13, S 8, H CO 26951, I/A 24 (16.03.12).
21 de Diciembre de 2011Modificaciones estatutarias. 16. Funcionamiento Junta Gral.-. 18. Funcionamiento JuntaGral.-. 19. Funcionamiento Junta Gral.-. 24.Otros.-. Datos registrales. T 2077 , F 11, S 8, H CO 26951, I/A 22 (12.12.11).
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: GRUPO PRA SA;CATALUNYACAIXA CAPITAL SA;GRUPO DE EMPRESAS CAJASURSA;INVERCARTERA INTERNACIONAL SL;COLUMBA 2010 SL;PRASA ANDALUCIA OCCIDENTAL SL. Revocaciones. Apoderado:ROMERO REINA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2077 , F 13, S 8, H CO 26951, I/A 23 (12.12.11).
20 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2077 , F 11, S 8, H CO 26951, I/A 21 ( 9.09.11).
24 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: AVENTIN BARRAU JOSE MANUEL. Co.De.Ma.So: AVENTIN BARRAU JOSE MANUEL.Nombramientos. Consejero: COLUMBA 2010 SL. Co.De.Ma.So: COLUMBA 2010 SL. Datos registrales. T 2070 , F 71, S 8, H CO26951, I/A 19 (13.05.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS. Co.De.Ma.So: ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS.Nombramientos. Consejero: PRASA ANDALUCIA OCCIDENTAL SL. Co.De.Ma.So: PRASA ANDALUCIA OCCIDENTAL SL. Datosregistrales. T 2070 , F 72, S 8, H CO 26951, I/A 20 (13.05.11).
25 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: GRUPO PRA SA. Vicepresid.: INVERCARTERA SA. Nombramientos. Presidente: GRUPO DEEMPRESAS CAJASUR SA. Vicepresid.: INVERCARTERA SA. Cambio de domicilio social. C/ CRONISTA REY DIAZ 2(CORDOBA). Datos registrales. T 2070 , F 70, S 8, H CO 26951, I/A 18 (17.02.11).
14 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.999.999,84 Euros. Resultante Suscrito: 82.694.309,70 Euros. Modificaciones estatutarias. 7.Otros.-. 8. Otros.-. 9. Otros.-. 16. Funcionamiento Junta Gral.-. 18. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 2070 , F 69, S 8,H CO 26951, I/A 16 ( 3.02.11).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 42.601.606,31 Euros. Resultante Suscrito: 125.295.916,01 Euros. Datos registrales. T 2070 , F 69,S 8, H CO 26951, I/A 17 ( 3.02.11).
30 de Septiembre de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30.669.646,14 Euros. Resultante Suscrito: 66.694.309,86 Euros. Datos registrales. T2070 , F 68, S 8, H CO 26951, I/A 13 (21.09.10).
07 de Junio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: CONCHA JARAVA FERNANDO VICENTE. Datos registrales. T 2070 , F 67, S 8, H CO 26951, I/A 12(21.05.10).
01 de Junio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: ROMERO REINA FRANCISCO JAVIER;PRIETO MAHEDERO ANTONIO. Nombramientos. Apoderado:ROMERO REINA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2070 , F 67, S 8, H CO 26951, I/A 12 (21.05.10).
09 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: TRIGO AIZPURU MIGUEL ANGEL. Co.De.Ma.So: TRIGO AIZPURU MIGUEL ANGEL.Nombramientos. Consejero: AVENTIN BARRAU JOSE MANUEL. Co.De.Ma.So: AVENTIN BARRAU JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 2040 , F 19, S 8, H CO 26951, I/A 11 (26.02.10).
22 de Junio de 2009Fe de erratas: El Consejero Delegado tiene facultades mancomunadas y solidarias. Datos registrales. T 2040 , F 9, S 8, H CO26951, I/A 2 (17.12.07).
Ceses/Dimisiones. Consejero: PROMOTORA CATALUNYA MEDITERRANEA SA. Vicepresid.: PROMOTORA CATALUNYAMEDITERRANEA SA. Cons.Del.Man: PROMOTORA CATALUNYA MEDITERRANEA SA. Nombramientos. Consejero:INVERCARTERA INTERNACIONAL SL. Vicepresid.: INVERCARTERA SA. Co.De.Ma.So: INVERCARTERA INTERNACIONAL SL.Datos registrales. T 2040 , F 17, S 8, H CO 26951, I/A 9 (11.06.09).