Buscador CIF Logo

Actos BORME Uniplay Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Uniplay Sa

Actos BORME Uniplay Sa - A64228034

Tenemos registrados 72 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Uniplay Sa con CIF A64228034

馃敊 Perfil de Uniplay Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Uniplay Sa

19 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: COTS MIR LAURA;SALGUERO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 44215 , F 20,S 8, H M 464087, I/A 112 (12.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALGUERO CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 44215 , F 20, S 8, H M464087, I/A 113 (12.12.23).

29 de Noviembre de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: COTECNIC 2000 SL. GARRIDO PLAYER SL. Datos registrales. T 44215 , F 17, S8, H M 464087, I/A 111 (22.11.23).

03 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: SANJUAN ALTIMIRA MOISES;SANJUAN ALTIMIRA MOISES;MOLINA LAO MANUEL. Datosregistrales. T 39684 , F 97, S 8, H M 464087, I/A 110 (26.10.22).

08 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: MERINO LONGUE CARLOS. Datos registrales. T 39684 , F 97, S 8, H M 464087, I/A 109 ( 3.07.22).

07 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: PARA ANDRADE ANTONIO. Datos registrales. T 39684 , F 96, S 8, H M 464087, I/A 108 (30.06.22).

06 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: ESTANY ESPINALT MANUEL MATEO. Datos registrales. T 39684 , F 95, S 8, H M 464087, I/A 107(30.05.22).

30 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: GARCIA-BORREGON MILLAN AMADEO JOSE. Datos registrales. T 39684 , F 95, S 8, H M 464087,I/A 106 (23.03.22).

26 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 39684 , F 95, S 8, HM 464087, I/A 105 (19.01.22).

23 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: HEREDIA GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 39684 , F 94, S 8, H M 464087, I/A 104(16.12.21).

22 de Diciembre de 2021
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: REDEYE GAMES SL. FIRST GAME SL. Datos registrales. T 39684 , F 87, S 8, H M464087, I/A 103 (15.12.21).

25 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ TARIN JESUS. Datos registrales. T 39684 , F 87, S 8, H M 464087, I/A 102 (18.10.21).

20 de Abril de 2021
Revocaciones. Apoderado: ROYO TRALLERO DAVID. Apo.Sol.: ROYO TRALLERO DAVID;COSCULLUELA VIDAL

01 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRAU FOLGUERA ANTONIO. Datos registrales. T 39684 , F 86, S 8, H M 464087, I/A 100(24.11.20).

20 de Julio de 2020
Reelecciones. Representan: LOPEZ REBOREDO CARLOS. Adm. Unico: CIRSA SLOT CORPORATION SL. Datos registrales. T39684 , F 86, S 8, H M 464087, I/A 99 (13.07.20).

25 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: MARTIN ALCALA SERGIO;GARCIA FERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 39684 , F 86, S 8, HM 464087, I/A 98 (18.06.20).

03 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARTIN ALCALA SERGIO. Datos registrales. T 39684 , F 85, S 8, H M 464087, I/A 97 (25.02.20).

19 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: TURULL PICARDO JUAN ANTONIO;BARRESI VINCENZO. Datos registrales. T 39684 , F 85, S 8, H M464087, I/A 96 (12.02.20).

11 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: VARGAS DEL CASTILLO MARIANO-LORENZO. Datos registrales. T 30557 , F 34, S 8, H M 464087,I/A 95 ( 6.10.19).

08 de Agosto de 2019
Revocaciones. Apoderado: ROYO TRALLERO DAVID;BALAGUE RIBALTA JOAN RAMON;BUERA RIBERA GERARD;ABELLANPEREZ CARLOS;ALONSO CHILLON FRANCISCO;VARGAS DEL CASTILLO MARIANO-LORENZO;MARTIN ALCALASERGIO;NOVAS MORENO MONTSERRAT. Apo.Sol.: PEREZ CHESA MARIA ROSER;GRAU MIRO ANNA;VILLUENDAS MESTRESANTIAGO GUILLERMO;FUENTES BARRANCO EMILIO;RODRIGUEZ ROSALES JOSE MIGUEL. Apoderado: OSORIO SALGADOJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30557 , F 34, S 8, H M 464087, I/A 94 ( 1.08.19).

05 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apoderado: GARCIA FERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 30557 , F 33, S 8, H M 464087, I/A 93(29.07.19).

25 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: SANJUAN ALTIMIRA MOISES. Datos registrales. T 30557 , F 33, S 8, H M 464087, I/A 92 (18.06.19).

14 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: BARBERAN DOMENECH JUAN;SISTACH MANEN MARC. Datos registrales. T 30557 , F 32, S 8, HM 464087, I/A 91 ( 7.03.19).

18 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 30557 , F 32, S 8, HM 464087, I/A 90 (10.01.19).

12 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: ARCE YARRITU ANDER. Datos registrales. T 30557 , F 31, S 8, H M 464087, I/A 88 ( 4.12.18).

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ BERTOLI CARLOS;BARBA LEON JUAN. Datos registrales. T 30557 , F 32, S 8, H M464087, I/A 89 ( 4.12.18).

22 de Noviembre de 2018
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 15 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 30557 , F 31, S 8, H M464087, I/A 87 (15.11.18).

18 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: LAO GORINA MANUEL. Datos registrales. T 30557 , F 31, S 8, H M 464087, I/A 86 (11.09.18).

17 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: GARCIA-BORREGON MILLAN AMADEO JOSE. Datos registrales. T 30557 , F 30, S 8, H M 464087,I/A 84 ( 8.05.18).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN ALCALA SERGIO. Datos registrales. T 30557 , F 30, S 8, H M 464087, I/A 85 ( 8.05.18).

08 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ BAZAN RAMIRO. Datos registrales. T 30557 , F 30, S 8, H M 464087, I/A 83 (26.04.18).

03 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: OSORIO SALGADO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30557 , F 29, S 8, H M 464087, I/A 82(20.04.18).

23 de Abril de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: CASTILLO URDIAIN ANDRES;VILLUENDAS MESTRE SANTIAGO GUILLERMO;FUENTES BARRANCOEMILIO;RODRIGUEZ ROSALES JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 30557 , F 29, S 8, H M 464087, I/A 81 (16.04.18).

29 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 30557 , F 28, S 8, HM 464087, I/A 80 (18.01.18).

25 de Enero de 2018
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GONMATIC SL. ELECTRONICOS TRUJILLANOS SL. Datos registrales. T 30557 ,F 24, S 8, H M 464087, I/A 79 (16.01.18).

14 de Agosto de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: ROYO TRALLERO DAVID;MAS RIBO RICARD;BALAGUE RIBALTA JOAN RAMON;BUERA RIBERAGERARD;ABELLAN PEREZ CARLOS;COSCULLUELA VIDAL MARIA;PEREZ CHESA MARIA ROSER;FABREGAS LUELMOENRIC;SALA COSTA-JUSSA CARLOTA;COTS VEGA FRANCISCO JAVIER;SALMERON DAVI MERCE;CRUZ SERRA LIDIA;GOMEZGONZALEZ JORGE;VIZCAINO PRAT MIGUEL;MARCOS MU脩OZ CARMEN;BARCELO OBREGON FRANCISCO JAVIER;VINTROFORTUNY JOAN;GRAU MIRO ANNA;ESCALERA HERNANDEZ SUSANA. Datos registrales. T 30557 , F 23, S 8, H M 464087, I/A78 ( 3.08.17).

28 de Junio de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CIRSA SLOT CORPORATION SA. Datos registrales. T 30557 , F23, S 8, H M 464087, I/A 77 (20.06.17).

15 de Febrero de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ CORNEJO PEREZ JORGE;ERNESTO ARAUJO ANTONIO;MORALES MESTREARMANDO;DEL VALLE VILLALBA FELIPE BENITO. Apoderado: RODRIGUEZ TARIN JESUS;ALONSO CHILLONFRANCISCO;SANCHEZ BERTOLI CARLOS;BUENO BARRIO ANGEL-AMADO;ARCE YARRITU ANDER;MARTINEZ SANCHEZMANUEL;VARGAS DEL CASTILLO MARIANO-LORENZO;NARVAEZ THOMAS ALFREDO. Datos registrales. T 30557 , F 22, S 8, HM 464087, I/A 75 ( 7.02.17).

Nombramientos. Apoderado: ROYO TRALLERO DAVID;MAS RIBO RICARD;BUERA RIBERA GERARD;NOVAS MORENOMONTSERRAT;ABELLAN PEREZ CARLOS. Datos registrales. T 30557 , F 23, S 8, H M 464087, I/A 76 ( 7.02.17).

24 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 30557 , F 22, S 8, HM 464087, I/A 74 (17.01.17).

23 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: ORDAX BELDA ENRIQUE. Datos registrales. T 30557 , F 21, S 8, H M 464087, I/A 73 (13.01.17).

28 de Julio de 2016
Cambio de objeto social. LA EXPLOTACION EN REGIMEN DE EMPRESA OPERADORA DE TODO TIPO DE MAQUINASRECREATIVAS O DE TIPO A Y MAQUINAS RECREATIVAS CON PREMIO PROGRAMADO O DE TIPO B, EN LOCALES OESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS, PROPIOS O AJENOS (CNAE:9200). LA EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS DEHOSTELERIA DONDE PUEDAN SER INSTALA. Datos registrales. T 30557 , F 21, S 8, H M 464087, I/A 72 (19.07.16).

13 de Julio de 2016
Nombramientos. Apoderado: BARBA LEON JUAN. Datos registrales. T 30557 , F 20, S 8, H M 464087, I/A 70 ( 6.07.16).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN ALCALA SERGIO. Datos registrales. T 30557 , F 20, S 8, H M 464087, I/A 71 ( 6.07.16).

27 de Junio de 2016
Nombramientos. Apoderado: PEREZ BRIZ RAFAEL. Datos registrales. T 30557 , F 19, S 8, H M 464087, I/A 67 (17.06.16).

Nombramientos. Apoderado: SY TOURE ROKHAYA. Datos registrales. T 30557 , F 19, S 8, H M 464087, I/A 68 (17.06.16).

Nombramientos. Apoderado: DE VALLE VILLALBA FELIPE BENITO. Datos registrales. T 30557 , F 20, S 8, H M 464087, I/A 69(17.06.16).

03 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: ALONSO CHILLON FRANCISCO. Datos registrales. T 30557 , F 14, S 8, H M 464087, I/A 59(22.04.16).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ TARIN JESUS. Datos registrales. T 30557 , F 14, S 8, H M 464087, I/A 60 (22.04.16).

Nombramientos. Apoderado: NARVAEZ THOMAS ALFREDO. Datos registrales. T 30557 , F 15, S 8, H M 464087, I/A 61

Nombramientos. Apoderado: ARCE YARRITU ANDER. Datos registrales. T 30557 , F 16, S 8, H M 464087, I/A 62 (22.04.16).

Nombramientos. Apoderado: BUENO BARRIO ANGEL-AMADO. Datos registrales. T 30557 , F 16, S 8, H M 464087, I/A 63(22.04.16).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BERTOLI CARLOS. Datos registrales. T 30557 , F 17, S 8, H M 464087, I/A 64 (22.04.16).

Nombramientos. Apoderado: VARGAS DEL CASTILLO MARIANO-LORENZO. Datos registrales. T 30557 , F 17, S 8, H M 464087,I/A 65 (22.04.16).

Nombramientos. Apoderado: FRUCTUOSO ALCADE GAMARRA CARLOS. Datos registrales. T 30557 , F 18, S 8, H M 464087, I/A66 (22.04.16).

26 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ BAZAN RAMIRO. Datos registrales. T 30557 , F 13, S 8, H M 464087, I/A 58 (17.02.16).

08 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apoderado: BALAGUE RIBALTA JOAN RAMON;BUERA RIBERA GERARD;ROYO TRALLERO DAVID;ABELLANPEREZ CARLOS;ALONSO CHILLON FRANCISCO;BUENO BARRIO ANGEL-AMADO;RODRIGUEZ TARIN JESUS;BARBA LEONJUAN;SANCHEZ BERTOLI CARLOS;ALONSO CHILLON FRANCISCO;DUELO RIU CARLOSApo.Sol.: LEAL GARCIA JUANMANUEL. Apoderado: MARTIN MORA MORCILLO ALBERTO;ALONSO CHILLON FRANCISCO;SANCHEZ BERTOLICARLOS;RODRIGUEZ TARIN JESUS;GARCES NADAL ALBERTO JOSE;BUENO BARRIO ANGEL-AMADO;PALAU VERDEJOALEJANDRO;ARCE YARRITU ANDER;MARTINEZ SANCHEZ MANUEL RUPERTO;GARCIA FERNANDEZ CARLOS. Datosregistrales. T 30557 , F 12, S 8, H M 464087, I/A 57 ( 1.02.16).

27 de Enero de 2016
Reelecciones. Auditor: CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 30557 , F 12, S 8, HM 464087, I/A 56 (18.01.16).

02 de Julio de 2015
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ BAZAN RAMIRO;RODRIGUEZ MENDEZ JOSE MARIA;MARTINEZ PEREZFRANCISCO;MU脩OZ VEGA FRANCISCO;FERNANDEZ-ROBLES DE BENITO JULIO ANTONIO;MARTINEZ OLMOS JESUSANTONIO. Datos registrales. T 30557 , F 8, S 8, H M 464087, I/A 47 (17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ TARIN JESUS. Datos registrales. T 30557 , F 8, S 8, H M 464087, I/A 48 (17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: ALONSO CHILLON FRANCISCO. Datos registrales. T 30557 , F 8, S 8, H M 464087, I/A 49(17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BERTOLI CARLOS. Datos registrales. T 30557 , F 9, S 8, H M 464087, I/A 50 (17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: BUENO BARRIO ANGEL-AMADO. Datos registrales. T 30557 , F 9, S 8, H M 464087, I/A 51(17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: ARCE YARRITU ANDER. Datos registrales. T 30557 , F 10, S 8, H M 464087, I/A 52 (17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SANCHEZ MANUEL. Datos registrales. T 30557 , F 11, S 8, H M 464087, I/A 53(17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: VARGAS DEL CASTILLO MARIANO-LORENZO. Datos registrales. T 30557 , F 11, S 8, H M 464087,I/A 54 (17.06.15).

Nombramientos. Apoderado: NARVAEZ THOMAS ALFREDO. Datos registrales. T 30557 , F 12, S 8, H M 464087, I/A 55(17.06.15).

22 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: DUELO RIU CARLOS. Nombramientos. Representan: LOPEZ REBOREDO CARLOS. Datosregistrales. T 30557 , F 7, S 8, H M 464087, I/A 46 (14.04.15).

24 de Febrero de 2015
Reelecciones. Auditor: CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 30557 , F 7, S 8, H M464087, I/A 45 (12.02.15).

05 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: ROYO TRALLERO DAVID;BALAGUE RIBALTA JOAN RAMON;BUERA RIBERA GERARD;ABELLANPEREZ CARLOS. Datos registrales. T 30557 , F 6, S 8, H M 464087, I/A 44 (29.01.15).

09 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CIRSA SLOT CORPORATION SL. Representan: ALCALA TOMAS PABLO. Disoluci贸n. Fusion.Extinci贸n. Datos registrales. T 20821 , F 210, S 8, H M 24381, I/A 126 (28.01.09).

05 de Febrero de 2009
Reelecciones. Auditor: CORTES PEREZ Y COMPA脩IA AUDITORES SL. Datos registrales. T 20821 , F 210, S 8, H M 24381, I/A125 (23.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n