Actos BORME de Unistral Recambios Sa
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: LAURA ROCA FARGAS;DUNIA LLORENS SALAMO. Datos registrales. T 3386 , F 37, S 8, H GI 32412,I/A 47 (26.07.23).
20 de Abril de 2023Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL.Datos registrales. T 3386 , F 36, S 8, H GI 32412, I/A 46 (14.04.23).
14 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE MARIA PIERA LIRIA. Nombramientos. Consejero: MARTIN GIRALT ADROHER. Datosregistrales. T 3386 , F 36, S 8, H GI 32412, I/A 45 ( 6.04.23).
03 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS. Apo.Sol.: JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS. Datosregistrales. T 3386 , F 36, S 8, H GI 32412, I/A 44 (30.01.23).
01 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROSA MASIP BOIL. Datos registrales. T 3386 , F 36, S 8, H GI 32412, I/A 43 (25.01.23).
05 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: JORGE MARTIN ROIG. Nombramientos. Cons.Del.Man: JORGE MARTIN ROIG.Reelecciones. Consejero: JORGE MARTIN ROIG. Datos registrales. T 3386 , F 36, S 8, H GI 32412, I/A 42 (28.07.22).
31 de Mayo de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: SILVIA CABRERIZO TRAVIESO;JUAN JOSE MASOLIVER MORENO DE LA VEGA. Datosregistrales. T 2784 , F 195, S 8, H GI 32412, I/A 41 (24.05.22).
09 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN FORT VIADER. Nombramientos. Consejero: JOSE MARIA PIERA LIRIA. Datos registrales.T 2784 , F 195, S 8, H GI 32412, I/A 40 ( 2.05.22).
23 de Febrero de 2022Modificaciones estatutarias. ARTICULO 6º.- REGIMEN DE TRANSMISION DE LAS ACCIONES Y DERECHOS.- 6.1 Serán libres
14 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ROSA MASIP BOIL;MIREIA RUEDA FERRANDO;JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS. Datosregistrales. T 2784 , F 194, S 8, H GI 32412, I/A 37 ( 8.07.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: ROSA MASIP BOIL;MIREIA RUEDA FERRANDO;JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS. Datos registrales.T 2784 , F 195, S 8, H GI 32412, I/A 38 ( 8.07.21).
15 de Febrero de 2021Otros conceptos: Según Oficio de fecha 21/07/2020, expedido por el R. M. de Barcelona, se ha constituido el depósito de lasCuentas Consolidadas, ejercicio 2019, con el número 40022258, de fecha 15/07/2020, siendo la Sociedad dominante "FLUIDRA SA".Datos registrales. T 2784 , F 194, S 8, H GI 32412, I/A NM2 ( 8.02.21).
22 de Enero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIRIAM SANCHEZ TERUEL. Datos registrales. T 2784 , F 194, S 8, H GI 32412, I/A 36 (18.01.21).
09 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: ROSA MASIP BOIL;MIREIA RUEDA FERRANDO;JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS. Datosregistrales. T 2784 , F 194, S 8, H GI 32412, I/A 34 ( 2.10.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS;ROSA MASIP BOIL;MIGUEL PALAU CRUIXENT. Datos registrales.T 2784 , F 194, S 8, H GI 32412, I/A 35 ( 2.10.20).
28 de Enero de 2020Otros conceptos: Según Oficio de fecha 14/06/2019, expedido por el R. M. de Barcelona, se comunica que en relación a la Sociedadde esta hoja, se ha constituido el depósito de las Cuentas Consolidadas, ejercicio 2018, con el número 39022321, de fecha11/06/2019, siendo la Sociedad dominante "FLUIDRA SA". Datos registrales. T 2784 , F 194, S 8, H GI 32412, I/A NM1 (21.01.20).
14 de Enero de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: FLUIDRA COMMERCIAL SA. Datos registrales. T 2784 , F 194, S8, H GI 32412, I/A 33 ( 3.01.20).
21 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: MARIA TERESA BARLUENGA GONZALEZ DEL VALLE. Nombramientos. Gerente: MARIA TERESABARLUENGA GONZALEZ DEL VALLE. Datos registrales. T 2784 , F 193, S 8, H GI 32412, I/A 31 (13.08.19).
Revocaciones. Apoderado: JAVIER TINTORE SEGURA. Datos registrales. T 2784 , F 193, S 8, H GI 32412, I/A 32 (13.08.19).
18 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: JAUME CAROL PAÑACH. Presidente: JAUME CAROL PAÑACH. Cons.Del.Man: JAUME CAROLPAÑACH. Nombramientos. Consejero: CARLOS FRANQUESA CASTRILLO. Presidente: CARLOS FRANQUESA CASTRILLO.Cons.Del.Man: CARLOS FRANQUESA CASTRILLO. Datos registrales. T 2784 , F 193, S 8, H GI 32412, I/A 30 (10.06.19).
26 de Febrero de 2019Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2784 , F 193, S 8, H GI 32412, I/A 29 (19.02.19).
22 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: NARCIS FIGUERAS TRIOLA. Datos registrales. T 2784 , F 192, S 8, H GI 32412, I/A 28 (14.08.18).
26 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSE TURA ROF. Datos registrales. T 2784 , F 192, S 8, H GI 32412, I/A 26 (18.07.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUAN JOSE MASOLIVER MORENO DE LA VEGA. Datos registrales. T 2784 , F 192, S 8, H GI32412, I/A 27 (18.07.18).
13 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIRIAM SANCHEZ TERUEL;FRANCISCA BELTRAN RODRIGUEZ. Datos registrales. T 2784 , F192, S 8, H GI 32412, I/A 25 ( 5.06.18).
12 de Enero de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: SILVIA CABRERIZO TRAVIESO. Datos registrales. T 2784 , F 192, S 8, H GI 32412, I/A 24 (3.01.17).
14 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FLUIDRA INDUSTRY SA. Nombramientos. Presidente: JAUME CAROL PAÑACH. Consejero:JORGE MARTIN ROIG;JUAN FORT VIADER. Secretario: ANDRES BOTELLA ARIAS. Vicesecret.: MAXIMINO MONTERO LASTRES.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. T1926 , F 152, S 8, H GI 32412, I/A 22 ( 5.12.16).
Nombramientos. Cons.Del.Man: JAUME CAROL PAÑACH;JORGE MARTIN ROIG. Datos registrales. T 1926 , F 153, S 8, H GI32412, I/A 23 ( 5.12.16).
04 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS. Datos registrales. T 1926 , F 152, S 8, H GI 32412, I/A 21(25.02.15).
05 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE TURA ROF. Datos registrales. T 1926 , F 151, S 8, H GI 32412, I/A 19 (28.01.15).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOAN CARLES CIFRE VERICAT. Datos registrales. T 1926 , F 152, S 8, H GI 32412, I/A 20(28.01.15).
21 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: ESTHER CATEURA LLOPRAT. Datos registrales. T 1926 , F 151, S 8, H GI 32412, I/A 18 (11.10.13).
22 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: EDUARD TARRUELL FLORES;MARIA ASSUMPCIO ROCA FARNES;ANTONIO DE LUNAGARCIA;ANDRES BOTELLA ARIAS;JOAN CARLES CIFRE VERICAT. Datos registrales. T 1926 , F 150, S 8, H GI 32412, I/A 16(13.11.12).
Nombramientos. Apoderado: JAVIER TINTORE SEGURA. Datos registrales. T 1926 , F 151, S 8, H GI 32412, I/A 17 (13.11.12).
26 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: JOSEP MARIA BADIA BARTOMEUS;ROSA MASIP BOIL;MIGUEL PALAU CRUIXENT. Datosregistrales. T 1926 , F 150, S 8, H GI 32412, I/A 15 (15.06.12).
10 de Agosto de 2010Reelecciones. Adm. Unico: FLUIDRA INDUSTRY SA. Otros conceptos: Artículo 10. Plazo administrador 6 años. Datosregistrales. T 1926 , F 150, S 8, H GI 32412, I/A 14 (28.07.10).
18 de Junio de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: JAUME CAROL PAÑACH. Apod.D.Gral.: CARLOS FRANQUESA CASTRILLO. Datos registrales. T1926 , F 150, S 8, H GI 32412, I/A 13 ( 8.06.09).