Actos BORME de United Europhil Ep Sa
23 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: MILLAN CORTES MARIO ROBERTO;MILLAN CORTES MARIO ROBERTO. Datos registrales. T 25755 ,F 219, S 8, H M 81588, I/A 101 (16.06.23).
13 de Septiembre de 2022Nombramientos. Auditor: CAPITAL AUDITORS AND CONSULTANTS SL. Datos registrales. T 25755 , F 219, S 8, H M 81588, I/A100 ( 6.09.22).
15 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25755 , F 219, S 8, H M 81588, I/A 99 ( 7.10.21).
12 de Julio de 2021Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Cambio de objeto social. Asimismo, la Sociedad podr谩 realizar el serviciode cambio de divisas relacionado con servicios de pago de conformidad con lo establecido en el art铆culo 20.1 a) del Real Decreto Ley19/2018 de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Datos registrales. T 25755 , F218, S 8, H M 81588, I/A 98 ( 5.07.21).
22 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ LAYBAA LIDIA. Secretario: HERNANDEZ LAYBAA LIDIA. Nombramientos.Consejero: HERNANDEZ LAYBAA LIDIA. Secretario: HERNANDEZ LAYBAA LIDIA. Reelecciones. Consejero: MORENO DELGADOFRANCISCO. Con.Delegado: MORENO DELGADO FRANCISCO. Consejero: VILLALOBOS EDUARDO. Presidente: VILLALOBOSEDUARDO. Datos registrales. T 25755 , F 218, S 8, H M 81588, I/A 97 (15.09.20).
11 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MILLAN CORTES MARIO ROBERTO. Apo.Manc.: ESCUDERO DE LEON EDUARDO;GONZALEZ BAJOMIRIAM;CHAVERO TORRENOVA MARIA ELENA;FURIO ALTOZANO RICARDO. Datos registrales. T 25755 , F 217, S 8, H M81588, I/A 96 ( 4.03.20).
06 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: HAMMONDS BATES PATRICK. Secretario: HAMMONDS BATES PATRICK. Nombramientos.Consejero: HERNANDEZ LAYBAA LIDIA. Secretario: HERNANDEZ LAYBAA LIDIA. Datos registrales. T 25755 , F 217, S 8, H M81588, I/A 95 (30.08.19).
14 de Noviembre de 2018Modificaciones estatutarias. 24. Modificaci贸n de la politica de retribuci贸n del cargo. Datos registrales. T 25755 , F 217, S 8, H M81588, I/A 94 ( 6.11.18).
26 de Octubre de 2018Nombramientos. Auditor: RSM SPAIN AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25755 , F 216, S 8, H M 81588, I/A 93 (16.10.18).
19 de Septiembre de 2018Ampliacion del objeto social. El objeto de la Sociedad ser谩 la actividad de compra y venta de billetes extranjeros y cheques deviajeros contra entrega de su contravalor en euros o en otros billetes de banco extranjeros, la gesti贸n de transferencias con el exterioren concepto de gastos de estancia en el extranjero ... Datos registrales. T 25755 , F 216, S 8, H M 81588, I/A 92 (12.09.18).
31 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: GASSO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25755 , F 216, S 8, H M 81588, I/A 91 (22.12.15).
03 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: HERVAS SANCHEZ ISABEL;HERVAS CASTRO JOSE;HEREDIA RODRIGUEZ CARMEN;PEREZPEREZ SANTA VIRTUDES;FRICKE CRISTOBALINA ANGELA;MANUEL Y CATY COLON ASOCIADOS SL;GONZALEZ CUEVASGERARDO ANTONIO;CARVAJAL MEDINA ALDRIN NELSON;DE LA CRUZ ROSARIO ESPERANZA;SIMON NYRA;DIAZLIBARDO;BALLON ORO GLORIVIL;DIALLO ALHOUSSEYNI;ARCE CAMPOS LUZ MARIOLY. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PAULAKELVIN;NASIR KHAN AMINA;OLOERIU DANIELA;FERMIN PE脩A NIURKA-ANYOLINA. Apoderado: EBRAHIMNIA MOHAMMADALI;MERIZALDE CABRERA PRAXEDES YUCEPI;PAZMI脩O GARCIA MARIELA DEL CARMEN;PI脩A IBARRA ARNALDOROBERTO;SANDU ELIZABETH;AONLINE GRUPO TELECOM SLApo.Sol.: EDDEHBI EL HABIB;ESPINOZA CABRERA MARIABELEN;NU脩EZ DIAZ MARINES DEL CARMEN;ABREU MEJIA FRANKLIN;SEGURA CUADROS HENRY FABIAN. Datos registrales.T 25755 , F 214, S 8, H M 81588, I/A 90 (25.11.15).
30 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ BAJO MIRIAM;CHAVERO TORRENOVA MARIA ELENA. Datos registrales. T 25755 , F214, S 8, H M 81588, I/A 89 (20.11.15).
06 de Noviembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 94.995,60 Euros. Desembolsado: 94.995,60 Euros. Resultante Suscrito: 1.335.001,22 Euros.Resultante Desembolsado: 1.335.001,22 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.- Ampliaci贸n decapital.. Datos registrales. T 25755 , F 214, S 8, H M 81588, I/A 88 (29.10.15).
25 de Septiembre de 2015Reelecciones. Consejero: MORENO DELGADO FRANCISCO. Con.Delegado: MORENO DELGADO FRANCISCO. Consejero:HAMMONDS BATES PATRICK. Secretario: HAMMONDS BATES PATRICK. Consejero: VILLALOBOS EDUARDO. Presidente:VILLALOBOS EDUARDO. Datos registrales. T 25755 , F 213, S 8, H M 81588, I/A 87 (14.09.15).
18 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: ESCUDERO DE LEON EDUARDO;OLCINA VITAL FRANCISCO;GONZALEZ BAJO MIRIAM.Nombramientos. Apo.Sol.: MILLAN CORTES MARIO ROBERTO. Apo.Manc.: ESCUDERO DE LEON EDUARDO;GONZALEZ BAJOMIRIAM;CHAVERO TORRENOVA MARIA ELENA;FURIO ALTOZANO RICARDO. Datos registrales. T 25755 , F 213, S 8, H M81588, I/A 86 (10.09.15).
26 de Mayo de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 89.999,00 Euros. Desembolsado: 89.999,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.240.005,62 Euros.Resultante Desembolsado: 1.240.005,62 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.- Ampliaci贸n deCapital.. Datos registrales. T 25755 , F 212, S 8, H M 81588, I/A 85 (18.05.15).
19 de Enero de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 750.001,70 Euros. Desembolsado: 750.001,70 Euros. Resultante Suscrito: 1.150.006,62 Euros.Resultante Desembolsado: 1.150.006,62 Euros. Datos registrales. T 25755 , F 212, S 8, H M 81588, I/A 84 (12.01.15).
26 de Diciembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.412.490,92 Euros. Resultante Suscrito: 400.004,92 Euros. Datos registrales. T 25755 ,F 211, S 8, H M 81588, I/A 83 (18.12.13).
01 de Octubre de 2013P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: http://europhil.es/. Datos registrales. T 25755 , F 211, S 8, H M81588, I/A 82 (23.09.13).
31 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DAVID. Presidente: PEREZ DAVID. Consejero: SCOTT ERIK ANDERSON. Secretario:SCOTT ERIK ANDERSON. Revocaciones. Apoderado: BLANCO MURCIA SILVIA;PEREZ DAVID;SCOTT ERIK ANDERSON.Nombramientos. Consejero: HAMMONDS BATES PATRICK. Secretario: HAMMONDS BATES PATRICK. Consejero: VILLALOBOSEDUARDO. Presidente: VILLALOBOS EDUARDO. Apo.Sol.: HAMMONDS BATES PATRICK;VILLALOBOS EDUARDO. Datosregistrales. T 25755 , F 209, S 8, H M 81588, I/A 81 (20.12.12).
17 de Diciembre de 2012Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: GASSO AUDITORES SLP.Datos registrales. T 25755 , F 209, S 8, H M 81588, I/A 80 (10.12.12).
04 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ ALVARADO DIVINA YOLANDA;EUROPEAN STAR TOURS SL;CHAUDIRADOUANE;SANCHEZ VERA MAIRA LILIANA;ISHAQUE MUHAMMAD;FAKIR FATIMA. Apo.Sol.: RAMIREZ BETANCOURTALEJANDRO;RIVERO HERNANDEZ MANUEL;COCA MORANTE FERNANDA;GUTIERREZ MIRANDA SONNIA MARLENE;GUEDESAFONSO MONEYBA;DEBNATH SANKAR KUMAR;KANWIAN 2009 SL;PANGANIBAN PECATE TAMELITO;MCHACHTI FARID.Datos registrales. T 25755 , F 208, S 8, H M 81588, I/A 79 (23.05.12).
11 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: ALMONTE MARTINEZ ROSAURA. Apo.Sol.: FERNANDEZ CASTILLO DIEGO ALEXANDER DEJESUS;LAROUSSI ABDERRAZAK. Datos registrales. T 25755 , F 208, S 8, H M 81588, I/A 78 (28.03.12).
07 de Febrero de 2012Fe de erratas: ANULACION DE LA INSCRIPCION 78& AL HABERSE EXTENDIDO POR ERROR EN LA HOJA DE ESTASOCIEDAD. Datos registrales. T 25755 , F 207, S 8, H M 81588, I/A 78 ( 3.01.12).
17 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: MORENO DELGADO FRANCISCO. Datos registrales. T 25755 , F 207, S 8, H M 81588, I/A 78 (3.01.12).
19 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: GUANTES PEDRO JOSE. Apo.Sol.: POSTIGO TANG CARMEN DIANA;GOMEZ HERRERO DARIOABELARDO;CLAVIJO Y DOMINGUEZ SL;ROMERO PARDO CLAUDIA YANETH;EL HABTI NAJLAE;DAVALOS ROMEROPAVEL;CARDONA MONTOYA NATALIA MARIA;DE GALDO RODRIGUEZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T 25755 , F 207, S 8, HM 81588, I/A 77 ( 5.10.11).
20 de Julio de 2011Revocaciones. Apoderado: ECHRIGUI ALI. Nombramientos. Apo.Sol.: DEBNATH SANKAR KUMAR;ROMERO PARDO CLAUDIAYANETH;EL HABTI NAJLAE;KANWIAN 2009 SL;PANGANIBAN PECATE TAMELITO. Datos registrales. T 25755 , F 206, S 8, H M81588, I/A 75 ( 6.07.11).
Revocaciones. Apo.Sol.: MANZANO BENITO MARCELINO. Nombramientos. Apo.Sol.: MCHACHTI FARID;DAVALOS ROMEROPAVEL;CARDONA MONTOYA NATALIA MARIA;SEGURA CUADROS HENRY FABIAN;DE GALDO RODRIGUEZ ANGEL LUIS.Datos registrales. T 25755 , F 206, S 8, H M 81588, I/A 76 ( 6.07.11).
17 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: LAROUSSI ABDERRAZAK;GUEDES AFONSO MONEYBA;GOMEZ HERRERO DARIOABELARDO;CLAVIJO Y DOMINGUEZ SL. Datos registrales. T 25755 , F 205, S 8, H M 81588, I/A 74 ( 7.06.11).
13 de Junio de 2011Revocaciones. Apoderado: AGUILAR BATISTA JESUS JONATHAN;BLANCO MARIN MONICA ANDREA. Apo.Sol.: GALLOSILGADO NELFY. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CASTILLO DIEGO ALEXANDER DE JESUS;ESPINOZA CABRERAMARIA BELEN;RIVERO HERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 25755 , F 204, S 8, H M 81588, I/A 72 ( 1.06.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: COCA MORANTE FERNANDA;NU脩EZ DIAZ MARINES DEL CARMEN;ABREU MEJIAFRANKLIN;MANZANO BENITO MARCELINO;GUTIERREZ MIRANDA SONNIA MARLENE. Datos registrales. T 25755 , F 205, S 8,H M 81588, I/A 73 ( 1.06.11).