Buscador CIF Logo

Actos BORME Unitono Servicios Externalizados Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Unitono Servicios Externalizados Sa

Actos BORME Unitono Servicios Externalizados Sa - A80777311

Tenemos registrados 41 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Unitono Servicios Externalizados Sa con CIF A80777311

馃敊 Perfil de Unitono Servicios Externalizados Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Unitono Servicios Externalizados Sa

13 de Julio de 2021
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 39978 , F 125, S 8, H M 122018, I/A 120 ( 6.07.21).

29 de Diciembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39978 , F 125, S 8, H M 122018, I/A 119 (21.12.20).

26 de Noviembre de 2020
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA ALBUFERA 319 2陋 (MADRID). Datos registrales. T 39978 , F 125, S 8, H M 122018, I/A118 (19.11.20).

17 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apoderado: NU脩EZ DE LA PE脩A PAULA;RUIZ DE ARANA FERNANDEZ IRENE ELENA. Apo.Man.Soli: NU脩EZ DELA PE脩A PAULA;RUIZ DE ARANA FERNANDEZ IRENE ELENA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRESPO LUNA JUAN;LLENABARREIRA GLORIA;AGUADO TORRES GONZALO ALEJANDRO;VAZQUEZ PEREGRINA ROBERTO;PEREZ ROSALES JULIOALBERTO;RUIZ MEDRANDA FRANCISCO;GARCIA MARTIN ANA MARIA;LOPEZ ROJO JOSE LUIS;NIETO MORENO CESAR;DELA CARRERA LEONES RAQUEL;CALVET ARANCE ANA. Datos registrales. T 39978 , F 123, S 8, H M 122018, I/A 117 (10.08.20).

15 de Junio de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 39978 , F 123, S 8, H M 122018, I/A 116 ( 8.06.20).

17 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALVET ARANCE ANA;VAZQUEZ PEREGRINA ROBERTO;PEREZ ROSALES JULIOALBERTO;RUIZ MEDRANDA FRANCISCO;GARCIA MARTIN ANA MARIA;LOPEZ ROJO JOSE LUIS;NU脩EZ DE LA PE脩APAULA;DE LA CARRERA LEONES RAQUEL;RUIZ DE ARANA FERNANDEZ IRENE ELENA. Datos registrales. T 39978 , F 122, S8, H M 122018, I/A 115 (10.03.20).

20 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: NU脩EZ DE LA PE脩A PAULA;DE LA CARRERA LEONES RAQUEL;RUIZ DE ARANA FERNANDEZIRENE ELENA;CERRO JIMENEZ MARIA GEMA;VAZQUEZ PEREGRINA ROBERTO;PEREZ ROSALES JULIO ALBERTO;RUIZMEDRANDA FRANCISCO;GARCIA MARTIN ANA MARIA;LOPEZ ROJO JOSE LUIS. Datos registrales. T 34588 , F 225, S 8, H M122018, I/A 114 (13.02.20).

21 de Noviembre de 2019
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE SL. Ceses/Dimisiones.Representan: GARCIA PELLEJERO JAVIER. Adm. Unico: AVANZA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS SA. Nombramientos.Adm. Unico: GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE SL. Representan: LOPEZ PEREZ CESAR VICENTE. Datos registrales. T 34588 , F222, S 8, H M 122018, I/A 112 (14.11.19).

Revocaciones. Apoderado: PASTOR PEREZ AFRICA. Apo.Man.Soli: MORENO MARTIN CARLOS UBALDO;DE SANTIAGO PAZFERNANDO;IBA脩EZ PEREZ ALBERTO. Apo.Manc.: GARCIA PELLEJERO JAVIER. Apo.Sol.: MORA ALZAGA BEATRIZ;GOMEZPIQUERO NOELIA. Apoderado: ALCAIDE ROLLO JAVIER;ALBA MU脩OZ MARIA DOLORES. Apo.Man.Soli: CERRO JIMENEZMARIA GEMA. Nombramientos. Apoderado: CERRO JIMENEZ MARIA GEMA;VAZQUEZ PEREGRINA ROBERTO;PEREZROSALES JULIO ALBERTO;RUIZ MEDRANDA FRANCISCO;GARCIA MARTIN ANA MARIA;LOPEZ ROJO JOSE LUIS. Datosregistrales. T 34588 , F 222, S 8, H M 122018, I/A 113 (14.11.19).

11 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: CERRO JIMENEZ MARIA GEMA;VAZQUEZ PEREGRINA ROBERTO;PEREZ ROSALES JULIOALBERTO;RUIZ MEDRANDA FRANCISCO;GARCIA MARTIN ANA MARIA. Datos registrales. T 34588 , F 221, S 8, H M 122018, I/A111 ( 4.11.19).

24 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: ALCANTARA MORALES JOSE IGNACIO. Apo.Sol.: ALCANTARA MORALES JOSE IGNACIO.Apoderado: PINO FERRE NURIA. Apo.Sol.: LLINAS GARCIA DAVID. Apoderado: VALLEJOS ROSIQUE PEDRO;PINO FERRENURIA. Apo.Man.Soli: PINO FERRE NURIA;ALCANTARA MORALES JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 34588 , F 220, S 8, H M122018, I/A 110 (17.06.19).

31 de Mayo de 2019
Otros conceptos: SE SUBSANA EL ERROR COMETIDO EN LA CERTIFICACION PROTOCOLIZADA EN LA ESCRITURA QUECAUSO LA INSCRIPCION 108陋, EN EL SENTIDO DE QUE EL IMPORTE CORRECTO EN EL QUE SE AUMENTABA EL CAPITALERAN 6.190,42 EUROS, CON UNA PRIMA DE EMISION DE 251,27 EUROS POR ACCION, QUEDANDO EL CAPITAL FIJADO EN66.291,63. Datos registrales. T 34588 , F 220, S 8, H M 122018, I/A 109 (24.05.19).

04 de Marzo de 2019
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 264.998,25 Euros. Desembolsado: 264.998,25 Euros. Resultante Suscrito: 325.099,46 Euros.Resultante Desembolsado: 325.099,46 Euros. Datos registrales. T 34588 , F 219, S 8, H M 122018, I/A 108 (25.02.19).

24 de Enero de 2018
Cambio de objeto social. La creaci贸n de estrategias para campa帽as telef贸nicas. La planificaci贸n, log铆stica y realizaci贸n de campa帽astelef贸nicas.Las actividades de emisi贸n/recepci贸n de llamadas. Las actividades de consultor铆a, selecci贸n y formaci贸n en telemarketing.Datos registrales. T 34588 , F 219, S 8, H M 122018, I/A 107 (16.01.18).

02 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CERRO JIMENEZ MARIA GEMA. Apo.Manc.: GARCIA PELLEJERO JAVIER. Datos registrales. T34588 , F 219, S 8, H M 122018, I/A 106 (25.10.17).

25 de Mayo de 2017
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 34588 , F 218, S 8, H M 122018, I/A 105 (18.05.17).

23 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: PINO FERRE NURIA. Datos registrales. T 34588 , F 217, S 8, H M 122018, I/A 103 (15.11.16).

Revocaciones. Apoderado: VAN LUYK JOHANESS. Apo.Manc.: VAN LUYK JOHANESS. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZPABLO;CHECA SAENZ JOSE;ESCUDERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JOSE LUIS;ALVAREZ SANCHEZGRACIANO;MARTINEZ POLO JACINTO;GARCIA GARCIA SANTIAGO;RUIZ DE LEON LORIGA IGNACIO JOSE;SANTISTEBANLOPEZ JUAN MARCOS;GODOY GARDA ALEXIS. Apo.Sol.: ARDANAZ PARIENTE JUAN-CARLOS;VIOTA LOPEZ-LINARESRAFAEL;ARDANAZ PARIENTE JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli: MORA ALZAGA BEATRIZ;ARDANAZ PARIENTE JUAN CARLOS.Apo.Sol.: DE SANTIAGO PAZ FERNANDO;ARDANAZ PARIENTE JUAN CARLOS;ALCANTARA MORALES JOSE IGNACIO;MORAALZAGA BEATRIZ;ALVAREZ CHAFER JUAN JOSE;SEQUEIRA SUARDIAZ MARTA;LANCHAS MU脩OZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: DESANTIAGO PAZ FERNANDO;ARDANAZ PARIENTE JUAN CARLOS. Apo.Sol.: PINAR FORCEN JESUS;LOBATO RIESGO

06 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apoderado: PASTOR PEREZ AFRICA. Nombramientos. Apoderado: PASTOR PEREZ AFRICA. Datosregistrales. T 34588 , F 216, S 8, H M 122018, I/A 102 (29.09.16).

09 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apoderado: PASTOR PEREZ AFRICA. Datos registrales. T 23299 , F 55, S 8, H M 122018, I/A 101 ( 2.08.16).

22 de Julio de 2016
Cambio de domicilio social. AVDA DE CASTILLA 2 - EDIFICIO CANADA - PARQUE EMPR (SAN FERNANDO DE HENARES).Datos registrales. T 23299 , F 55, S 8, H M 122018, I/A 100 (15.07.16).

14 de Diciembre de 2015
Cambio de objeto social. : La prestaci贸n de servicios inbound de atenci贸n al cliente mediante la recepci贸n de llamadas telef贸nicas uotros canales digitales con fines comerciales y de asesoramiento de clientes o futuros clientes de las empresas para las que se prestenlos servicios, ......... Datos registrales. T 23299 , F 55, S 8, H M 122018, I/A 99 ( 4.12.15).

10 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: GOMES SOUSAS MARIA;VALLEJOS ROSIQUE PEDRO;ALBA MU脩OZ MARIA DOLORES. Datosregistrales. T 23299 , F 55, S 8, H M 122018, I/A 98 (30.11.15).

04 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 23299 , F 54, S 8, H M 122018, I/A 97 (27.10.15).

20 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA JOAQUIN. Nombramientos. Representan: GARCIAPELLEJERO JAVIER. Datos registrales. T 23299 , F 54, S 8, H M 122018, I/A 96 (13.10.15).

12 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ ALONSO PLAZA ALVARO;PASTEGA BENJUMEA PABLO;DEL OLMO CASALDERREYLUIS. Presidente: ALVAREZ ALONSO PLAZA ALVARO. Vicepresid.: PASTEGA BENJUMEA PABLO. Con.Delegado: DEL OLMOCASALDERREY LUIS. Secretario: LOPEZ TORRENS JULIO. Nombramientos. Adm. Unico: AVANZA EXTERNALIZACION DESERVICIOS SA. Representan: BOHORQUEZ CRESPI DE VALLDAURA JOAQUIN. Modificaciones estatutarias. 14.Funcionamiento Junta Gral.-. 18. Funcionamiento Junta Gral.-. 21. Administraci贸n y Representacion.-. 22. Funcionamiento Junta Gral.-.23. queda sin contenido el art铆culo 23. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 23299 , F 53, S 8, H M 122018, I/A 95 ( 3.08.15).

31 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SL. Datos registrales. T 23299 , F 53, S 8, H M 122018, I/A 94 (23.12.14).

26 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SL. Datos registrales. T 23299 , F 53, S 8, H M 122018, I/A 93 (15.11.13).

03 de Abril de 2013
Reelecciones. Presidente: ALVAREZ ALONSO PLAZA ALVARO. Vicepresid.: PASTEGA BENJUMEA PABLO. Con.Delegado: DELOLMO CASALDERREY LUIS. Datos registrales. T 23299 , F 53, S 8, H M 122018, I/A 92 (25.03.13).

Reelecciones. Consejero: ALVAREZ ALONSO PLAZA ALVARO;PASTEGA BENJUMEA PABLO;DEL OLMO CASALDERREY LUIS.Datos registrales. T 23299 , F 52, S 8, H M 122018, I/A 91 (25.03.13).

06 de Marzo de 2013
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SL. Datos registrales. T 23299 , F 52, S 8, H M 122018, I/A 90 (26.02.13).

24 de Mayo de 2012
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 23299 , F 52, S 8, H M 122018, I/A 89 (14.05.12).

09 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: ALCAIDE ROLLO JAVIER. Datos registrales. T 23299 , F 52, S 8, H M 122018, I/A 88 (31.05.11).

28 de Febrero de 2011
Revocaciones. Apoderado: SAAVEDRA JIMENEZ PALOMA. Apo.Manc.: SAAVEDRA JIMENEZ PALOMA. Datos registrales. T23299 , F 51, S 8, H M 122018, I/A 87 (16.02.11).

28 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: ROMERO ZABALA JOSEFA. Datos registrales. T 23299 , F 51, S 8, H M 122018, I/A 86 (18.10.10).

21 de Julio de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: LLINAS GARCIA DAVID;PINAR FORCEN JESUS;LOBATO RIESGO BALDOMERO. Datos registrales.T 23299 , F 50, S 8, H M 122018, I/A 83 ( 9.07.10).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PARRA LUIS. Datos registrales. T 23299 , F 50, S 8, H M 122018, I/A 84 ( 9.07.10).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ SHEILA;GOMEZ PIQUERO NOELIA. Datos registrales. T 23299 , F 51, S 8, H M122018, I/A 85 ( 9.07.10).

22 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: PINO FERRE NURIA. Datos registrales. T 23299 , F 50, S 8, H M 122018, I/A 82 ( 8.07.09).

03 de Julio de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: DE SANTIAGO PAZ FERNANDO;ARDANAZ PARIENTE JUAN CARLOS. Datos registrales. T 23299 ,F 49, S 8, H M 122018, I/A 81 (23.06.09).

20 de Mayo de 2009
Revocaciones. Auditor: IBERICA DE AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: AUREN CENTRO AUDITORES YCONSULTORES SL. Datos registrales. T 23299 , F 49, S 8, H M 122018, I/A 80 ( 7.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n