Buscador CIF Logo

Actos BORME Universidad Internacional Isabel I De Castilla Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Universidad Internacional Isabel I De Castilla Sa

Actos BORME Universidad Internacional Isabel I De Castilla Sa - A09515412

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Universidad Internacional Isabel I De Castilla Sa con CIF A09515412

馃敊 Perfil de Universidad Internacional Isabel I De Castilla Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Universidad Internacional Isabel I De Castilla Sa

30 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: GAITE PINDADO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 782, L 573, F 71, S 8, H BU 13725, I/A 29(24.06.22).

Revocaciones. Apoderado: BACHMANN FUENTES RICARDO IGNACIO. Datos registrales. T 782, L 573, F 71, S 8, H BU 13725,I/A 30 (24.06.22).

20 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS;VELEZ CARRERA CELESTINO. Presidente: CUELLARNEBREDA MARIA JESUS. Secretario: VELEZ CARRERA CELESTINO. Consejero: GOMEZ BARAHONA ALBERTO. Cons.Del.Sol:CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS;VELEZ CARRERA CELESTINO. Nombramientos. Consejero: CUELLAR NEBREDA MARIAJESUS;GOMEZ BARAHONA ALBERTO;GOMEZ CUELLAR MARTA. Presidente: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS. Secretario:GOMEZ BARAHONA ALBERTO. Con.Delegado: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS. Datos registrales. T 690, L 481, F 40, S 8, HBU 13725, I/A 23 (14.05.21).

Nombramientos. Apoderado: ORTEGA ALEGRE LARA. Datos registrales. T 782, L 573, F 69, S 8, H BU 13725, I/A 25 (14.05.21).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA PEREZ ANA CRISTINA. Datos registrales. T 782, L 573, F 70, S 8, H BU 13725, I/A 26(14.05.21).

Nombramientos. Apoderado: CABRERO LOBATO PATRICIA. Datos registrales. T 782, L 573, F 70, S 8, H BU 13725, I/A 27(14.05.21).

Nombramientos. Apoderado: BACHMANN FUENTES RICARDO IGNACIO. Datos registrales. T 782, L 573, F 71, S 8, H BU 13725,I/A 28 (14.05.21).

Nombramientos. Apoderado: OBREGON POZO LORENA. Datos registrales. T 690, L 481, F 40, S 8, H BU 13725, I/A 24(14.05.21).

06 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Auditor: SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO. Aud.Supl.: VILLANUEVA RIU EUSTASIO. Nombramientos.Auditor: VADILLO & ASOCIADOS AUDITORES Y ADMINISTRADORES CO. Datos registrales. T 690, L 481, F 40, S 8, H BU 13725,I/A 22 (31.01.20).

29 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DE JUAN FELIX. Datos registrales. T 690, L 481, F 40, S 8, H BU 13725, I/A 21 (23.01.20).

26 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ABADIA GARCIA DE VICU脩A OLAIA. Datos registrales. T 690, L 481, F 40, S 8, H BU 13725, I/A 20(20.02.19).

10 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Cons.Del.Sol: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Nombramientos.Consejero: GOMEZ BARAHONA ALBERTO. Cons.Del.Sol: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS. Reelecciones. Cons.Del.Sol:VELEZ CARRERA CELESTINO. Datos registrales. T 690, L 481, F 39, S 8, H BU 13725, I/A 19 ( 6.08.18).

16 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAZURRO BARAHONA VICTOR;VELEZ CARRERA CELESTINO;GARCIA DE JUAN FELIX;ABADIAGARCIA DE VICU脩A OLAIA. Secretario: VELEZ CARRERA CELESTINO. Cons.Del.Sol: CAZURRO BARAHONA VICTOR;VELEZCARRERA CELESTINO. Consejero: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS. Presidente: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS.Nombramientos. Consejero: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS;GARCIA DE JUAN FELIX;CAZURRO BARAHONAVICTOR;ABADIA GARCIA DE VICU脩A OLAIA;VELEZ CARRERA CELESTINO. Presidente: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS.Secretario: VELEZ CARRERA CELESTINO. Cons.Del.Sol: CAZURRO BARAHONA VICTOR;VELEZ CARRERA CELESTINO. Datosregistrales. T 690, L 481, F 38, S 8, H BU 13725, I/A 18 ( 9.08.17).

15 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARDOSO LUIS MANUEL. Datos registrales. T 690, L 481, F 38, S 8, H BU 13725, I/A 17 (8.03.17).

01 de Marzo de 2017
Nombramientos. Auditor: SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO. Aud.Supl.: VILLANUEVA RIU EUSTASIO. Datos registrales. T690, L 481, F 38, S 8, H BU 13725, I/A 16 (22.02.17).

14 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ BARAHONA ALBERTO. Datos registrales. T 663, L 454, F 177, S 8, H BU 13725, I/A 15 (8.04.15).

06 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GALLEGO ISIDORO. Datos registrales. T 663, L 454, F 177, S 8, H BU 13725, I/A 14(27.03.15).

08 de Enero de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Nombramientos. Consejero: CUELLAR NEBREDA MARIAJESUS. Presidente: CUELLAR NEBREDA MARIA JESUS. Datos registrales. T 663, L 454, F 176, S 8, H BU 13725, I/A 13(30.12.14).

09 de Julio de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.719.400,00 Euros. Desembolsado: 1.719.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.780.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.780.000,00 Euros. Datos registrales. T 663, L 454, F 176, S 8, H BU 13725, I/A 12 ( 2.07.14).

24 de Diciembre de 2013
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Datos registrales. T 663, L 454, F 175, S 8, H BU 13725, I/A 11(17.12.13).

20 de Agosto de 2013
Fe de erratas: Se rectifica el cambio de domicilio que caus贸 la inscripci贸n 9& siendo el correcto: "Burgos, C/ Fern谩n Gonz谩lez, n潞 76,CP 09003". Datos registrales. T 663, L 454, F 175, S 8, H BU 13725, I/A 9 ( 4.07.13).

10 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAZURRO BARAHONA VICTOR;CAMPO REVILLA ALBERTO;CARDOSO LUIS MANUEL;GARCIADE JUAN FELIX;ABADIA GARCIA DE VICU脩A OLAIA. Presidente: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Secretario: CAMPO REVILLAALBERTO. Nombramientos. Consejero: CAZURRO BARAHONA VICTOR;VELEZ CARRERA CELESTINO;CARDOSO LUISMANUEL;GARCIA DE JUAN FELIX;ABADIA GARCIA DE VICU脩A OLAIA. Presidente: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Secretario:VELEZ CARRERA CELESTINO. Cons.Del.Sol: CAZURRO BARAHONA VICTOR;VELEZ CARRERA CELESTINO. Modificacionesestatutarias. 5. Capital.Se Modifica el valor nominal de las acciones de la sociedad de 600 E a 1 E, sin que se produzca la variaci贸nde la cifra del capital social.. Cambio de domicilio social. C/ FERNAN GONZALEZ 74 (BURGOS). Datos registrales. T 663, L 454,F 175, S 8, H BU 13725, I/A 9 ( 4.07.13).

10 de Junio de 2013
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 45.450,00 Euros. Datos registrales. T 623, L 414, F 20, S 8, H BU 13725, I/A8 ( 4.06.13).

17 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAZURRO BARAHONA VICTOR;INSTITUTO PIAGET-COOPERATIVA PARA ODESENVOLVIMIEN;GARCIA DE JUAN FELIX. Presidente: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Consejero: CAMPO REVILLAALBERTO. Secretario: CAMPO REVILLA ALBERTO. Con.Delegado: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Consejero: ABADIA GARCIADE VICU脩A OLAIA. Nombramientos. Consejero: CAZURRO BARAHONA VICTOR;CAMPO REVILLA ALBERTO;CARDOSO LUISMANUEL;GARCIA DE JUAN FELIX;ABADIA GARCIA DE VICU脩A OLAIA. Presidente: CAZURRO BARAHONA VICTOR. Secretario:CAMPO REVILLA ALBERTO. Datos registrales. T 623, L 414, F 19, S 8, H BU 13725, I/A 6 (11.04.13).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GALLEGO ISIDORO. Datos registrales. T 623, L 414, F 20, S 8, H BU 13725, I/A 7(11.04.13).

24 de Septiembre de 2012
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CAMPUS EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEON SA. Datos registrales. T 623, L414, F 18, S 8, H BU 13725, I/A 4 (14.09.12).

Nombramientos. Apoderado: MONTERO MARTINEZ CRISTINA. Datos registrales. T 623, L 414, F 19, S 8, H BU 13725, I/A 5(14.09.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n