Buscador CIF Logo

Actos BORME Unmequi Universal Medico Quirurgica Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Unmequi Universal Medico Quirurgica Sociedad Anonima

Actos BORME Unmequi Universal Medico Quirurgica Sociedad Anonima - A28026003

Tenemos registrados 37 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Unmequi Universal Medico Quirurgica Sociedad Anonima con CIF A28026003

馃敊 Perfil de Unmequi Universal Medico Quirurgica Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Unmequi Universal Medico Quirurgica Sociedad Anonima

14 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: REGUERA ERRASTI JAVIER;LOPEZ RUBAL JOSE ANTONIO;ABARCA CIDON JUAN;HMHOSPITALES 1989 SA. Presidente: HM HOSPITALES 1989 SA. Con.Delegado: HM HOSPITALES 1989 SA. Vicepresid.: ABARCACIDON JUAN. Secretario: LOPEZ RUBAL JOSE ANTONIO. Secr.Supl.: REGUERA ERRASTI JAVIER. Revocaciones. Apoderado:ABARCA CIDON ALEJANDRO;ABARCA CIDON JUAN;ARMENTA MARQUEZ LUIS;BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN;ABARCACIDON ELENA;DIEZ ANDRES FLORENTINO;IRURITA DIEZ ALVARO;LOPEZ GOMEZ JOAQUIN MARIANO;ESTIRADOBRONCHALO ALBERTO;ARMENTA MARQUEZ LUIS. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 33074 , F 53, S 8, H M37929, I/A 87 ( 6.10.21).

26 de Mayo de 2021
Otros conceptos: Inserci贸n en la p谩gina web de la sociedad del proyecto com煤n de fusi贸n relativo a la fusi贸n por absorci贸n entre HMHOSPITALES 1989 SA como absorbente y UNMEQUI UNIVERSAL MEDICO QUIRURGICA SOCIEDAD ANONIMA como absorbida.Datos registrales. T 2143 , F 16, S 8, H M 37929, I/A 20-M (19.05.21).

01 de Septiembre de 2020
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 33074 , F53, S 8, H M 37929, I/A 86 (25.08.20).

07 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: ESTIRADO BRONCHALO ALBERTO. Datos registrales. T 33074 , F 52, S 8, H M 37929, I/A 84(30.06.20).

Nombramientos. Apoderado: ARMENTA MARQUEZ LUIS. Datos registrales. T 33074 , F 52, S 8, H M 37929, I/A 85 (30.06.20).

08 de Mayo de 2020
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: HM HOSPITALES 1989 SA. Datos registrales. T 33074 , F 52, S 8, H M 37929, I/A83 (30.04.20).

24 de Abril de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 378.480,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.SE MODIFIA EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 33074 , F 51, S 8, H M 37929, I/A 82 (17.04.20).

28 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORESSL. Datos registrales. T 33074 , F 51, S 8, H M 37929, I/A 81 (20.12.18).

11 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GOMEZ JOAQUIN MARIANO. Datos registrales. T 33074 , F 50, S 8, H M 37929, I/A 80 (3.10.18).

14 de Septiembre de 2018
Cambio de domicilio social. PLAZA DEL CONDE DEL VALLE DE SUCHIL, 2 (MADRID). Datos registrales. T 33074 , F 50, S 8, HM 37929, I/A 79 ( 6.09.18).

27 de Febrero de 2017
Nombramientos. Apoderado: DIEZ ANDRES FLORENTINO. Datos registrales. T 33074 , F 49, S 8, H M 37929, I/A 77 (20.02.17).

Nombramientos. Apoderado: IRURITA DIEZ ALVARO. Datos registrales. T 33074 , F 49, S 8, H M 37929, I/A 78 (20.02.17).

02 de Febrero de 2017
P谩gina web de la sociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: www.hmhospitales.com. Datosregistrales. T 33074 , F 49, S 8, H M 37929, I/A 76 (26.01.17).

16 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: BELTRAN GAMIR RAFAEL BJORN. Datos registrales. T 33074 , F 48, S 8, H M 37929, I/A 74 (5.01.17).

Nombramientos. Apoderado: ABARCA CIDON ELENA. Datos registrales. T 33074 , F 48, S 8, H M 37929, I/A 75 ( 5.01.17).

21 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDRIA SL. Nombramientos. Auditor: EUDITA PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS SL. Datosregistrales. T 33074 , F 47, S 8, H M 37929, I/A 73 (10.11.16).

07 de Abril de 2016
Nombramientos. Apoderado: ARMENTA MARQUEZ LUIS. Datos registrales. T 33074 , F 47, S 8, H M 37929, I/A 72 (30.03.16).

24 de Febrero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Desembolsado: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.378.480,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.377.972,45 Euros. Datos registrales. T 33074 , F 46, S 8, H M 37929, I/A 71 (17.02.16).

16 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARCO ARBOLI MARIA JOSE;IRURITA DIEZ ALVARO. Secretario: REGUERA ERRASTI JAVIER.Nombramientos. Consejero: LOPEZ RUBAL JOSE ANTONIO;ABARCA CIDON JUAN. Con.Delegado: HM HOSPITALES 1989 SA.Vicepresid.: ABARCA CIDON JUAN. Secretario: LOPEZ RUBAL JOSE ANTONIO. Secr.Supl.: REGUERA ERRASTI JAVIER.Reelecciones. Presidente: HM HOSPITALES 1989 SA. Datos registrales. T 33074 , F 45, S 8, H M 37929, I/A 70 ( 9.12.15).

27 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LUXAN MARCO ANA. Secretario: DE LUXAN MARCO ANA. Secr.Supl.: PEREZ LORENZOMANUEL JESUS. Consejero: PEREZ LORENZO MANUEL JESUS. Con.Delegado: MARCO ARBOLI MARIA JOSE. Presidente:MARCO ARBOLI MARIA JOSE. Revocaciones. Apoderado: PEREZ LORENZO MANUEL JESUS. Nombramientos. Consejero:HOSPITAL DE MADRID SA. Representan: ABARCA CIDON ALEJANDRO. Presidente: HOSPITAL DE MADRID SA. Secretario:REGUERA ERRASTI JAVIER. Apoderado: ABARCA CIDON ALEJANDRO;ABARCA CIDON JUAN. Datos registrales. T 33074 , F43, S 8, H M 37929, I/A 69 (19.08.15).

06 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ MERCHAN JONAS;MARCO ARBOLI PILAR. Nombramientos. Consejero: REGUERAERRASTI JAVIER;IRURITA DIEZ ALVARO. Reelecciones. Auditor: AUDRIA SL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5潞 DELOS ESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: SUBSANADO EL ERROR PADECIDO EN LA REDUCCION DE CAPITALSOCIAL ACORDADA POR LA JUNTA GENERAL DE 26 DE JUNIO DE 2015, INSCRIPCION 55; COMO CONSECUENCIA, ELCAPITAL SOCIAL SUSCRITO DE 378.480 QUEDA DESEMBOLSADO EN LA CANTIDAD DE 377.972,45 EUROS. Datosregistrales. T 33074 , F 41, S 8, H M 37929, I/A 68 (28.07.15).

04 de Agosto de 2015
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 3.652,56 Euros. Datos registrales. T 33074 , F 40, S 8, H M 37929, I/A 67(27.07.15).

20 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 33074 , F 40, S 8, H M 37929, I/A 66 (11.03.15).

18 de Marzo de 2015
Reelecciones. Auditor: AUDRIA SL. Datos registrales. T 33074 , F 40, S 8, H M 37929, I/A 65 (10.03.15).

13 de Marzo de 2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: REVILLA AMORES MANUEL. Modificaciones estatutarias. SEMODIFICAN LOS ARTICULOS 11, 12, 13 Y 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVOS A LA TRANSMISION DE LASACCIONES Y ASISTENCIA A LA JUNTA. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.vallessalud.com.Datos registrales. T 22620 , F 224, S 8, H M 37929, I/A 64 ( 5.03.15).

24 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: PEREZ LORENZO MANUEL JESUS. Datos registrales. T 22620 , F 224, S 8, H M 37929, I/A 63(17.01.14).

02 de Diciembre de 2013
Reelecciones. Auditor: AUDRIA SL;AUDRIA SL. Datos registrales. T 22620 , F 224, S 8, H M 37929, I/A 62 (21.11.13).

26 de Agosto de 2010
Nombramientos. Consejero: JIMENEZ MERCHAN JONAS;MARCO ARBOLI PILAR. Secr.Supl.: PEREZ LORENZO MANUELJESUS. Reelecciones. Auditor: LAVINIA AUDITORIA Y CONSULTORIA DE GESTION SL. Consejero: MARCO ARBOLI MARIAJOSE. Con.Delegado: MARCO ARBOLI MARIA JOSE. Presidente: MARCO ARBOLI MARIA JOSE. Secretario: DE LUXAN MARCO

13 de Mayo de 2010
Reelecciones. Auditor: LAVINIA AUDITORIA Y CONSULTORIA DE GESTION SL;LAVINIA AUDITORIA Y CONSULTORIA DEGESTION SL;LAVINIA AUDITORIA Y CONSULTORIA DE GESTION SL;LAVINIA AUDITORIA Y CONSULTORIA DE GESTIONSL;LAVINIA AUDITORIA Y CONSULTORIA DE GESTION SL. Datos registrales. T 22620 , F 221, S 8, H M 37929, I/A 60 ( 3.05.10).

05 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA OLMOS CONCEPCION. Secretario: GARCIA OLMOS CONCEPCION. Nombramientos.Secretario: DE LUXAN MARCO ANA. Datos registrales. T 22620 , F 221, S 8, H M 37929, I/A 59 (23.04.10).

19 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ LOPEZ MAXIMO;BASANTE MARTINEZ DANIEL. Nombramientos. Consejero: PEREZLORENZO MANUEL JESUS;DE LUXAN MARCO ANA. Datos registrales. T 22620 , F 220, S 8, H M 37929, I/A 57 (10.02.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LANDEIRA FERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 22620 , F 221, S 8, H M 37929, I/A 58(10.02.10).

30 de Noviembre de 2009
Fusi贸n por uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: UNMEQUI SANATORIOS SL. Datos registrales. T 22620 , F 215, S 8, H M 37929,I/A 56 (18.11.09).

04 de Noviembre de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 991.827,59 Euros. Resultante Suscrito: 378.480,00 Euros. Datos registrales. T 22620 , F215, S 8, H M 37929, I/A 55 (21.10.09).

18 de Septiembre de 2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 16.936,09 Euros. Datos registrales. T 22620 , F 214, S 8, H M 37929, I/A 53( 9.09.09).

Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 174.944,26 Euros. Datos registrales. T 22620 , F 214, S 8, H M 37929, I/A 54( 9.09.09).

14 de Septiembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 288.485,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.370.307,59 Euros. Modificaciones estatutarias. SEMODIFICAN LOS ARTICULOS 5潞, 8潞, 11潞, 12潞 Y 13潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 22620 , F 209, S 8, H M37929, I/A 52 ( 1.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n