Actos BORME de Unvi Carroceros Sl
24 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Apo.Sol.: GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO;PADRONCONDE JUAN CARLOS;PADRON CONDE JUAN CARLOS;LEGIDO MARIÑO EVA MARIA;PEREZ BARCA JUANCARLOS;GONZALEZ VILLAR TANIA. Apo.Manc.: LECOMPTE ALEXANDER. Apo.Sol.: PEREZ BARCA JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 901 , F 197, S 8, H OR 10400, I/A 24 ( 8.03.22).
04 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 901 , F 197, S 8, H OR 10400, I/A 23 (26.01.22).
30 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE;PEREZ RUMBAO SA;LAGO PEÑAS SANTIAGO. Presidente:PEREZ NIETO EMILIO JOSE VICENTE. Nombramientos. Consejero: PEREZ BELLIDO JOAQUIN;SEIJAS PEREZ RAMONMARIA;GOMEZ COIRA ANDRES IGNACIO. Presidente: PEREZ MARTINEZ ELOY. Datos registrales. T 901 , F 197, S 8, H OR10400, I/A 22 (21.12.20).
13 de Febrero de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CABO PAREJO PATRICIA;CONDE GONZALEZ ANABEL. Datos registrales. T 901 , F 196, S 8, H OR10400, I/A 21 ( 1.02.19).
14 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 901 , F 196, S 8, H OR 10400, I/A 20 (27.12.18).
04 de Enero de 2019Nombramientos. Consejero: LAGO PEÑAS SANTIAGO. Otros conceptos: Se modifica el artículo 25º de los Estatutos Sociales encuanto a que el cargo de administrador o consejero, en su caso, pasa a ser retribuido. Datos registrales. T 901 , F 196, S 8, H OR10400, I/A 19 (20.12.18).
14 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODAS MEIRA NURIA. Nombramientos. Apo.Sol.: PADRON CONDE JUAN CARLOS;FERNANDEZCONDE SONIA;LEGIDO MARIÑO EVA MARIA;GONZALEZ VILLAR TANIA;PEREZ BARCA JUAN CARLOS. Datos registrales. T716 , F 125, S 8, H OR 10400, I/A 18 ( 3.09.18).
Ampliación de capital. Capital: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.922.500,00 Euros. Datos registrales. T 716 , F 125, S 8, HOR 10400, I/A 17 ( 3.09.18).
10 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: SODIGA GALICIA SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO SA. Datos registrales. T 716 , F 125, S 8,H OR 10400, I/A 16 ( 2.05.18).
14 de Febrero de 2018Otros conceptos: Limitación de facultades conferidas al Consejero Delegado, Don Eloy Pérez Martínez. Datos registrales. T 716 , F124, S 8, H OR 10400, I/A 14 (29.01.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ MARTINEZ ELOY. Nombramientos. Apo.Manc.: LECOMPTE ALEXANDER. Datosregistrales. T 716 , F 125, S 8, H OR 10400, I/A 15 (29.01.18).
25 de Agosto de 2017Nombramientos. Consejero: PEREZ BELLIDO EMILIO. Datos registrales. T 716 , F 124, S 8, H OR 10400, I/A 13 (10.08.17).
10 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: PADRON CONDE JUAN CARLOS;RODAS MEIRA NURIA;LEGIDO MARIÑO EVA MARIA;PEREZBARCA JUAN CARLOS;GONZALEZ VILLAR TANIA. Datos registrales. T 716 , F 124, S 8, H OR 10400, I/A 12 (30.01.17).
08 de Febrero de 2013Nombramientos. Con.Delegado: PEREZ MARTINEZ ELOY. Datos registrales. T 716 , F 123, S 8, H OR 10400, I/A 10 (31.01.13).
19 de Octubre de 2009Nombramientos. Consejero: PEREZ MARTINEZ ELOY;GONZALEZ PEREIRA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 716 , F123, S 8, H OR 10400, I/A 9 ( 5.10.09).
23 de Abril de 2009Revocaciones. Apoderado: ARMESTO VILANOVA JESUS;ARMESTO VILANOVA JESUS. Datos registrales. T 716 , F 123, S 8, HOR 10400, I/A 8 ( 8.04.09).
02 de Marzo de 2009Ampliación de capital. Capital: 1.372.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.622.500,00 Euros. Datos registrales. T 716 , F 122, S 8,H OR 10400, I/A 7 ( 6.02.09).