Buscador CIF Logo

Actos BORME Uponor Hispania Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Uponor Hispania Sa

Actos BORME Uponor Hispania Sa - A81248072

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Uponor Hispania Sa con CIF A81248072

🔙 Perfil de Uponor Hispania Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Uponor Hispania Sa

08 de Noviembre de 2023
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ZION CLAUDIO EDUARDO. Nombramientos. Consejero: JUSTOVARELA ELISABETH. Datos registrales. T 9810 , F 225, S 8, H M 157540, I/A 65 (31.10.23).

Revocaciones. Apoderado: ZION CLAUDIO EDUARDO. Apo.Manc.: ZION CLAUDIO EDUARDO. Apo.Man.Soli: AVILA SANZLAURA;ZION CLAUDIO EDUARDO. Apo.Sol.: AVILA SANZ LAURA. Apo.Manc.: ZION CLAUDIO EDUARDO;AVILA SANZ LAURA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: AVILA SANZ LAURA;VALENTE GANDRA ANTONIO FERNANDO;JUSTO VARELA ELISABETH.Datos registrales. T 9810 , F 225, S 8, H M 157540, I/A 66 (31.10.23).

13 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: WILLIAMSSON FOLKE PER OLA;AMANDI DE SOUSA RUI MANUEL;LARSSONGUNNAR;STJARNESUND ROLF GUNNAR;HERDIN SVABINKAS DANIEL;WILLIAMSSON FOLKE PER OLA;AMANDI DE SOUSARUI MANUEL;LARSSON GUNNAR;ENGUIDANOS RAMOS ELENA;HERDIN SVABINKAS DANIEL ALEXANDER;ENGUIDANOSRAMOS ELENA. Apo.Man.Soli: ENGUIDANOS RAMOS ELENA;HEINONEN THOMAS ERIK JOHANNES. Apoderado: KAHANPAAVELI PEKKA;JARVINEN JUHA PETTERI;JOKINEN AUNE VAPPU. Apo.Manc.: KRAPF BURKHARD MICHAELSEBASTIAN;ENGUIDANOS RAMOS ELENA. Apoderado: STECH CHRISTOF ALEXANDER;STECH CHRISTOF ALEXANDER.Apo.Manc.: STECH CHRISTOF ALEXANDER. Apo.Man.Soli: STECH CHRISTOF ALEXANDER. Apo.Sol.: ALVAREZ LORENZOJORGE. Apo.Manc.: ALVAREZ LORENZO JORGE. Datos registrales. T 9810 , F 225, S 8, H M 157540, I/A 64 ( 6.05.22).

11 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PORTILLO MONTES RAQUEL. Datos registrales. T 9810 , F 224, S 8, H M 157540, I/A 63 (

26 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: YRJOENMAEKI MINNA HELMI SALOME. Presidente: YRJOENMAEKI MINNA HELMI SALOME.Nombramientos. Consejero: MELKKO MARKUS KRISTIAN. Presidente: MELKKO MARKUS KRISTIAN. Datos registrales. T 9810 ,F 224, S 8, H M 157540, I/A 62 (19.04.22).

27 de Abril de 2021
Cambio de domicilio social. AVDA LEONARDO DA VINCI 15-17-19 - PARQUE EMPRESARI (GETAFE). Datos registrales. T 9810, F 224, S 8, H M 157540, I/A 61 (20.04.21).

24 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9810 , F 223, S 8,H M 157540, I/A 60 (17.12.20).

28 de Mayo de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: ZION CLAUDIO EDUARDO;ALVAREZ LORENZO JORGE;AVILA SANZ LAURA. Datos registrales. T9810 , F 223, S 8, H M 157540, I/A 59 (21.05.20).

10 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: HARKKI REETA ELINA;AHLMARK ANNAMARI ELINA. Presidente: HARKKI REETA ELINA.Vicepresid.: AHLMARK ANNAMARI ELINA. Nombramientos. Consejero: YRJOENMAEKI MINNA HELMI SALOME;HARKKI REETAELINA. Presidente: YRJOENMAEKI MINNA HELMI SALOME. Vicepresid.: HARKKI REETA ELINA. Datos registrales. T 9810 , F 223,S 8, H M 157540, I/A 58 ( 3.03.20).

16 de Mayo de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: STRANDBERG MAIJA KAARINA. Presidente: STRANDBERG MAIJA KAARINA. Consejero: HARKKIREETA ELINA. Vicepresid.: HARKKI REETA ELINA. Nombramientos. Consejero: HARKKI REETA ELINA;AHLMARK ANNAMARIELINA. Presidente: HARKKI REETA ELINA. Vicepresid.: AHLMARK ANNAMARI ELINA. Datos registrales. T 9810 , F 222, S 8, H M157540, I/A 57 ( 8.05.19).

26 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Secretario: CODORNIU Y GONZALEZ VILLAZON RICARDO. VsecrNoConsj: CODORNIU AGUILAR ALFONSO.Revocaciones. Apoderado: ROSES FERNANDEZ FERNANDO. Nombramientos. Secretario: CODORNIU AGUILAR ALFONSO.Datos registrales. T 9810 , F 222, S 8, H M 157540, I/A 56 (18.12.18).

28 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ LORENZO JORGE;AVILA SANZ LAURA. Datos registrales. T 9810 , F 222, S 8, H M 157540,I/A 55 (20.11.18).

25 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9810 , F 221, S 8, H M 157540, I/A 54 (17.10.18).

20 de Agosto de 2018
Reelecciones. Consejero: HARKKI REETA ELINA. Vicepresid.: HARKKI REETA ELINA. Datos registrales. T 9810 , F 221, S 8, H M157540, I/A 53 ( 8.08.18).

06 de Febrero de 2018
Cambio de domicilio social. SENDA DE LA CHIVIRINA S/N - ANTIGUA CARRETERA DE E (MOSTOLES). Datos registrales. T9810 , F 221, S 8, H M 157540, I/A 52 (30.01.18).

04 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARJAANA PALOMAKI RIITTA. Presidente: MARJAANA PALOMAKI RIITTA. Nombramientos.Consejero: STRANDBERG MAIJA KAARINA. Presidente: STRANDBERG MAIJA KAARINA. Datos registrales. T 9810 , F 221, S 8, HM 157540, I/A 51 (28.08.17).

10 de Abril de 2017
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION;GOMEZ PILARES INMACULADACONCEPCION;GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION. Apo.Man.Soli: GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION.Apo.Manc.: GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION. Apo.Sol.: GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION. Apoderado:VILHUNEN JANNE MARCUS. Apo.Manc.: GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION;GOMEZ PILARES INMACULADACONCEPCION;GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION. Apoderado: VILHUNEN JANNE MARCUS;GOMEZ PILARESINMACULADA CONCEPCION;VILHUNEN JANNE MARCUS;GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION. Apo.Manc.:VILHUNEN JANNE MARKUS;GOMEZ PILARES INMACULADA CONCEPCION. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AVILA SANZ

03 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: VILHUNEN JANNE MARKUS. Nombramientos. Consejero: ZION CLAUDIO EDUARDO. Datosregistrales. T 9810 , F 219, S 8, H M 157540, I/A 49 (24.03.17).

06 de Mayo de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9810 , F 219, S 8, H M 157540, I/A 48 (26.04.16).

14 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: ENGUIDANOS RAMOS ELENA. Apo.Sol.: ENGUIDANOS RAMOS ELENA. Apo.Manc.: ENGUIDANOSRAMOS ELENA. Apoderado: ENGUIDANOS RAMOS ELENA;ENGUIDANOS RAMOS ELENA. Apo.Manc.: ENGUIDANOS RAMOSELENA. Datos registrales. T 9810 , F 219, S 8, H M 157540, I/A 47 ( 6.04.15).

02 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: ZION CLAUDIO EDUARDO. Apo.Manc.: ZION CLAUDIO EDUARDO;ROSES FERNANDEZFERNANDO;STECH CHRISTOF ALEXANDER;VILHUNEN JANNE MARKUS;ENGUIDANOS RAMOS ELENA;GOMEZ PILARESINMACULADA. Datos registrales. T 9810 , F 218, S 8, H M 157540, I/A 46 (23.05.14).

09 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: ROSES FERNANDEZ FERNANDO;STECH CHRISTOF ALEXANDER;VILHUNEN JANNEMARCUS;ENGUIDANOS RAMOS ELENA;GOMEZ PILARES INMACULADA;VILHUNEN JANNE MARCUS;STECH CHRISTOFALEXANDER;ROSES FERNANDEZ FERNANDO;ENGUIDANOS RAMOS ELENA;GOMEZ PILARES INMACULADA. Datosregistrales. T 9810 , F 217, S 8, H M 157540, I/A 45 ( 1.04.14).

28 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANTA CRUZ ANGEL. Datos registrales. T 9810 , F 217, S 8, H M 157540, I/A 44 (20.03.14).

28 de Agosto de 2013
Reelecciones. Consejero: HARKKI REETA ELINA. Vicepresid.: HARKKI REETA ELINA. Consejero: VILHUNEN JANNE MARKUS.Datos registrales. T 9810 , F 217, S 8, H M 157540, I/A 43 (20.08.13).

23 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9810 , F 216, S 8, H M 157540, I/A 42 (14.08.13).

28 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROSES FERNANDEZ FERNANDO. Presidente: ROSES FERNANDEZ FERNANDO.Nombramientos. Consejero: MARJAANA PALOMAKI RIITTA. Presidente: MARJAANA PALOMAKI RIITTA. Datos registrales. T9810 , F 216, S 8, H M 157540, I/A 41 (18.01.13).

02 de Enero de 2012
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: UPONOR CORPORATION. Datos registrales. T 9810 , F 216, S 8,H M 157540, I/A 40 (21.12.11).

05 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 9810 , F 216, S 8, H M 157540, I/A 39 (25.10.10).

13 de Abril de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: ESCOLAN FERNANDEZ YOLANDA. Datos registrales. T 9810 , F 216, S 8, H M 157540, I/A 38(31.03.10).

04 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9810 , F 216, S 8, H M 157540, I/A 37 (21.12.09).

13 de Octubre de 2009
Reelecciones. Consejero: ROSES FERNANDEZ FERNANDO. Presidente: ROSES FERNANDEZ FERNANDO. Datos registrales. T9810 , F 215, S 8, H M 157540, I/A 36 (30.09.09).

20 de Enero de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANTA CRUZ ANGEL. Apo.Manc.: ROSES FERNANDEZ FERNANDO;GOMEZ PILARESINMACULADA;ENGUIDANOS RAMOS ELENA. Datos registrales. T 9810 , F 215, S 8, H M 157540, I/A 35 ( 9.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información