Actos BORME de Urbanizadora Badajoz Sociedad Anonima
28 de Julio de 2022Reelecciones. Auditor: JUAN ANTONIO MONTERREY MAYORAL. Aud.Supl.: BEATRIZ GIL SANCHEZ. Datos registrales. T 611 ,F 195, S 8, H BA 2046, I/A 62 . (17.02.22).
24 de Febrero de 2022Nombramientos. Aud.Supl.: BEATRIZ GIL SANCHEZ. Auditor: JUAN ANTONIO MONTERREY MAYORAL. Datos registrales. T 611, F 195, S 8, H BA 2046, I/A 62 (17.02.22).
30 de Septiembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 195.679,59 Euros. Resultante Suscrito: 1.761.176,41 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los Estatutos : 6. Capital. Datos registrales. T 611 , F 194, S 8, H BA 2046, I/A 61 (23.09.21).
29 de Diciembre de 2020Modificaciones estatutarias. 30. Administraci贸n y Representacion. Datos registrales. T 611 , F 193, S 8, H BA 2046, I/A 59(21.12.20).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CARLOS MARIA LUNA MARTINEZ;JESUS LISARDO SANCHEZPARE;LUNA MARTINEZ ANTONIO;RODRIGUEZ ROYO FERNANDO;VICENTE SANCHEZ PARE. Secretario: LUNA MARTINEZANTONIO. Presidente: VICENTE SANCHEZ PARE. Nombramientos. Consejero: VICENTE SANCHEZ PARE. Presidente: VICENTESANCHEZ PARE. Consejero: ANTONIO LUNA MARTINEZ. Secretario: ANTONIO LUNA MARTINEZ. Consejero: JESUS LISARDOSANCHEZ PARE;CARLOS MARIA LUNA MARTINEZ;FERNANDO JAVIER RODRIGUEZ ROYO. Datos registrales. T 611 , F 194, S8, H BA 2046, I/A 60 (21.12.20).
28 de Diciembre de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PROMOCIONES SANCHA BRAVA S.A. Datos registrales. T 611 , F 192, S 8, H BA2046, I/A 58 (21.12.15).
06 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ CUADRADO VICENTE;LUNA GORDILLO ANTONIO. Presidente: SANCHEZ CUADRADOVICENTE. Secretario: LUNA GORDILLO ANTONIO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ PARE JESUS LISARDO;LUNAMARTINEZ CARLOS. Presidente: SANCHEZ PARE VICENTE. Secretario: LUNA MARTINEZ ANTONIO. Reelecciones. Consejero:RODRIGUEZ ROYO FERNANDO;LUNA MARTINEZ ANTONIO;SANCHEZ PARE VICENTE. Datos registrales. T 611 , F 191, S 8, HBA 2046, I/A 57 (29.09.15).
26 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ PARE PABLO;SANCHEZ PARE JESUS LISARDO;RODRIGUEZ PINILLALUCIA;RODRIGUEZ PINILLA FERNANDO;LUNA MARTINEZ ANTONIO;LUNA MARTINEZ CARLOS;SANCHEZ PARE CARLOS.Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ PARE CARLOS;SANCHEZ PARE JESUS LISARDO;RODRIGUEZ PINILLAFERNANDO;SANCHEZ PARE PABLO;RODRIGUEZ PINILLA LUCIA;GARCIA GIL MARTIN;LUNA MARTINEZ ANTONIO;LUNAMARTINEZ CARLOS. Datos registrales. T 553 , F 30, S 8, H BA 2046, I/A 56 (19.06.15).
05 de Enero de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: JARDINES DE VALVERDE S.A. Datos registrales. T 553 , F 29, S 8, H BA 2046,I/A 55 (24.12.14).
11 de Julio de 2014Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 126.515,31 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6.Capital.-. Datos registrales. T 553 , F 28, S 8, H BA 2046, I/A 54 ( 4.07.14).
01 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ PARE CARLOS. Datos registrales. T 553 , F 28, S 8, H BA 2046, I/A 53 (25.03.14).
03 de Julio de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 316.288,27 Euros. Desembolsado: 189.772,96 Euros. Resultante Suscrito: 1.565.496,82 Euros.Resultante Desembolsado: 1.438.981,51 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datosregistrales. T 553 , F 27, S 8, H BA 2046, I/A 52 (26.06.13).
30 de Enero de 2013Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 107.176,34 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6.Capital.-. Datos registrales. T 553 , F 26, S 8, H BA 2046, I/A 51 (23.01.13).
19 de Noviembre de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 15.872,41 Euros. Resultante Suscrito: 1.249.208,55 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 486 , F 95, S 8, H BA 2046, I/A 49 ( 7.11.12).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 123.048,74 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6.Capital.-. Datos registrales. T 553 , F 26, S 8, H BA 2046, I/A 50 ( 7.11.12).
23 de Abril de 2012Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 246.097,48 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6.Capital.-. Datos registrales. T 486 , F 95, S 8, H BA 2046, I/A 48 (12.04.12).
21 de Febrero de 2012Modificaciones estatutarias. 12. Funcionamiento Junta Gral.-. 22. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 486 , F 94, S8, H BA 2046, I/A 47 (10.02.12).
19 de Octubre de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 246.097,48 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6.Capital.-. Datos registrales. T 486 , F 94, S 8, H BA 2046, I/A 46 ( 7.10.11).
03 de Agosto de 2011Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 9.398,13 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6.Capital.-. Datos registrales. T 486 , F 94, S 8, H BA 2046, I/A 45 (25.07.11).
04 de Abril de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ PINILLA LUCIA;SANCHEZ PARE JESUS LISARDO;LUNA MARTINEZ ANTONIO.Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ PARE JESUS LISARDO;SANCHEZ PARE PABLO;RODRIGUEZ PINILLAFERNANDO;RODRIGUEZ PINILLA LUCIA;LUNA MARTINEZ ANTONIO;LUNA MARTINEZ CARLOS. Datos registrales. T 486 , F 93,S 8, H BA 2046, I/A 44 (24.03.11).
19 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ CUADRADO VICENTE;SANCHEZ PARE VICENTE;LUNA GORDILLO ANTONIO;LUNAMARTINEZ ANTONIO;LUNA MARTINEZ CARLOS;RODRIGUEZ ROYO FERNANDO;RODRIGUEZ PINILLA LUCIA;SANCHEZCUADRADO FERNANDO;MINGARRO VAZQUEZ RAFAEL. Presidente: SANCHEZ CUADRADO VICENTE. Cons.Del.Man: SANCHEZPARE VICENTE;LUNA MARTINEZ ANTONIO;RODRIGUEZ ROYO FERNANDO. Secretario: LUNA GORDILLO ANTONIO. Consejero:SANCHEZ PARE JESUS LISARDO. Nombramientos. Presidente: SANCHEZ CUADRADO VICENTE. Consejero: LUNA GORDILLOANTONIO. Secretario: LUNA GORDILLO ANTONIO. Consejero: RODRIGUEZ ROYO FERNANDO;LUNA MARTINEZANTONIO;SANCHEZ PARE VICENTE;SANCHEZ CUADRADO VICENTE. Modificaciones estatutarias. 23. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 486 , F 92, S 8, H BA 2046, I/A 43 (10.01.11).
31 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ PARE CARLOS. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ PARE JESUS LISARDO.Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 996.920,77 Euros. Desembolsado: 249.230,19 Euros. Resultante Suscrito: 1.265.080,96 Euros.Resultante Desembolsado: 517.390,38 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos
17 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES PILES SILVIA. Cons.Del.Man: TORRES PILES SILVIA. Consejero: TORRES PIZARROJOSE LUIS. Datos registrales. T 486 , F 91, S 8, H BA 2046, I/A 41 ( 8.02.10).
08 de Febrero de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: LUNA MARTINEZ ANTONIO;SANCHEZ CUADRADO FERNANDO;SANCHEZ PARE JESUS LISARDO.Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ PINILLA LUCIA;LUNA MARTINEZ ANTONIO;SANCHEZ PARE JESUS LISARDO. Datosregistrales. T 64, L 1, F 165, S 8, H BA 2046, I/A 40 (28.01.10).
17 de Julio de 2009Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ PARE CARLOS;SANCHEZ CUADRADO FERNANDO;LUNA MARTINEZ ANTONIO;TORRESPILES SILVIA;RODRIGUEZ PINILLA LUCIA. Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ CUADRADO FERNANDO;LUNA MARTINEZANTONIO;SANCHEZ PARE JESUS LISARDO. Datos registrales. T 64, L 1, F 165, S 8, H BA 2046, I/A 39 ( 8.07.09).
12 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: TORRES PIZARRO JOSE LUIS. Nombramientos. Secretario: LUNA GORDILLO ANTONIO. Datosregistrales. T 64, L 1, F 135, S 8, H BA 2046, I/A 38 ( 3.02.09).