Actos BORME de Urbanizadora Benny Sa
07 de Noviembre de 2022Reelecciones. Consejero: SOAJE CRESPO MARIA JOSEFINA. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 148, S 8, H PO 48504, I/A 29(27.10.22).
09 de Diciembre de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS;PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES.Presidente: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Secretario: PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES. Nombramientos. Consejero:PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES. Presidente: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Secretario: PEREZ CRESPO MARIAMERCEDES. Consejero: PEREZ CRESPO JOSE CARLOS;PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Datos registrales. T 3579, L 3579, F147, S 8, H PO 48504, I/A 27 (27.11.20).
Nombramientos. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL. Aud.Supl.: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDADLIMITAD. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 147, S 8, H PO 48504, I/A 28 (27.11.20).
22 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Nombramientos. Consejero: SOAJE CRESPO MARIAJOSEFINA. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 147, S 8, H PO 48504, I/A 26 (11.10.18).
27 de Junio de 2018Otros conceptos: Se modifica el ARTICULO 10潞 de los Estatutos Sociales relativo a la CONVOCATORIA, CONSTITUCION YADOPCION DE ACUERDOS de la Junta general. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 146, S 8, H PO 48504, I/A 25 (20.06.18).
13 de Febrero de 2018Nombramientos. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 146, S 8, H PO 48504, I/A 24 ( 5.02.18).
29 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ CRESPO FERNANDO. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 146, S 8, H PO 48504, I/A 23(20.12.17).
24 de Octubre de 2017Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO FERNANDO;CRESPO TORRES MARIA DELPILAR;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DELPILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO MARIAMERCEDES;PEREZ CRESPO MARIA RAMOS;PEREZ CRESPO FERNANDO;SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Presidente:PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Secretario: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 144, S 8,H PO 48504, I/A 20 (17.10.17).
Ceses/Dimisiones. Secretario: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Nombramientos. Secretario: PEREZ CRESPO MARIAMERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 145, S 8, H PO 48504, I/A 21 (17.10.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS;PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 3579,L 3579, F 145, S 8, H PO 48504, I/A 22 (17.10.17).
07 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ CRESPO BERNARDINO. Nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO FERNANDO.Datos registrales. T 3579, L 3579, F 144, S 8, H PO 48504, I/A 19 (28.09.15).
10 de Abril de 2014Nombramientos. Consejero: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Reelecciones. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DELPILAR;PEREZ CRESPO BERNARDINO;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR.Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 144, S 8, H PO 48504, I/A 18 ( 1.04.14).
02 de Febrero de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 73.026,71 Euros. Resultante Suscrito: 61.600,00 Euros. Datos registrales. T 3579, L3579, F 143, S 8, H PO 48504, I/A 17 (24.01.12).
04 de Mayo de 2011Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 33.656,68 Euros. Resultante Suscrito: 134.626,71 Euros. Datos registrales. T 3579, L3579, F 143, S 8, H PO 48504, I/A 16潞 (19.04.11).
09 de Febrero de 2011Cambio de domicilio social. C/ URUGUAY 6 2潞 DEREC (VIGO). Datos registrales. T 3579, L 3579, F 143, S 8, H PO 48504, I/A 15(27.01.11).
15 de Octubre de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.207,08 Euros. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 142, S 8, H PO 48504,I/A 14 ( 4.10.10).
13 de Julio de 2010Otros conceptos: Rectifican el error cometido al redactar la certificaci贸n inserta en la escritura que motiv贸 la inscripci贸n 12&, en elsentido de que la aceptaci贸n al cargo de Consejero de D. Bernardino P茅rez Crespo lo es desde el d铆a 30 de abril de 2010. Fe deerratas: Rectifican el error cometido al redactar la certificaci贸n inserta en la escritura que motiv贸 la inscripci贸n 12&, en el sentido deque la aceptaci贸n al cargo de Consejero de D. Bernardino P茅rez Crespo lo es desde el d铆a 30 deabril de 2010. Datos registrales. T3579, L 3579, F 142, S 8, H PO 48504, I/A 13 ( 1.07.10).
26 de Octubre de 2009Adaptaci贸n de sociedad. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES.Consejero: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIADEL PILAR. Consejero: CRESPO TORRES DOLORES. Nombramientos. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DELPILAR;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;CRESPO TORRES DOLORESPresidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR.Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Con.Delegado: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T3579, L 3579, F 140, S 8, H PO 48504, I/A 10 (15.10.09).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Secretario: CRESPO TORRESMARIA MERCEDES. Consejero: CRESPO TORRES DOLORES;CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Con.Delegado: CRESPOTORRES MARIA DEL PILAR. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Consejero: CRESPO TORRESMARIA DEL PILAR;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;CRESPO TORRES DOLORESPresidente: CRESPO TORRES MARIADEL PILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 141, S 8, H PO 48504, I/A 11(15.10.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES.Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR;CRESPO TORRESDOLORES. Nombramientos. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR;PEREZ CRESPO BERNARDINO;CRESPOTORRES MARIA MERCEDES. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIAMERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 142, S 8, H PO 48504, I/A 12 (15.10.09).