Buscador CIF Logo

Actos BORME Urbanizadora Benny Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Urbanizadora Benny Sa

Actos BORME Urbanizadora Benny Sa - A36618726

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Urbanizadora Benny Sa con CIF A36618726

馃敊 Perfil de Urbanizadora Benny Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Urbanizadora Benny Sa

07 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Consejero: SOAJE CRESPO MARIA JOSEFINA. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 148, S 8, H PO 48504, I/A 29(27.10.22).

09 de Diciembre de 2020
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS;PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES.Presidente: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Secretario: PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES. Nombramientos. Consejero:PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES. Presidente: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Secretario: PEREZ CRESPO MARIAMERCEDES. Consejero: PEREZ CRESPO JOSE CARLOS;PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Datos registrales. T 3579, L 3579, F147, S 8, H PO 48504, I/A 27 (27.11.20).

Nombramientos. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL. Aud.Supl.: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOCIEDADLIMITAD. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 147, S 8, H PO 48504, I/A 28 (27.11.20).

22 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Nombramientos. Consejero: SOAJE CRESPO MARIAJOSEFINA. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 147, S 8, H PO 48504, I/A 26 (11.10.18).

27 de Junio de 2018
Otros conceptos: Se modifica el ARTICULO 10潞 de los Estatutos Sociales relativo a la CONVOCATORIA, CONSTITUCION YADOPCION DE ACUERDOS de la Junta general. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 146, S 8, H PO 48504, I/A 25 (20.06.18).

13 de Febrero de 2018
Nombramientos. Auditor: DE LA CALLE AMARO MIGUEL RAMON. Aud.Supl.: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORESSOCIEDAD LIMITAD. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 146, S 8, H PO 48504, I/A 24 ( 5.02.18).

29 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ CRESPO FERNANDO. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 146, S 8, H PO 48504, I/A 23(20.12.17).

24 de Octubre de 2017
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO FERNANDO;CRESPO TORRES MARIA DELPILAR;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DELPILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO MARIAMERCEDES;PEREZ CRESPO MARIA RAMOS;PEREZ CRESPO FERNANDO;SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Presidente:PEREZ CRESPO MARIA RAMOS. Secretario: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 144, S 8,H PO 48504, I/A 20 (17.10.17).

Ceses/Dimisiones. Secretario: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Nombramientos. Secretario: PEREZ CRESPO MARIAMERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 145, S 8, H PO 48504, I/A 21 (17.10.17).

Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ CRESPO MARIA RAMOS;PEREZ CRESPO MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 3579,L 3579, F 145, S 8, H PO 48504, I/A 22 (17.10.17).

07 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ CRESPO BERNARDINO. Nombramientos. Consejero: PEREZ CRESPO FERNANDO.Datos registrales. T 3579, L 3579, F 144, S 8, H PO 48504, I/A 19 (28.09.15).

10 de Abril de 2014
Nombramientos. Consejero: SOAJE CRESPO FERNANDA AMELIA. Reelecciones. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DELPILAR;PEREZ CRESPO BERNARDINO;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR.Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 144, S 8, H PO 48504, I/A 18 ( 1.04.14).

02 de Febrero de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 73.026,71 Euros. Resultante Suscrito: 61.600,00 Euros. Datos registrales. T 3579, L3579, F 143, S 8, H PO 48504, I/A 17 (24.01.12).

04 de Mayo de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 33.656,68 Euros. Resultante Suscrito: 134.626,71 Euros. Datos registrales. T 3579, L3579, F 143, S 8, H PO 48504, I/A 16潞 (19.04.11).

09 de Febrero de 2011
Cambio de domicilio social. C/ URUGUAY 6 2潞 DEREC (VIGO). Datos registrales. T 3579, L 3579, F 143, S 8, H PO 48504, I/A 15(27.01.11).

15 de Octubre de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.207,08 Euros. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 142, S 8, H PO 48504,I/A 14 ( 4.10.10).

13 de Julio de 2010
Otros conceptos: Rectifican el error cometido al redactar la certificaci贸n inserta en la escritura que motiv贸 la inscripci贸n 12&, en elsentido de que la aceptaci贸n al cargo de Consejero de D. Bernardino P茅rez Crespo lo es desde el d铆a 30 de abril de 2010. Fe deerratas: Rectifican el error cometido al redactar la certificaci贸n inserta en la escritura que motiv贸 la inscripci贸n 12&, en el sentido deque la aceptaci贸n al cargo de Consejero de D. Bernardino P茅rez Crespo lo es desde el d铆a 30 deabril de 2010. Datos registrales. T3579, L 3579, F 142, S 8, H PO 48504, I/A 13 ( 1.07.10).

26 de Octubre de 2009
Adaptaci贸n de sociedad. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES.Consejero: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIADEL PILAR. Consejero: CRESPO TORRES DOLORES. Nombramientos. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DELPILAR;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;CRESPO TORRES DOLORESPresidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR.Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Con.Delegado: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T3579, L 3579, F 140, S 8, H PO 48504, I/A 10 (15.10.09).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Secretario: CRESPO TORRESMARIA MERCEDES. Consejero: CRESPO TORRES DOLORES;CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Con.Delegado: CRESPOTORRES MARIA DEL PILAR. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Consejero: CRESPO TORRESMARIA DEL PILAR;CRESPO TORRES MARIA MERCEDES;CRESPO TORRES DOLORESPresidente: CRESPO TORRES MARIADEL PILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 141, S 8, H PO 48504, I/A 11(15.10.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES. Secretario: CRESPO TORRES MARIA MERCEDES.Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR;CRESPO TORRESDOLORES. Nombramientos. Consejero: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR;PEREZ CRESPO BERNARDINO;CRESPOTORRES MARIA MERCEDES. Presidente: CRESPO TORRES MARIA DEL PILAR. Secretario: CRESPO TORRES MARIAMERCEDES. Datos registrales. T 3579, L 3579, F 142, S 8, H PO 48504, I/A 12 (15.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n