Actos BORME de Urbanizadora La Cova Sl
09 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Apoderado: SANTOLARIA ARTERO JUAN JOSE. Apo.Sol.: SANTOLARIA ARTERO JUAN JOSE. Datosregistrales. T 10421, L 7702, F 150, S 8, H V 56323, I/A 28 ( 2.06.22).
18 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Apoderado: JULIAN MATEU RUBEN. Apo.Sol.: JULIAN MATEU RUBEN. Datos registrales. T 10421, L 7702, F149, S 8, H V 56323, I/A 27 (11.03.22).
15 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: MUÑOZ BLASCO JUAN SALVADOR. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 147, S 8, H V 56323, I/A25 ( 7.12.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LLOPIS MAGRANER FRANCISCO. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 147, S 8, H V 56323, I/A26 ( 7.12.21).
01 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAMBLA MOLINOS JOSE CARLOS;GIL VALLES OSCAR LUIS;JULIAN MATEU RUBEN. Apo.Sol.:SANTOLARIA ARTERO JUAN JOSE. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 147, S 8, H V 56323, I/A 24 (24.11.21).
03 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Apoderado: CATALAN CATALAN ESMERALDO. Apo.Man.Soli: CATALAN CATALAN ESMERALDO. Datosregistrales. T 10421, L 7702, F 147, S 8, H V 56323, I/A 23 (26.11.20).
20 de Junio de 2019Revocaciones. Apoderado: GARCIA CAMPA IGNACIO;MARCH VAZQUEZ JOSE BENITO. Datos registrales. T 10421, L 7702, F147, S 8, H V 56323, I/A 22 (13.06.19).
09 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA CABRERA DIEGO. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 146, S 8, H V 56323, I/A 21 (2.04.19).
28 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: LLOPIS MAGRANER FRANCISCO;MUÑOZ BLASCO JUAN SALVADOR. Apo.Sol.: JULIAN MATEURUBEN;SANTOLARIA ARTERO JUAN JOSE. Apo.Man.Soli: CATALAN CATALAN ESMERALDO. Datos registrales. T 5885, L 3191,F 194, S 8, H V 56323, I/A 20 (21.02.18).
22 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: SANTOLARIA ARTERO JUAN JOSE. Datos registrales. T 5885, L 3191, F 193, S 8, H V 56323, I/A19 (15.09.16).
08 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Apoderado: MARTINEZ TENA MILAGROS. Datos registrales. T 5885, L 3191, F 193, S 8, H V 56323, I/A 18(29.04.14).
08 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: JULIAN MATEU RUBEN. Datos registrales. T 5885, L 3191, F 192, S 8, H V 56323, I/A 17 ( 1.08.13).
12 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLLER SANZ JUAN ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: CALVIGA SL. Otros conceptos:DON FRANCISCO VICENTE GASCON GRINES es designado persona física representante de la mercantil CALVIGA, SL para elejercicio del cargo de Administrador único . Datos registrales. T 5885, L 3191, F 192, S 8, H V 56323, I/A 16 ( 5.07.13).
12 de Julio de 2012Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR FERRAN 2 1º (VALENCIA). Datos registrales. T 5885, L 3191, F 192, S 8, H V 56323, I/A15 ( 3.07.12).
12 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: MARCH VAZQUEZ JOSE BENITO. Datos registrales. T 5885, L 3191, F 192, S 8, H V 56323, I/A 14 (3.02.10).
20 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Apoderado: MARCO MUÑOZ ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 5885, L 3191, F 191, S 8, H V 56323, I/A 13(11.01.10).
26 de Noviembre de 2009Cambio de domicilio social. PASEO DE LA ALAMEDA 34 5 (VALENCIA). Datos registrales. T 5885, L 3191, F 191, S 8, H V56323, I/A 12 (17.11.09).