Actos BORME de Vaersa Valenciana De Aprovechamiento Energetico De Residuos Sa
02 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Secretario: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA. Consejero: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA.Nombramientos. Consejero: JUAN ALCOCER ENRIC. Secretario: JUAN ALCOCER ENRIC. Datos registrales. T 9987, L 7269, F173, S 8, H V 25192, I/A 109 (23.02.23).
01 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Subdirec: MARCO LOPEZ JOSE MANUEL. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA FERRER FERRANVICENT;MARCO LOPEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Subdirec: ROCA URDANGARIN MIGUEL. Apo.Man.Soli: RAMON PAULJUAN MANUEL;ROCA URDANGARIN MIGUEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 171, S 8, H V 25192, I/A 108 (25.01.23).
17 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ ROCHER BENJAMIN;FERRIZ SORIANO VICENTE. Nombramientos. Consejero: GOMEZVIVO JULIO RAMON;BELMONTE SANCHEZ TERESA MARIA. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 170, S 8, H V 25192, I/A 106(10.01.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOLLA HERRERA MIREIA;TUZON MARCO PAULA;BELMONTE SANCHEZ TERESA MARIA.Presidente: MOLLA HERRERA MIREIA. Vicepr.1: TUZON MARCO PAULA. Nombramientos. Consejero: NAVARRO CASILLASISAURA. Presidente: NAVARRO CASILLAS ISAURA. Consejero: CANDELA PINA FRANCISCO JOSE;HERNANDEZ SAEZ JOSEJOAQUIN. Vicepr.1: CANDELA PINA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 171, S 8, H V 25192, I/A 107(10.01.23).
15 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DIEZ ANTONIO VICENTE. Secretario: GARCIA DIEZ ANTONIO VICENTE.Nombramientos. Consejero: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA. Secretario: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA.Datos registrales. T 9987, L 7269, F 170, S 8, H V 25192, I/A 105 ( 4.10.21).
13 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: QUESADA FERRE FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;CERDAN BARCELOFULGENCIO JOSE. Vicepr.2: RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: PEREZ ROCHERBENJAMIN;QUINTANA MARTINEZ ANTONIO;FERRIZ SORIANO VICENTE. Vicepr.2: LLANES RIBAS ROGELIO. Datos registrales.T 9987, L 7269, F 169, S 8, H V 25192, I/A 103 ( 7.05.21).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARCO LOPEZ JOSEMANUEL;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Dir. General: GARCIA FERRER FERRAN VICENT. Apo.Man.Soli:GARCIA FERRER FERRAN VICENT;MARCO LOPEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 169, S 8, H V 25192, I/A104 ( 7.05.21).
10 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Aud.C.Con.: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos
12 de Febrero de 2020Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 9987, L7269, F 168, S 8, H V 25192, I/A 101 ( 5.02.20).
10 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CEBRIAN CALVO ELENA;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;MORATAL SASTRE JOSE;MARZOPASTOR ANTONI;ALVAREZ ALONSO DELIA;LLANES RIBAS ROGELIO;PUNCEL CHORNET ALFONSO. Presidente: CEBRIANCALVO ELENA. Vicepresid.: RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO. Consejero: PIQUER HUERGA JOAN;IRANZO NAVARROANDREU;QUESADA FERRE FRANCISCO JAVIER;CHAFER NACHER MARIA TERESA. Vicepresid.: QUESADA FERREFRANCISCO JAVIER. Secretario: MORATAL SASTRE JOSE. Vicesecret.: CHAFER NACHER MARIA TERESA. Consejero:CASTELLO GARCIA ISABEL;PINEDA CUENCA MANUEL. Nombramientos. Consejero: MOLLA HERRERA MIREIA;GARCIA DIEZANTONIO VICENTE;TUZON MARCO PAULA;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;MARIN FABRA DIEGO;CHAFER NACHER
08 de Agosto de 2019Cambio de objeto social. La Sociedad tendr谩 como objeto: 1.- La construcci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento,valorizaci贸n o eliminaci贸n de cualquier tipo de residuos, as铆 como su gesti贸n, recogida, transporte, almacenamiento, dep贸sito,tratamiento, reciclaje, transformaci贸n y eliminaci贸n, la comercializaci. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 155, S 8, H V 25192, I/A99 ( 1.08.19).
21 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Nombramientos. Consejero: CASTELLO GARCIAISABEL;PINEDA CUENCA MANUEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 155, S 8, H V 25192, I/A 98 (14.02.19).
18 de Diciembre de 2018P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 154, S 8, H V 25192, I/A 95 (11.12.18).
Revocaciones. Apoderado: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Subdirec: MARCO LOPEZ JOSE MANUEL.Apo.Man.Soli: MARCO LOPEZ JOSE MANUEL;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 154, S 8, H V25192, I/A 96 (11.12.18).
24 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARO PRAT JULIA;PERIS NAVARRO ENRIQUE. Vicesecret.: MORATAL SASTRE JOSE.Consejero: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Vicepresid.: ALVARO PRAT JULIA. Secretario: PERIS NAVARRO ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: QUESADA FERRE FRANCISCO JAVIER;CHAFER NACHER MARIA TERESA. Vicepresid.: QUESADAFERRE FRANCISCO JAVIER. Secretario: MORATAL SASTRE JOSE. Vicesecret.: CHAFER NACHER MARIA TERESA. Consejero:POYATOS LEON JUAN ANGEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 153, S 8, H V 25192, I/A 94 (17.09.18).
06 de Marzo de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4.999.719,00 Euros. Desembolsado: 4.999.719,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.670.129,00 Euros.Resultante Desembolsado: 19.670.129,00 Euros. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 153, S 8, H V 25192, I/A 93 (27.02.18).
19 de Octubre de 2017Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 152, S 8, H V 25192, I/A 92(11.10.17).
09 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Dir. General: GARCIA LLORENS VICENT. Subdirec: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Revocaciones.Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Dir. General: MACEDA LOPEZBENJAMIN. Apoderado: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 151, S 8, H V 25192, I/A 91 ( 2.10.17).
05 de Octubre de 2017Nombramientos. Dir. General: GARCIA LLORENS VICENT. Otros conceptos: El 煤nico accionista el d铆a 13/05/2.016 y previamodificaci贸n del art铆culo 21潞 de los Estatutos Sociales redactado en los t茅rminos que figuran en la inscripci贸n 84陋, acord贸 RATIFICARY/O CONVALIDAR EL NOMBRAMIENTO DE DON VICENT GARCIA I LLORENS, como DIRECTOR GENERAL efectuado por elconsejo de admin. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 151, S 8, H V 25192, I/A 90 (28.09.17).
04 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ HERRERO MYRIAM DE LAS NIEVES. Nombramientos. Consejero: IRANZONAVARRO ANDREU. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 151, S 8, H V 25192, I/A 89 (27.09.17).
17 de Mayo de 2017Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 4 de los estatutos sociales.. Cambio de objeto social. 1.- Laconstrucci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorizaci贸n o eliminaci贸n de cualquier tipo de residuos, as铆 como sugesti贸n, recogida, transporte, almacenamiento, dep贸sito, tratamiento, reciclaje, transformaci贸n y eliminaci贸n, la comercializaci贸n yventa de los productos resu. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 150, S 8, H V 25192, I/A 88 ( 9.05.17).
04 de Mayo de 2017Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 9987, L7269, F 150, S 8, H V 25192, I/A 87 (25.04.17).
01 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAGO GIRALDOS MARIA. Nombramientos. Consejero: PIQUER HUERGA JOAN. Datosregistrales. T 9987, L 7269, F 149, S 8, H V 25192, I/A 85 (24.01.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CUENCA GARCIA ANGELES. D. Gerente: NIETO MOCHOLI JOSE. Revocaciones. Apoderado:BONO MARTINEZ EMERIT;CLIMENT ESPI JUAN VICENTE;BAYARRI LLORENS ANNA MARIA. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTREJOSE;SERRANO MATEO CRISTINA;URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES;ESPERT SILVESTRE JOSE;ESPERTSILVESTRE JOSE;TEJEDO TORMO VICENTE. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Datosregistrales. T 9987, L 7269, F 149, S 8, H V 25192, I/A 86 (24.01.17).
31 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MILLA JULIAN;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Cons.Del.Sol: MACEDA LOPEZ BENJAMIN.Consejero: GARCIA LLORENS VICENT. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT. Apo.Manc.: ESPERTSILVESTRE JOSE. Apo.Man.Soli: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Consejero: CUENCA GARCIA ANGELES.Subdirec: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Otros conceptos:MODIFICACION Y REFUNDICION DE ESTATUTOS. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.vaersa.com. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 146, S 8, H V 25192, I/A 84 (22.03.16).
02 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Vicesecret.: GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Secretario: PERALRIBELLES GASPAR. Consejero: BONIG TRIGUEROS ISABEL;PERAL RIBELLES GASPAR;VIESCA MARQUES JUAN;GONZALEZPRIETO ALFREDO;TEJEDO TORMO VICENTE;COMOS GUILLEM JOSE ALBERTO. Vicepresid.: TEJEDO TORMO VICENTE.Consejero: PRADAS TEN SALOME;GARCIA RIBOT PEDRO JAVIER. Cons.Del.Sol: TEJEDO TORMO VICENTE;GONZALEZ PRIETOALFREDO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: APARICIO GRAU JOSE. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTRE JOSE. Nombramientos.Consejero: CEBRIAN CALVO ELENA;ALVARO PRAT JULIA;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;PERIS NAVARROENRIQUE;MORATAL SASTRE JOSE;DIAGO GIRALDOS MARIA;MARZO PASTOR ANTONI. Apo.Man.Soli: MACEDA LOPEZBENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT;ESPERT SILVESTRE JOSE. Consejero: ALVAREZ ALONSO DELIA;LLANES RIBASROGELIO;FERNANDEZ HERRERO MYRIAM DE LAS NIEVES;LOPEZ MILLA JULIAN;PUNCEL CHORNET ALFONSO;MACEDALOPEZ BENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT. Cons.Del.Sol: MACEDA LOPEZ BENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT.Presidente: CEBRIAN CALVO ELENA. Vicepresid.: RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO. Secretario: PERIS NAVARRO ENRIQUE.Vicepresid.: ALVARO PRAT JULIA. Vicesecret.: MORATAL SASTRE JOSE. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 225, S 8, H V25192, I/A 82 (26.08.15).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GARCIA LLORENS VICENT. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MACEDA LOPEZBENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT;ESPERT SILVESTRE JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENSVICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTRE JOSE. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 145, S 8, H V25192, I/A 83 (26.08.15).
17 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: GONZALEZ PRIETO ALFREDO;TEJEDO TORMO VICENTE. Nombramientos. Cons.Del.Sol:TEJEDO TORMO VICENTE;GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 224, S 8, H V 25192, I/A 81(10.12.14).
09 de Diciembre de 2014Cambio de objeto social. 1. La construcci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorizaci贸n o eliminaci贸n de todotipo de residuos, as铆 como su gesti贸n, recogida, transporte, almacenamiento, dep贸sito, tratamiento, reciclaje, transformaci贸n yeliminaci贸n, la comercializaci贸n y venta de los productos resultante. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 224, S 8, H V 25192, I/A 80( 1.12.14).
28 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: SIMO ARNAU ENRIQUE;SIMO ARNAU ENRIQUE;SIMO ARNAU ENRIQUE. Apoderado: SIMO ARNAUENRIQUE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARICIO GRAU JOSE. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTRE JOSE. Datos registrales. T7551, L 4852, F 223, S 8, H V 25192, I/A 79 (21.11.14).
27 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Nombramientos. Cons.Del.Man: TEJEDO TORMOVICENTE;GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 223, S 8, H V 25192, I/A 78 (20.11.14).
12 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: VA脩O GIRONES JOAQUIN;BROSETA DUPRE BRUNO. Nombramientos. Consejero: PRADASTEN SALOME;GARCIA RIBOT PEDRO. Cambio de domicilio social. AVDA DE LES CORTS VALENCIANAS 20 2 (VALENCIA).Datos registrales. T 7551, L 4852, F 223, S 8, H V 25192, I/A 77 ( 4.11.14).
11 de Junio de 2014Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLC SL;AUREN AUDITORES ALC SL;AUREN AUDITORES BIO S.L.;AURENAUDITORS BCN S.A.;AUREN AUDITORES MAD S.L. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES VLC SL;AUREN AUDITORES ALCSL;AUREN AUDITORES BIO S.L.;AUREN AUDITORS BCN S.A.;AUREN AUDITORES MAD S.L. Datos registrales. T 7551, L 4852,F 222, S 8, H V 25192, I/A 76 ( 4.06.14).
13 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTORO BLASCO MARIA AMPARO. Nombramientos. Consejero: VA脩O GIRONES JOAQUIN.Datos registrales. T 7551, L 4852, F 222, S 8, H V 25192, I/A 75 ( 6.05.13).
25 de Febrero de 2013Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLC SL;AUREN AUDITORES ALC SL. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES VLCSL;AUREN AUDITORES ALC SL. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 73 (18.02.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENLLIURE MORENO JOSE MARIA;MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Vicepresid.: MU脩OZCRIADO MARIA ARANZAZU. Revocaciones. Apo.Manc.: MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Nombramientos. Consejero:COMOS GUILLEM JOSE ALBERTO. Vicepresid.: TEJEDO TORMO VICENTE. Apo.Manc.: SIMO ARNAU ENRIQUE;TEJEDO TORMOVICENTE. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 74 (18.02.13).
01 de Junio de 2012Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 7.500.480,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 5. Capital.-El capitalsocial se fija en la cantidad de catorce millones seiscientos setenta mil cuatrocientos diez euros -14670410-. Se halla dividido en244100 acciones de clase y serie 煤nica, de sesenta euros y diez c茅ntimos -60,10 euros-, de valor nominal cada una de ellas ynumeradas. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 72 (23.05.12).
22 de Agosto de 2011Revocaciones. Apoderado: ESPINOSA BOLA脩OS FELIPE. Nombramientos. Apoderado: SIMO ARNAU ENRIQUE. Apo.Manc.:SIMO ARNAU ENRIQUE;ESPERT SILVESTRE JOSE;SIMO ARNAU ENRIQUE;MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Datosregistrales. T 7551, L 4852, F 220, S 8, H V 25192, I/A 71 (10.08.11).
16 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: AMIGO SALVI PILAR;SERRANO MATEO CRISTINA. Secretario: SERRANO MATEO CRISTINA.Consejero: CENTENO CENTENO MARIA ANGELES;URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES;LAMPARERO LAZARO JORGEANTONIO;BENLLIURE MORENO JOSE MARIA;COTINO FERRER JUAN GABRIEL. Presidente: COTINO FERRER JUAN GABRIEL.Vicepresid.: URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES. Cons.Del.Sol: COTINO FERRER JUAN GABRIEL;URE脩A GUILLEMMARIA DE LOS ANGELES. Consejero: MONZO MARTINEZ EUSEBIO. Nombramientos. Presidente: BONIG TRIGUEROS ISABEL.Vicepresid.: MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Vicesecret.: GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Secretario: PERAL RIBELLESGASPAR. Consejero: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Con.Delegado: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Consejero: MU脩OZ CRIADOMARIA ARANZAZU;PERAL RIBELLES GASPAR;MONTORO BLASCO MARIA AMPARO;VIESCA MARQUES JUAN;GONZALEZPRIETO ALFREDO;TEJEDO TORMO VICENTE;BENLLIURE MORENO JOSE MARIA;BROSETA DUPRE BRUNO. Datosregistrales. T 7551, L 4852, F 220, S 8, H V 25192, I/A 70 ( 4.08.11).
21 de Diciembre de 2010Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 4 de los estatutos sociales.. Cambio de objeto social. 1.- Laconstrucci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorizaci贸n o eliminaci贸n de todo tipo de residuos, la recogida,transporte, almacenamiento, dep贸sito, tratamiento, reciclaje, transformaci贸n y eliminaci贸n, la comercializaci贸n y venta de los productosresultantes, as铆 como la .. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 219, S 8, H V 25192, I/A 69 (10.12.10).
30 de Julio de 2010Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES MEDITERRANEO SL;AUREN AUDITORES LEVANTE SL. Aud.C.Con.: AURENAUDITORES MEDITERRANEO SL;AUREN AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 219, S 8, H V 25192,I/A 68 (21.07.10).
06 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LANDECHO CAMPOS PABLO. Nombramientos. Consejero: MONZO MARTINEZ EUSEBIO.Cambio de domicilio social. C/ MARIANO CUBER 17 (VALENCIA). Datos registrales. T 7551, L 4852, F 219, S 8, H V 25192, I/A67 (25.06.10).
17 de Diciembre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 31.778.163,48 Euros. Resultante Suscrito: 4.669.770,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 10.000.640,00 Euros. Desembolsado: 2.500.160,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.670.410,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 7.169.930,00 Euros. Datos registrales. T 6547, L 3851, F 225, S 8, H V 25192, I/A 65 ( 7.12.09).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GARCIA ANTON JOSE RAMON. Consejero: GARCIA ANTON JOSE RAMON. Presidente:GARCIA ANTON JOSE RAMON. Vicepresid.: AMIGO SALVI PILAR. Nombramientos. Consejero: COTINO FERRER JUANGABRIEL. Presidente: COTINO FERRER JUAN GABRIEL. Vicepresid.: URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES. Cons.Del.Sol:COTINO FERRER JUAN GABRIEL;URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 6547, L 3851, F 225, S 8, HV 25192, I/A 66 ( 7.12.09).
12 de Marzo de 2009Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SOCIEDAD ANONIMA PROFESION. Aud.C.Con.: MOORE STEPHENSIBERGRUP SOCIEDAD ANONIMA PROFESION. Datos registrales. T 6547, L 3851, F 225, S 8, H V 25192, I/A 64 ( 3.03.09).