Buscador CIF Logo

Actos BORME Vaersa Valenciana De Aprovechamiento Energetico De Residuos Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Vaersa Valenciana De Aprovechamiento Energetico De Residuos Sa

Actos BORME Vaersa Valenciana De Aprovechamiento Energetico De Residuos Sa - A46299988

Tenemos registrados 45 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Vaersa Valenciana De Aprovechamiento Energetico De Residuos Sa con CIF A46299988

馃敊 Perfil de Vaersa Valenciana De Aprovechamiento Energetico De Residuos Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Vaersa Valenciana De Aprovechamiento Energetico De Residuos Sa

02 de Marzo de 2023
Ceses/Dimisiones. Secretario: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA. Consejero: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA.Nombramientos. Consejero: JUAN ALCOCER ENRIC. Secretario: JUAN ALCOCER ENRIC. Datos registrales. T 9987, L 7269, F173, S 8, H V 25192, I/A 109 (23.02.23).

01 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Subdirec: MARCO LOPEZ JOSE MANUEL. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA FERRER FERRANVICENT;MARCO LOPEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Subdirec: ROCA URDANGARIN MIGUEL. Apo.Man.Soli: RAMON PAULJUAN MANUEL;ROCA URDANGARIN MIGUEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 171, S 8, H V 25192, I/A 108 (25.01.23).

17 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ ROCHER BENJAMIN;FERRIZ SORIANO VICENTE. Nombramientos. Consejero: GOMEZVIVO JULIO RAMON;BELMONTE SANCHEZ TERESA MARIA. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 170, S 8, H V 25192, I/A 106(10.01.23).

Ceses/Dimisiones. Consejero: MOLLA HERRERA MIREIA;TUZON MARCO PAULA;BELMONTE SANCHEZ TERESA MARIA.Presidente: MOLLA HERRERA MIREIA. Vicepr.1: TUZON MARCO PAULA. Nombramientos. Consejero: NAVARRO CASILLASISAURA. Presidente: NAVARRO CASILLAS ISAURA. Consejero: CANDELA PINA FRANCISCO JOSE;HERNANDEZ SAEZ JOSEJOAQUIN. Vicepr.1: CANDELA PINA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 171, S 8, H V 25192, I/A 107(10.01.23).

15 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DIEZ ANTONIO VICENTE. Secretario: GARCIA DIEZ ANTONIO VICENTE.Nombramientos. Consejero: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA. Secretario: FRESCO TORRALBA PEDRO DE BORJA.Datos registrales. T 9987, L 7269, F 170, S 8, H V 25192, I/A 105 ( 4.10.21).

13 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUESADA FERRE FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;CERDAN BARCELOFULGENCIO JOSE. Vicepr.2: RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: PEREZ ROCHERBENJAMIN;QUINTANA MARTINEZ ANTONIO;FERRIZ SORIANO VICENTE. Vicepr.2: LLANES RIBAS ROGELIO. Datos registrales.T 9987, L 7269, F 169, S 8, H V 25192, I/A 103 ( 7.05.21).

Ceses/Dimisiones. Dir. General: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARCO LOPEZ JOSEMANUEL;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Dir. General: GARCIA FERRER FERRAN VICENT. Apo.Man.Soli:GARCIA FERRER FERRAN VICENT;MARCO LOPEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 169, S 8, H V 25192, I/A104 ( 7.05.21).

10 de Marzo de 2021
Nombramientos. Auditor: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Aud.C.Con.: GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP. Datos

12 de Febrero de 2020
Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 9987, L7269, F 168, S 8, H V 25192, I/A 101 ( 5.02.20).

10 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CEBRIAN CALVO ELENA;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;MORATAL SASTRE JOSE;MARZOPASTOR ANTONI;ALVAREZ ALONSO DELIA;LLANES RIBAS ROGELIO;PUNCEL CHORNET ALFONSO. Presidente: CEBRIANCALVO ELENA. Vicepresid.: RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO. Consejero: PIQUER HUERGA JOAN;IRANZO NAVARROANDREU;QUESADA FERRE FRANCISCO JAVIER;CHAFER NACHER MARIA TERESA. Vicepresid.: QUESADA FERREFRANCISCO JAVIER. Secretario: MORATAL SASTRE JOSE. Vicesecret.: CHAFER NACHER MARIA TERESA. Consejero:CASTELLO GARCIA ISABEL;PINEDA CUENCA MANUEL. Nombramientos. Consejero: MOLLA HERRERA MIREIA;GARCIA DIEZANTONIO VICENTE;TUZON MARCO PAULA;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;MARIN FABRA DIEGO;CHAFER NACHER

08 de Agosto de 2019
Cambio de objeto social. La Sociedad tendr谩 como objeto: 1.- La construcci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento,valorizaci贸n o eliminaci贸n de cualquier tipo de residuos, as铆 como su gesti贸n, recogida, transporte, almacenamiento, dep贸sito,tratamiento, reciclaje, transformaci贸n y eliminaci贸n, la comercializaci. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 155, S 8, H V 25192, I/A99 ( 1.08.19).

21 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: POYATOS LEON JUAN ANGEL. Nombramientos. Consejero: CASTELLO GARCIAISABEL;PINEDA CUENCA MANUEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 155, S 8, H V 25192, I/A 98 (14.02.19).

18 de Diciembre de 2018
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 154, S 8, H V 25192, I/A 95 (11.12.18).

Revocaciones. Apoderado: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Subdirec: MARCO LOPEZ JOSE MANUEL.Apo.Man.Soli: MARCO LOPEZ JOSE MANUEL;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 154, S 8, H V25192, I/A 96 (11.12.18).

24 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARO PRAT JULIA;PERIS NAVARRO ENRIQUE. Vicesecret.: MORATAL SASTRE JOSE.Consejero: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Vicepresid.: ALVARO PRAT JULIA. Secretario: PERIS NAVARRO ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: QUESADA FERRE FRANCISCO JAVIER;CHAFER NACHER MARIA TERESA. Vicepresid.: QUESADAFERRE FRANCISCO JAVIER. Secretario: MORATAL SASTRE JOSE. Vicesecret.: CHAFER NACHER MARIA TERESA. Consejero:POYATOS LEON JUAN ANGEL. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 153, S 8, H V 25192, I/A 94 (17.09.18).

06 de Marzo de 2018
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4.999.719,00 Euros. Desembolsado: 4.999.719,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.670.129,00 Euros.Resultante Desembolsado: 19.670.129,00 Euros. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 153, S 8, H V 25192, I/A 93 (27.02.18).

19 de Octubre de 2017
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 152, S 8, H V 25192, I/A 92(11.10.17).

09 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Dir. General: GARCIA LLORENS VICENT. Subdirec: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Revocaciones.Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Dir. General: MACEDA LOPEZBENJAMIN. Apoderado: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 151, S 8, H V 25192, I/A 91 ( 2.10.17).

05 de Octubre de 2017
Nombramientos. Dir. General: GARCIA LLORENS VICENT. Otros conceptos: El 煤nico accionista el d铆a 13/05/2.016 y previamodificaci贸n del art铆culo 21潞 de los Estatutos Sociales redactado en los t茅rminos que figuran en la inscripci贸n 84陋, acord贸 RATIFICARY/O CONVALIDAR EL NOMBRAMIENTO DE DON VICENT GARCIA I LLORENS, como DIRECTOR GENERAL efectuado por elconsejo de admin. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 151, S 8, H V 25192, I/A 90 (28.09.17).

04 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ HERRERO MYRIAM DE LAS NIEVES. Nombramientos. Consejero: IRANZONAVARRO ANDREU. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 151, S 8, H V 25192, I/A 89 (27.09.17).

17 de Mayo de 2017
Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 4 de los estatutos sociales.. Cambio de objeto social. 1.- Laconstrucci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorizaci贸n o eliminaci贸n de cualquier tipo de residuos, as铆 como sugesti贸n, recogida, transporte, almacenamiento, dep贸sito, tratamiento, reciclaje, transformaci贸n y eliminaci贸n, la comercializaci贸n yventa de los productos resu. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 150, S 8, H V 25192, I/A 88 ( 9.05.17).

04 de Mayo de 2017
Modificaci贸n de poderes. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Datos registrales. T 9987, L7269, F 150, S 8, H V 25192, I/A 87 (25.04.17).

01 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAGO GIRALDOS MARIA. Nombramientos. Consejero: PIQUER HUERGA JOAN. Datosregistrales. T 9987, L 7269, F 149, S 8, H V 25192, I/A 85 (24.01.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CUENCA GARCIA ANGELES. D. Gerente: NIETO MOCHOLI JOSE. Revocaciones. Apoderado:BONO MARTINEZ EMERIT;CLIMENT ESPI JUAN VICENTE;BAYARRI LLORENS ANNA MARIA. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTREJOSE;SERRANO MATEO CRISTINA;URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES;ESPERT SILVESTRE JOSE;ESPERTSILVESTRE JOSE;TEJEDO TORMO VICENTE. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ BONAFE MARIA EMPAR. Datosregistrales. T 9987, L 7269, F 149, S 8, H V 25192, I/A 86 (24.01.17).

31 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MILLA JULIAN;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Cons.Del.Sol: MACEDA LOPEZ BENJAMIN.Consejero: GARCIA LLORENS VICENT. Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT. Apo.Manc.: ESPERTSILVESTRE JOSE. Apo.Man.Soli: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Nombramientos. Consejero: CUENCA GARCIA ANGELES.Subdirec: MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENS VICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Otros conceptos:MODIFICACION Y REFUNDICION DE ESTATUTOS. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.vaersa.com. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 146, S 8, H V 25192, I/A 84 (22.03.16).

02 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Vicesecret.: GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Secretario: PERALRIBELLES GASPAR. Consejero: BONIG TRIGUEROS ISABEL;PERAL RIBELLES GASPAR;VIESCA MARQUES JUAN;GONZALEZPRIETO ALFREDO;TEJEDO TORMO VICENTE;COMOS GUILLEM JOSE ALBERTO. Vicepresid.: TEJEDO TORMO VICENTE.Consejero: PRADAS TEN SALOME;GARCIA RIBOT PEDRO JAVIER. Cons.Del.Sol: TEJEDO TORMO VICENTE;GONZALEZ PRIETOALFREDO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: APARICIO GRAU JOSE. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTRE JOSE. Nombramientos.Consejero: CEBRIAN CALVO ELENA;ALVARO PRAT JULIA;RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO;PERIS NAVARROENRIQUE;MORATAL SASTRE JOSE;DIAGO GIRALDOS MARIA;MARZO PASTOR ANTONI. Apo.Man.Soli: MACEDA LOPEZBENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT;ESPERT SILVESTRE JOSE. Consejero: ALVAREZ ALONSO DELIA;LLANES RIBASROGELIO;FERNANDEZ HERRERO MYRIAM DE LAS NIEVES;LOPEZ MILLA JULIAN;PUNCEL CHORNET ALFONSO;MACEDALOPEZ BENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT. Cons.Del.Sol: MACEDA LOPEZ BENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT.Presidente: CEBRIAN CALVO ELENA. Vicepresid.: RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO. Secretario: PERIS NAVARRO ENRIQUE.Vicepresid.: ALVARO PRAT JULIA. Vicesecret.: MORATAL SASTRE JOSE. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 225, S 8, H V25192, I/A 82 (26.08.15).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GARCIA LLORENS VICENT. Revocaciones. Apo.Man.Soli: MACEDA LOPEZBENJAMIN;GARCIA LLORENS VICENT;ESPERT SILVESTRE JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORENSVICENT;MACEDA LOPEZ BENJAMIN. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTRE JOSE. Datos registrales. T 9987, L 7269, F 145, S 8, H V25192, I/A 83 (26.08.15).

17 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: GONZALEZ PRIETO ALFREDO;TEJEDO TORMO VICENTE. Nombramientos. Cons.Del.Sol:TEJEDO TORMO VICENTE;GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 224, S 8, H V 25192, I/A 81(10.12.14).

09 de Diciembre de 2014
Cambio de objeto social. 1. La construcci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorizaci贸n o eliminaci贸n de todotipo de residuos, as铆 como su gesti贸n, recogida, transporte, almacenamiento, dep贸sito, tratamiento, reciclaje, transformaci贸n yeliminaci贸n, la comercializaci贸n y venta de los productos resultante. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 224, S 8, H V 25192, I/A 80( 1.12.14).

28 de Noviembre de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: SIMO ARNAU ENRIQUE;SIMO ARNAU ENRIQUE;SIMO ARNAU ENRIQUE. Apoderado: SIMO ARNAUENRIQUE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARICIO GRAU JOSE. Apo.Manc.: ESPERT SILVESTRE JOSE. Datos registrales. T7551, L 4852, F 223, S 8, H V 25192, I/A 79 (21.11.14).

27 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Nombramientos. Cons.Del.Man: TEJEDO TORMOVICENTE;GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 223, S 8, H V 25192, I/A 78 (20.11.14).

12 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: VA脩O GIRONES JOAQUIN;BROSETA DUPRE BRUNO. Nombramientos. Consejero: PRADASTEN SALOME;GARCIA RIBOT PEDRO. Cambio de domicilio social. AVDA DE LES CORTS VALENCIANAS 20 2 (VALENCIA).Datos registrales. T 7551, L 4852, F 223, S 8, H V 25192, I/A 77 ( 4.11.14).

11 de Junio de 2014
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLC SL;AUREN AUDITORES ALC SL;AUREN AUDITORES BIO S.L.;AURENAUDITORS BCN S.A.;AUREN AUDITORES MAD S.L. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES VLC SL;AUREN AUDITORES ALCSL;AUREN AUDITORES BIO S.L.;AUREN AUDITORS BCN S.A.;AUREN AUDITORES MAD S.L. Datos registrales. T 7551, L 4852,F 222, S 8, H V 25192, I/A 76 ( 4.06.14).

13 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTORO BLASCO MARIA AMPARO. Nombramientos. Consejero: VA脩O GIRONES JOAQUIN.Datos registrales. T 7551, L 4852, F 222, S 8, H V 25192, I/A 75 ( 6.05.13).

25 de Febrero de 2013
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLC SL;AUREN AUDITORES ALC SL. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES VLCSL;AUREN AUDITORES ALC SL. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 73 (18.02.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BENLLIURE MORENO JOSE MARIA;MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Vicepresid.: MU脩OZCRIADO MARIA ARANZAZU. Revocaciones. Apo.Manc.: MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Nombramientos. Consejero:COMOS GUILLEM JOSE ALBERTO. Vicepresid.: TEJEDO TORMO VICENTE. Apo.Manc.: SIMO ARNAU ENRIQUE;TEJEDO TORMOVICENTE. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 74 (18.02.13).

01 de Junio de 2012
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 7.500.480,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 5. Capital.-El capitalsocial se fija en la cantidad de catorce millones seiscientos setenta mil cuatrocientos diez euros -14670410-. Se halla dividido en244100 acciones de clase y serie 煤nica, de sesenta euros y diez c茅ntimos -60,10 euros-, de valor nominal cada una de ellas ynumeradas. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 221, S 8, H V 25192, I/A 72 (23.05.12).

22 de Agosto de 2011
Revocaciones. Apoderado: ESPINOSA BOLA脩OS FELIPE. Nombramientos. Apoderado: SIMO ARNAU ENRIQUE. Apo.Manc.:SIMO ARNAU ENRIQUE;ESPERT SILVESTRE JOSE;SIMO ARNAU ENRIQUE;MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Datosregistrales. T 7551, L 4852, F 220, S 8, H V 25192, I/A 71 (10.08.11).

16 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: AMIGO SALVI PILAR;SERRANO MATEO CRISTINA. Secretario: SERRANO MATEO CRISTINA.Consejero: CENTENO CENTENO MARIA ANGELES;URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES;LAMPARERO LAZARO JORGEANTONIO;BENLLIURE MORENO JOSE MARIA;COTINO FERRER JUAN GABRIEL. Presidente: COTINO FERRER JUAN GABRIEL.Vicepresid.: URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES. Cons.Del.Sol: COTINO FERRER JUAN GABRIEL;URE脩A GUILLEMMARIA DE LOS ANGELES. Consejero: MONZO MARTINEZ EUSEBIO. Nombramientos. Presidente: BONIG TRIGUEROS ISABEL.Vicepresid.: MU脩OZ CRIADO MARIA ARANZAZU. Vicesecret.: GONZALEZ PRIETO ALFREDO. Secretario: PERAL RIBELLESGASPAR. Consejero: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Con.Delegado: BONIG TRIGUEROS ISABEL. Consejero: MU脩OZ CRIADOMARIA ARANZAZU;PERAL RIBELLES GASPAR;MONTORO BLASCO MARIA AMPARO;VIESCA MARQUES JUAN;GONZALEZPRIETO ALFREDO;TEJEDO TORMO VICENTE;BENLLIURE MORENO JOSE MARIA;BROSETA DUPRE BRUNO. Datosregistrales. T 7551, L 4852, F 220, S 8, H V 25192, I/A 70 ( 4.08.11).

21 de Diciembre de 2010
Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n del art铆culo 4 de los estatutos sociales.. Cambio de objeto social. 1.- Laconstrucci贸n de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorizaci贸n o eliminaci贸n de todo tipo de residuos, la recogida,transporte, almacenamiento, dep贸sito, tratamiento, reciclaje, transformaci贸n y eliminaci贸n, la comercializaci贸n y venta de los productosresultantes, as铆 como la .. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 219, S 8, H V 25192, I/A 69 (10.12.10).

30 de Julio de 2010
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES MEDITERRANEO SL;AUREN AUDITORES LEVANTE SL. Aud.C.Con.: AURENAUDITORES MEDITERRANEO SL;AUREN AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 7551, L 4852, F 219, S 8, H V 25192,I/A 68 (21.07.10).

06 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: LANDECHO CAMPOS PABLO. Nombramientos. Consejero: MONZO MARTINEZ EUSEBIO.Cambio de domicilio social. C/ MARIANO CUBER 17 (VALENCIA). Datos registrales. T 7551, L 4852, F 219, S 8, H V 25192, I/A67 (25.06.10).

17 de Diciembre de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 31.778.163,48 Euros. Resultante Suscrito: 4.669.770,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 10.000.640,00 Euros. Desembolsado: 2.500.160,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.670.410,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 7.169.930,00 Euros. Datos registrales. T 6547, L 3851, F 225, S 8, H V 25192, I/A 65 ( 7.12.09).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GARCIA ANTON JOSE RAMON. Consejero: GARCIA ANTON JOSE RAMON. Presidente:GARCIA ANTON JOSE RAMON. Vicepresid.: AMIGO SALVI PILAR. Nombramientos. Consejero: COTINO FERRER JUANGABRIEL. Presidente: COTINO FERRER JUAN GABRIEL. Vicepresid.: URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES. Cons.Del.Sol:COTINO FERRER JUAN GABRIEL;URE脩A GUILLEM MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 6547, L 3851, F 225, S 8, HV 25192, I/A 66 ( 7.12.09).

12 de Marzo de 2009
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SOCIEDAD ANONIMA PROFESION. Aud.C.Con.: MOORE STEPHENSIBERGRUP SOCIEDAD ANONIMA PROFESION. Datos registrales. T 6547, L 3851, F 225, S 8, H V 25192, I/A 64 ( 3.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n