Buscador CIF Logo

Actos BORME Valcerrada Inversiones Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Valcerrada Inversiones Sl

Actos BORME Valcerrada Inversiones Sl - B84613645

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Valcerrada Inversiones Sl con CIF B84613645

馃敊 Perfil de Valcerrada Inversiones Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Valcerrada Inversiones Sl

13 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTOS Y AZLOR DE ARAGON CARMEN. Datos registrales. T 22563 , F 216, S 8, H M 403331,I/A 34 ( 5.11.23).

05 de Abril de 2023
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GUERRERO BURGOS Y PEREIRO JUAN. Nombramientos. Auditor: ALESCO PARTNERSSLP. SecreNoConsj: MEDIERO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 8 de losestatutos. Creaci贸n del art铆uclo 8 bis de los estatutos. Cambio de domicilio social. C/ GOYA 111 - 2潞 IZQUIERDA (MADRID).P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: https://valcerradasl.es. Datos registrales. T 22563 , F 215, S 8,H M 403331, I/A 33 (29.03.23).

03 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: MARTIN TOLEDANO NU脩EZ LUIS. Datos registrales. T 22563 , F 214, S 8, H M 403331, I/A 31(26.10.21).

Nombramientos. Apoderado: RIVERA SERRANO VALERIANO. Datos registrales. T 22563 , F 215, S 8, H M 403331, I/A 32(26.10.21).

12 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: COTONER Y MARTOS MARTA;MEDIERO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T22563 , F 214, S 8, H M 403331, I/A 30 ( 5.05.21).

02 de Agosto de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.861.312,00 Euros. Resultante Suscrito: 162.749.402,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERADAS LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL 1 AL 162.749.402, AMBOS INCLUSIVE, MODIFICANDO EL ARTICULO6潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 22563 , F 212, S 8, H M 403331, I/A 29 (26.07.18).

15 de Marzo de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 16.432.864,00 Euros. Resultante Suscrito: 166.610.714,00 Euros. Datos registrales. T22563 , F 211, S 8, H M 403331, I/A 28 ( 6.03.18).

30 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: MARTIN TOLEDANO NU脩EZ LUIS. Datos registrales. T 22563 , F 211, S 8, H M 403331, I/A 27(23.01.18).

10 de Noviembre de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.354.240,00 Euros. Resultante Suscrito: 183.043.578,00 Euros. Datos registrales. T22563 , F 210, S 8, H M 403331, I/A 26 ( 2.11.17).

04 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: MARTIN TOLEDANO NU脩EZ LUIS. Datos registrales. T 22563 , F 210, S 8, H M 403331, I/A 25(24.04.17).

31 de Marzo de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 14.685.216,00 Euros. Resultante Suscrito: 185.397.818,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERADAS LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL 1 AL 185.397.818, AMBOS INCLUSIVE, MODIFICANDO EL ARTICULO6潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 22563 , F 209, S 8, H M 403331, I/A 24 (22.03.17).

24 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUELL MARTOS PILAR. Nombramientos. Consejero: CARRANZA GUELL PILAR. Datosregistrales. T 22563 , F 208, S 8, H M 403331, I/A 23 (15.03.17).

12 de Agosto de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 10.056.485,00 Euros. Resultante Suscrito: 200.083.034,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Datos registrales. T 22563 , F 207, S 8, H M 403331, I/A 22 ( 4.08.16).

13 de Febrero de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 210.139.519,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 22563 , F 206, S 8, H M 403331, I/A 21 ( 6.02.14).

22 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: MARTIN TOLEDANO Y NU脩EZ LUIS. Datos registrales. T 22563 , F 205, S 8, H M 403331, I/A 19(11.03.13).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN TOLEDANO Y NU脩EZ LUIS. Datos registrales. T 22563 , F 205, S 8, H M 403331, I/A 20(11.03.13).

26 de Julio de 2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ LOPEZ FERNANDO MANUEL. Datos registrales. T 22563 , F 205, S 8, H M 403331, I/A18 (16.07.12).

09 de Julio de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ BERNAL PEDRO-AGUSTIN. Datos registrales. T 22563 , F 204, S 8, H M 403331, I/A17 (26.06.12).

05 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTOS AGUIRRE ANGUSTIAS;GUELL Y MARTOS ALFONSO;COTONER MARTOSNICOLAS;COTONER MARTOS JOSE LUIS;COTONER Y MARTOS MARTA;COTONER MARTOS MARIA;MARTOS AZLOR DEARAGON JAVIER;MARTOS Y AZLOR DE ARAGON CARMEN;MARTOS AZLOR DE ARAGON ISABEL. Presidente: COTONERMARTOS NICOLAS. Nombramientos. Consejero: COTONER Y MARTOS MARTA. Presidente: COTONER Y MARTOS MARTA.Consejero: MARTOS Y AGUIRRE ANGUSTIAS. Vicepresid.: MARTOS Y AGUIRRE ANGUSTIAS. Consejero: GUELL MARTOSPILAR;MARTOS Y AZLOR DE ARAGON CARMEN. Modificaciones estatutarias. A脩ADIDO EL NUEVO ARTICULO 9BIS. Datosregistrales. T 22563 , F 203, S 8, H M 403331, I/A 15 (25.06.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN TOLEDANO Y NU脩EZ LUIS. Apo.Manc.: COTONER Y MARTOS MARTA. Datosregistrales. T 22563 , F 204, S 8, H M 403331, I/A 16 (25.06.12).

04 de Julio de 2012
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA LA REDACCION DELEPIGRAFE "D" DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.. Otros conceptos: SE SUBSANA LA CERTIFICACION INCORPORADA EN ESCRITURA QUE CAUSO EN ELREGISTRO LA INSCRIPCION 13. Datos registrales. T 22563 , F 203, S 8, H M 403331, I/A 14 (22.06.12).

23 de Mayo de 2012
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS.-. Datos registrales. T 22563 , F 203, S 8, H M403331, I/A 13 ( 9.05.12).

12 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTOS Y AZLOR DE ARAGON JUAN ALFONSO. Vicepresid.: MARTOS Y AZLOR DE ARAGONJUAN ALFONSO. Consejero: GUELL Y MARTOS ALFONSO. Vicesecret.: GUELL Y MARTOS ALFONSO. Consejero: MARTOSAGUIRRE ANGUSTIAS;COTONER MARTOS MARTA MARIA. Presidente: COTONER MARTOS MARTA MARIA. Consejero:MARTOS ZABALBURU MARIANO CRISTINO. Con.Delegado: MARTOS ZABALBURU MARIANO CRISTINO. Secretario: MARTINTOLEDANO NU脩EZ LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: GUERRERO BURGOS Y PEREIRO JUAN. VsecrNoConsj: MARTINTOLEDANO NU脩EZ LUIS. Consejero: MARTOS AGUIRRE ANGUSTIAS;GUELL Y MARTOS ALFONSO;COTONER MARTOSNICOLAS;COTONER MARTOS JOSE LUIS;COTONER MARTOS MARTA;COTONER MARTOS MARIA;MARTOS AZLOR DEARAGON JAVIER;MARTOS Y AZLOR DE ARAGON CARMEN;MARTOS AZLOR DE ARAGON ISABEL. Presidente: COTONERMARTOS NICOLAS. Apoderado: COTONER MARTOS NICOLAS;MARTOS AGUIRRE ANGUSTIAS;GUELL Y MARTOSALFONSO;COTONER MARTOS JOSE LUIS;COTONER MARTOS MARTA;COTONER MARTOS MARIA;MARTOS AZLOR DEARAGON JAVIER;MARTOS Y AZLOR DE ARAGON CARMEN;MARTOS AZLOR DE ARAGON ISABEL;MARTIN TOLEDANO NU脩EZLUIS. Modificaciones estatutarias. 9. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 22563 , F 201, S 8, H M 403331, I/A12 ( 2.08.10).

Otros conceptos: PROYECTO DE TRASLADO DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA , A LUXEMBURGO , FIJANDOSE EN SUCAPITAL LUXEMBURGO, CALLE RUE GOETHE, 5 -1637, LUXEMBURGO-.- EN CUANTO A LOS SOCIOS Y TRATANDOSE DEUNA SOCIEDAD FAMILIAR , SE HA REALIZADO UNA CONSULTA PREVIA A TODOS ELLOS, MOSTRANDOSE CONFORMES ALTRASLADO .-SE FIJA COMO DIRECCION DONDE PUEDEN OBTENER , SIN GASTOS , INFORMACION SOBRE LASCONDICIONES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS Y ACREEDORES EL DOMICILIO SOCIAL ACTUAL , ENMADRID, AVENIDA FELIPE II , NUMERO 13-2潞 DERECHA.- Datos registrales. T 22563 , F 64, S 8, H M 403331, I/A 1M ( 2.08.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n