Buscador CIF Logo

Actos BORME Valdebebas Office Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Valdebebas Office Sl

Actos BORME Valdebebas Office Sl - B85934586

Tenemos registrados 6 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Valdebebas Office Sl con CIF B85934586

馃敊 Perfil de Valdebebas Office Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Valdebebas Office Sl

23 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SAN JUAN MONJE FERNANDO;GABRIEL JULIAN CHRISTOPHER. Revocaciones. Apoderado:GRUNDY KEVIN GORDON;BARBA SILVELA JUAN;SAN JUAN MONJE FERNANDO;GABRIEL JULIAN CHRISTOPHER;BARBASILVELA JUAN;SAN JUAN MONJE FERNANDO;AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA;SALAMANCA CARRASCO VICTORMARCELINO;SALAMANCA CUEVAS VICTOR;SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA;SALAMANCA CUEVAS VICTOR.Nombramientos. Liquidador: TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL. Representan: GARRIGUES CALDERON BELEN. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 27683 , F 179, S 8, H M 498900, I/A 8 (10.09.13).

23 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CHRISTOPHER GABRIEL JULIAN;SAN JUAN MONJE FERNANDO. Secretario: SAN JUAN MONJEFERNANDO. Nombramientos. Adm. Solid.: SAN JUAN MONJE FERNANDO;GABRIEL JULIAN CHRISTOPHER. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T27683 , F 179, S 8, H M 498900, I/A 7 (16.05.13).

25 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBA SILVELA JUAN. Presidente: BARBA SILVELA JUAN. Datos registrales. T 27683 , F 179, S8, H M 498900, I/A 6 (17.04.13).

29 de Julio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.601,00 Euros. Datos registrales. T 27683 , F 178, S 8, H M498900, I/A 5 (18.07.11).

30 de Marzo de 2011
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO NUMERO 26 (MADRID). Datos registrales. T 27683 , F 178, S 8, H M 498900, I/A 4(19.03.11).

15 de Diciembre de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: CHRISTOPHER GABRIEL JULIAN;SAN JUAN MONJE FERNANDO;BARBA SILVELA JUAN;SAN JUANMONJE FERNANDO;CHRISTOPHER GABRIEL JULIAN;BARBA SILVELA JUAN. Nombramientos. Apoderado: GRUNDY KEVINGORDON;BARBA SILVELA JUAN;SAN JUAN MONJE FERNANDO;GABRIEL JULIAN CHRISTOPHER;BARBA SILVELA JUAN;SANJUAN MONJE FERNANDO;AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA;SALAMANCA CARRASCO VICTORMARCELINO;SALAMANCA CUEVAS VICTOR;SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA;SALAMANCA CUEVAS VICTOR. Cambiode domicilio social. AVDA DE ARAGON 330 - PARQUE EMPRESARIAL "LAS MERCE (MADRID). Datos registrales. T 27683 , F176, S 8, H M 498900, I/A 3 ( 1.12.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n