Buscador CIF Logo

Actos BORME Valdemira Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Valdemira Sl

Actos BORME Valdemira Sl - B78645983

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Valdemira Sl con CIF B78645983

🔙 Perfil de Valdemira Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Valdemira Sl

05 de Mayo de 2022
Modificaciones estatutarias. 7. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 16506 , F 13, S 8, H M 54478, I/A 52 (27.04.22).

02 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Aud.C.Con.: MORISON ACPM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16506 , F 13, S 8, H M 54478, I/A 51(25.10.21).

06 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: BANUS GUTIERREZ ANGEL;BANUS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 16506 , F

25 de Marzo de 2020
Nombramientos. Auditor: MORISON ACPM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16506 , F 12, S 8, H M 54478, I/A 49(18.03.20).

17 de Marzo de 2020
Cambio de domicilio social. C/ NURIA 59 2º (MADRID). Datos registrales. T 16506 , F 12, S 8, H M 54478, I/A 48 (10.03.20).

31 de Octubre de 2019
Nombramientos. Aud.C.Con.: MORISON ACPM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16506 , F 12, S 8, H M 54478, I/A 47(24.10.19).

17 de Octubre de 2018
Nombramientos. Aud.C.Con.: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 16506 , F 12, S 8, H M 54478, I/A 46 ( 5.10.18).

19 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Presidente: BANUS GUTIERREZ ANGEL. Vicepresid.: BANUS GUTIERREZ MANUEL. Revocaciones.Apoderado: BANUS GUTIERREZ RAFAEL;CAMPOS CASTAÑO EDUARDO. Nombramientos. Presidente: BANUS GUTIERREZMANUEL. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ RAFAEL;FRESNILLO DE LEON OSCAR. Vicepresid.: BANUS GUTIERREZ RAFAEL.Con.Delegado: BANUS GUTIERREZ MANUEL. Cambio de domicilio social. TRVA DE COSTA BRAVA. 6 (MADRID). Datosregistrales. T 16506 , F 10, S 8, H M 54478, I/A 45 (12.01.16).

06 de Agosto de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZ RAFAEL;GUTIERREZ MARQUEZ LUIS. Datos registrales. T 16506 , F 10, S 8, HM 54478, I/A 44 (30.07.15).

16 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Con.Delegado: BANUS GUTIERREZ MANUEL. Presidente:GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Vicepresid.: BANUS GUTIERREZ JUAN. Nombramientos. Presidente: BANUS GUTIERREZANGEL. Vicepresid.: BANUS GUTIERREZ MANUEL. Datos registrales. T 16506 , F 9, S 8, H M 54478, I/A 42 ( 8.07.15).

Nombramientos. Consejero: BANUS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 16506 , F 9, S 8, H M 54478, I/A 43 (8.07.15).

27 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BANUS GUTIERREZ GONZALO. Datos registrales. T 16506 , F 9, S 8, H M 54478, I/A 41(17.04.15).

06 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ GONZALO;BANUS GUTIERREZ ANGEL;BANUSGUTIERREZ MANUEL;BANUS GUTIERREZ RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: BANUS GUTIERREZ RAFAEL;CAMPOSCASTAÑO EDUARDO. Datos registrales. T 16506 , F 8, S 8, H M 54478, I/A 40 (27.01.15).

30 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ FLECHA JOSE LUIS;CASTEDO ALVAREZ FERNANDO. Datos registrales. T 16506 ,F 8, S 8, H M 54478, I/A 39 (18.12.14).

21 de Octubre de 2014
Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 16506 , F 7, S 8, H M 54478,I/A 38 (13.10.14).

10 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-QUIROS GARCIA GUILLERMO. Nombramientos. SecreNoConsj: MOLINER OLIVALUIS. Datos registrales. T 16506 , F 7, S 8, H M 54478, I/A 37 ( 2.06.14).

04 de Abril de 2014
Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 16506 , F 7, S 8, H M 54478,I/A 36 (24.03.14).

07 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ SANTOS MARIA ELENA. Datos registrales. T 16506 , F 7, S 8, H M 54478, I/A 35(31.01.14).

11 de Enero de 2013
Ampliación de capital. Capital: 1.030.534,70 Euros. Resultante Suscrito: 5.299.852,39 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 16506 , F 6, S 8, H M 54478, I/A 34 ( 3.01.13).

16 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 16506 , F 6, S 8, H M54478, I/A 33 ( 3.11.11).

08 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA QUIROS GARCIA GUILLERMO. Vicepresid.: GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Consejero:BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ GONZALO;BANUS GUTIERREZ ANGEL;BANUS GUTIERREZ MANUEL;BANUSFERRE JUAN. Cons.Del.Sol: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ GONZALO. Presidente: GUTIERREZ FERNANDEZCELIA. Cons.Del.Sol: GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Consejero: BANUS GUTIERREZ RAFAEL ANGEL. Revocaciones.Apoderado: BANUS GUTIERREZ GONZALO;BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS FERRE ANTONIO;BANUS GUTIERREZMANUEL;BANUS ALEIXANDRE ALVARO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA-QUIROS GARCIA GUILLERMO. Consejero:GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Presidente: GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA. Consejero: BANUS GUTIERREZ JUAN.Vicepresid.: BANUS GUTIERREZ JUAN. Consejero: BANUS GUTIERREZ MANUEL. Con.Delegado: BANUS GUTIERREZ MANUEL.

Nombramientos. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ GONZALO;BANUS GUTIERREZ ANGEL;BANUSGUTIERREZ MANUEL;BANUS GUTIERREZ RAFAEL. Datos registrales. T 16506 , F 5, S 8, H M 54478, I/A 32 (29.03.11).

03 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Consejero: BANUS GUTIERREZ RAFAEL ANGEL. Datos registrales. T 16506 , F 3, S 8, H M 54478, I/A 30(20.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información