Actos BORME de Valdesolar Hive Sl
21 de Julio de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-RUBIO JAQUOTOT JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj: LINARESFERNANDEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 38087 , F 181, S 8, H M 556455, I/A 30 (14.07.23).
06 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: GOMEZ-ACEBO MUNTA脩OLA PABLO;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 38087, F 181, S 8, H M 556455, I/A 29 (30.05.23).
01 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: VILLORIA MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 38087 , F 179, S 8, H M 556455, I/A 27(25.05.23).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ TREJO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 38087 , F 180, S 8, H M 556455, I/A 28(25.05.23).
29 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: MATTHOLIE ROBERT ANDREW. Nombramientos. VsecrNoConsj: HARRIS CLAIRE SUSANNAH.Datos registrales. T 38087 , F 179, S 8, H M 556455, I/A 26 (22.03.23).
27 de Febrero de 2023Nombramientos. Vicesecret.: MATTHOLIE ROBERT ANDREW. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 24陋 lapublicaci贸n del nombramiento de MATTHOLIE ROBERT ANDREW como vicesecretario. Datos registrales. T 38087 , F 178, S 8, H M556455, I/A 24 (19.08.22).
09 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38087 , F 179, S 8, H M 556455,I/A 25 ( 2.02.23).
26 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: PEDROSA GOMEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 38087 , F 178, S 8, H M 556455, I/A 23(19.08.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: PERKINS GEORGE PHILIP ROGER. Vicesecret.: PERKINS GEORGE PHILIP ROGER.Nombramientos. Consejero: MATTHOLIE ROBERT ANDREW. Datos registrales. T 38087 , F 178, S 8, H M 556455, I/A 24(19.08.22).
25 de Agosto de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: COSTEIRA NOGUEIRA DE SOUSA JOAO PAULO. Datos registrales. T 38087 , F 177, S 8, H M 556455,I/A 22 (18.08.22).
14 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO. Nombramientos. Consejero: ABUIN GARCIACARLOS;PERKINS GEORGE PHILIP ROGER;GUTIERREZ PEREZ AURELIO;PEDROSA GOMEZ ENRIQUE;GOMEZ REDONDOSERGIO ALFONSO. Presidente: PEDROSA GOMEZ ENRIQUE. Vicepresid.: ABUIN GARCIA CARLOS. Vicesecret.: PERKINSGEORGE PHILIP ROGER. SecreNoConsj: GARCIA-RUBIO JAQUOTOT JAVIER. Modificaciones estatutarias. REFUNDICION DELOS ESTATUTOS SOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 38087 , F 170, S 8, H M 556455, I/A 21 ( 7.06.22).
01 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSAS RODRIGO ALMUDENA. Nombramientos. Apoderado:NOGUEIRA DE SOUSA COSTEIRA JOAO PAULO;GOMEZ REDONDO SERGIO ALFONSO;DE LA LAMA ALCAIDE JOSE MANUEL.Datos registrales. T 38087 , F 169, S 8, H M 556455, I/A 20 (25.01.22).
26 de Enero de 2022Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 44 (MADRID). Datos registrales. T 38087 , F 169, S 8, H M 556455, I/A 19(19.01.22).
28 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 38087 , F 169, S 8, H M 556455, I/A 18(21.05.21).
25 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 38087 , F 168, S 8, H M 556455, I/A 16(18.02.21).
Revocaciones. Apoderado: REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA. Datos registrales. T 38087 , F 168, S 8, H M556455, I/A 17 (18.02.21).
13 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ GENERAL LACY 23 (MADRID). Datos registrales. T 38087 , F 168, S 8, H M 556455, I/A 15 (2.04.20).
11 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO;COSTEIRA NOGUEIRA DE SOUSA JOAO PAULO. Datosregistrales. T 38087 , F 167, S 8, H M 556455, I/A 14 ( 4.02.20).
10 de Febrero de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: REPSOL RENOVABLES SL. Datos registrales. T 38087 , F 166, S8, H M 556455, I/A 12 ( 3.02.20).
Nombramientos. Apo.Manc.: VAZQUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;ROSAS RODRIGOALMUDENA;SEIJAS UZQUIZA IGNACIO. Datos registrales. T 38087 , F 166, S 8, H M 556455, I/A 13 ( 3.02.20).
17 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: CIORDIA RUEDA ELENA JORDANA. Datos registrales. T 38087 , F 165, S 8, H M 556455, I/A 10(10.12.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ SALINERO ERIKA. Datos registrales. T 38087 , F 166, S 8, H M 556455, I/A 11 (10.12.19).
07 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ-ACEBO MUNTA脩OLA PABLO. Datos registrales. T 38087 , F 165, S 8, H M 556455, I/A 9(30.10.18).
10 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: GOMEZ-ACEBO MUNTA脩OLA PABLO. Datos registrales. T 30917 , F 74, S 8, H M 556455, I/A 8 (3.10.18).
09 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA. Datos registrales. T 30917 , F 73, S 8, H M556455, I/A 7 ( 1.10.18).
05 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MOURILLE CASTI脩EIRAS SANTOS;HERNANDEZ SALINERO ERIKA;PEINADO BALDRICH IRENE.Datos registrales. T 30917 , F 73, S 8, H M 556455, I/A 6 (27.09.18).
25 de Septiembre de 2018Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 44 (MADRID). Datos registrales. T 30917 , F 73, S 8, H M 556455, I/A 5(17.09.18).
10 de Septiembre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: REPSOL NUEVAS ENERGIAS SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZHERMIDA LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: CORTEZON SANTACLARA JULIO. Datos registrales. T 4022 , F 31, S 8, H A154312, I/A 3 (27.08.18).