Actos BORME de Valenciana De Servicios De Automoviles Sa
18 de Mayo de 2021Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 660/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 28/04/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA. Juez:EDUARDO PASTOR MARTINEZ. Resoluciones: Se acuerda la conclusi贸n del concurso, cesando todos los efectos de la declaraci贸ndel concurso, sin perjuicio de su posible reapertura en caso de aparici贸n de.nuevos bienes; y se acuerda la extinci贸n de lapersonalidad jur铆dica de la sociedad instante y la cancelaci贸n de sus asientos registrales. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 660/2016. Fecha de resoluci贸n 15/09/2016. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE VALENCIA. Juez: DANIEL VALCARCE POLANCO. Administrador Concursal. Fecha 28/04/2020, NIF/CIF29187167Y. BELENGUER VERGARA JOSE GUILLERMO. Extinci贸n. Datos registrales. T 3141, L 455, F 221, S 8, H V 6458, I/A 37(11.05.21).
11 de Octubre de 2016Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 660/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 15/09/2016. Solicitud de declaraci贸n.Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: DANIEL VALCARCE POLANCO. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 660/2016. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 15/09/2016. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado:num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: DANIEL VALCARCE POLANCO. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 660/2016. Fecha de resoluci贸n 15/09/2016. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LOMERCANTIL DE VALENCIA. Juez: DANIEL VALCARCE POLANCO. Administrador Concursal. Fecha 15/09/2016, NIF/CIF29187167Y. BELENGUER VERGARA JOSE GUILLERMO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 660/2016. FIRME: Si,Fecha de resoluci贸n 15/09/2016. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n ydisposici贸n del concursado. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. Juez: DANIEL VALCARCE POLANCO.Datos registrales. T 3141, L 455, F 221, S 8, H V 6458, I/A 35 ( 4.10.16).
04 de Octubre de 2016Fe de erratas: D. Francisco Javier Gonz谩lez Duato, fue nombrado Consejero Delegado, no como por error se public贸 en el Bolet铆n145 de fecha 01/08/16 y referencia 03177932016. Datos registrales. T 3141, L 455, F 220, S 8, H V 6458, I/A 34 (22.07.16).
01 de Agosto de 2016Nombramientos. Con.Delegado: MARTINEZ CALIXTO JUAN RAMON. Datos registrales. T 3141, L 455, F 220, S 8, H V 6458, I/A34 (22.07.16).
19 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: SOSPEDRA BARBERA MARIA. Consejero: SOSPEDRA BARBERA MARIA;GONZALEZ DUATOFRANCISCO JAVIER;GOMEZ BALLESTER JOSE LUISPresidente: GONZALEZ DUATO FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado:GONZALEZ DUATO FRANCISCO JAVIER. Consejero: GOMEZ BALLESTER JULIAN;MARTINEZ CALIXTO JUAN RAMON.Secretario: MARTINEZ CALIXTO JUAN RAMON. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DUATO FRANCISCO JAVIER;GOMEZBALLESTER JOSE LUIS;MARTINEZ CALIXTO JUAN RAMON. Presidente: GONZALEZ DUATO FRANCISCO JAVIER. Secretario:MARTINEZ CALIXTO JUAN RAMON. Datos registrales. T 3141, L 455, F 64, S 8, H V 6458, I/A 33 (12.07.16).
01 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SOSPEDRA FERRER ENRIQUE;MARTI LIZARALDE JULIO ANTONIO;MARTI MU脩OZ JULIO-JOSE.Presidente: SOSPEDRA BARBERA MARIA. Nombramientos. Presidente: GONZALEZ DUATO FRANCISCO JAVIER.Con.Delegado: GONZALEZ DUATO FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Se fija en SEIS el n煤mero de miembros del Consejode Administraci贸n. Datos registrales. T 3141, L 455, F 64, S 8, H V 6458, I/A 31 (25.01.16).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ BALLESTER JOSE LUIS;MARTINEZ CALIXTO JUAN RAMON. Datos registrales. T 3141, L455, F 64, S 8, H V 6458, I/A 32 (25.01.16).
08 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ GUERRERO JULIAN ANTONIO. SecreNoConsj: ORTU脩O PASCUAL ADOLFO.Nombramientos. Consejero: GOMEZ BALLESTER JULIAN;GONZALEZ DUATO FRANCISCO JAVIER;MARTINEZ CALIXTO JUANRAMON. Secretario: MARTINEZ CALIXTO JUAN RAMON. Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datosregistrales. T 3141, L 455, F 64, S 8, H V 6458, I/A 30 ( 1.09.15).
03 de Septiembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GOMEZ BALLESTER JOSE LUIS. Datos registrales. T 3141, L 455, F 64, S 8, H V 6458, I/A 29(27.08.15).
22 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ BALLESTER JOSE LUIS. Revocaciones. Apoderado: SOSPEDRA FERRERENRIQUE;GOMEZ BALLESTER JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: SOSPEDRA BARBERA MARIA;MARTINEZ CALIXTOJUAN RAMON. Presidente: SOSPEDRA BARBERA MARIA. Datos registrales. T 3141, L 455, F 63, S 8, H V 6458, I/A 28 (14.05.15).
12 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ GUERRERO JULIAN ANTONIO;MARTI LIZARALDE JULIO ANTONIO;SOSPEDRA FERRERENRIQUE. Presidente: SOSPEDRA FERRER ENRIQUE. Secretario: ORTU脩O PASCUAL ADOLFO. Nombramientos. Consejero:SOSPEDRA FERRER ENRIQUE;GOMEZ GUERRERO JULIAN ANTONIO;MARTI LIZARALDE JULIO ANTONIO;SOSPEDRABARBERA MARIA;GOMEZ BALLESTER JOSE LUIS;MARTI MU脩OZ JULIO-JOSE. Presidente: GOMEZ BALLESTER JOSE LUIS.SecreNoConsj: ORTU脩O PASCUAL ADOLFO. Datos registrales. T 3141, L 455, F 63, S 8, H V 6458, I/A 27 ( 5.02.15).
13 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 3141, L 455, F 62, S 8, H V 6458, I/A 26 (6.08.14).
09 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ GUERRERO JULIAN ANTONIO;MARTI LIZARALDE JULIO ANTONIO;SOSPEDRA FERRERENRIQUE. Presidente: SOSPEDRA FERRER ENRIQUE. Vicepresid.: MARTI LIZARALDE JULIO ANTONIO. Secretario: GOMEZGUERRERO JULIAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GOMEZ GUERRERO JULIAN ANTONIO;MARTI LIZARALDE JULIOANTONIO;SOSPEDRA FERRER ENRIQUE. Presidente: SOSPEDRA FERRER ENRIQUE. Secretario: ORTU脩O PASCUAL ADOLFO.Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 3141, L 455, F 62, S 8, H V 6458, I/A 25 (2.08.13).
29 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: GOMEZ GUERRERO JULIAN ANTONIO. Datos registrales. T 3141, L 455, F 61, S 8, H V 6458,I/A 24 (22.04.13).
06 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ BALLESTER JOSE LUIS. Datos registrales. T 3141, L 455, F 61, S 8, H V 6458, I/A 23(27.08.12).
03 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 3141, L 455, F 61, S 8, H V 6458, I/A 22(23.08.12).
14 de Octubre de 2010Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 3141, L 455, F 61, S 8, H V 6458, I/A 21 (
06 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: CHUYVAL MOTOR GROUP SOCIEDAD LIMITADA. Consejero: CHUYVAL MOTOR GROUPSOCIEDAD LIMITADA;GOZALVO MIRALLES DESAMPARADOS;CHULIA GOZALVO SALVADOR. Vicepresid.: GOMEZ GUERREROJULIAN ANTONIO. Secretario: MARTI LIZARALDE JULIO ANTONIO. Nombramientos. Presidente: SOSPEDRA FERRERENRIQUE. Vicepresid.: MARTI LIZARALDE JULIO ANTONIO. Secretario: GOMEZ GUERRERO JULIAN ANTONIO. Datosregistrales. T 3141, L 455, F 61, S 8, H V 6458, I/A 20 (27.04.10).
06 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: CENTELLES FORNER VICENTE. Nombramientos. Consejero: GOZALVO MIRALLESDESAMPARADOS. Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL. Datos registrales. T 3141, L 455, F 61, S 8, HV 6458, I/A 19 (28.10.09).