Actos BORME de Valenciana De Supermercados Sa
27 de Octubre de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 166, S 8, H V 826, I/A 44 (20.10.21).
06 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 166, S 8, H V 826, I/A 43 (29.10.20).
03 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 166, S 8, H V 826, I/A 42 (27.01.20).
28 de Mayo de 2019Reelecciones. Adm. Unico: COALIMENT GRANOLLERS SA. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 166, S 8, H V 826, I/A 41(21.05.19).
07 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 165, S 8, H V 826, I/A 40 (29.11.18).
24 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 165, S 8, H V 826, I/A 39 (17.01.18).
24 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 165, S 8, H V 826, I/A 38 (17.01.17).
31 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAPERAS AYMAR JOSEP. Apo.Manc.: CASTELLS GARCIA MIGUEL;TORDERA ARAUSJOAQUIM. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 164, S 8, H V 826, I/A 36 (24.10.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAPUENTE GINE DAVID. Apo.Manc.: SAPERAS AYMAR JOSEP;CASTELLS GARCIAMIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIM. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 164, S 8, H V 826, I/A 37 (24.10.16).
27 de Octubre de 2016Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 164, S 8, H V 826, I/A 34 (20.10.16).
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 164, S 8, H V 826, I/A 35 (20.10.16).
27 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: CAMPAS MITJAVILA CARLES. Apo.Sol.: CAMPAS MITJAVILA CARLES. Apo.Manc.: CAMPASMITJAVILA CARLES. Apo.Man.Soli: VIVES PLANELL JOAN. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 163, S 8, H V 826, I/A 33(20.04.16).
02 de Febrero de 2016Nombramientos. Adm. Unico: COALIMENT GRANOLLERS SA. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 163, S 8, H V 826, I/A 32(26.01.16).
09 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: COALIMENT GRANOLLERS SA. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 163, S 8, H V 826, I/A 31 (2.06.14).
07 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: SAPERAS MARTI JOSEP;ROVIRA SAPERAS JOAN. Apo.Manc.: TALLON LUENGO HECTOR;RUEDAQUINTERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 163, S 8, H V 826, I/A 30 (31.03.14).
28 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIVES PLANELL JOAN. Apo.Manc.: CASTELLS GARCIA MIQUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIM.Datos registrales. T 3824, L 1136, F 162, S 8, H V 826, I/A 29 (21.02.14).
12 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 162, S 8, H V 826, I/A 28 ( 5.11.13).
26 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: TORDERA ARAUS JOAQUIM. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 162, S 8, H V 826, I/A 27(19.06.13).
31 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 162, S 8, H V 826, I/A 26 (22.10.12).
09 de Agosto de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: RUEDA QUINTERO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: RUEDA QUINTERO FRANCISCO
11 de Febrero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPAS MITJAVILA CARLES;SAPERAS VERGARA JORDI. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 160,S 8, H V 826, I/A 24 ( 2.02.11).
22 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: TALLON LUENGO HECTOR;TORDERA ARAUS JOAQUIN. Datos registrales. T 3824, L 1136, F 160,S 8, H V 826, I/A 23 (13.12.10).
15 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: COALIMENT GRANOLLERS SA. Nombramientos. Adm. Unico: COALIMENT GRANOLLERS SA.Datos registrales. T 3824, L 1136, F 160, S 8, H V 826, I/A 22 ( 6.07.09).