Buscador CIF Logo

Actos BORME Valls Infraestructures Aparcaments I Serveis Societat Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Valls Infraestructures Aparcaments I Serveis Societat Anonima

Actos BORME Valls Infraestructures Aparcaments I Serveis Societat Anonima - A43561992

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Tarragona para Valls Infraestructures Aparcaments I Serveis Societat Anonima con CIF A43561992

🔙 Perfil de Valls Infraestructures Aparcaments I Serveis Societat Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Tarragona

Actos BORME de Valls Infraestructures Aparcaments I Serveis Societat Anonima

18 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SALAT BRUNEL FRANCESC XAVIER. Nombramientos. Consejero: GARCIA CARMONA ENRIC.

07 de Agosto de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: FONT HERRERA RAMON;SERRA MORLA RAMON;BORDAS PASCUAL ROGER. Nombramientos.Apo.Manc.: FONT HERRERA RAMON;BORDAS PASCUAL ROGER;LOPEZ MARTINEZ MARIA NIEVES. Datos registrales. T 2798 ,F 51, S 8, H T 18175, I/A 19 (31.07.20).

Nombramientos. Gerente: BORDAS PASCUAL ROGER. Datos registrales. T 2798 , F 52, S 8, H T 18175, I/A 20 (31.07.20).

31 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANGUELA BONET FRANCESC. Presidente: ANGUELA BONET FRANCESC. Consejero: FARRECUADRAS MARIA DOLORS;BIGORRA SUGRAÑES ALBERT;ROIG ARAN ARTEMI;ESPLUGAS PABLO XAVIER;BASTIDAAUBAREDA TAIS;BELLO LOPEZ FELIX;GARCIA PARRA JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: FONT HERRERA RAMON.Presidente: FONT HERRERA RAMON. Consejero: SALAT BRUNEL FRANCESC XAVIER;GIRO BATALLA RAMON;BASTIDAAUBAREDA TAIS;PEREZ CAPARROS JOAQUIN JUAN;LAIZ RODRIGUEZ CRISTINA. SecreNoConsj: NAVARRO URGELLMONTSERRAT. Datos registrales. T 2798 , F 49, S 8, H T 18175, I/A 16 (23.10.19).

30 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: ANGUELA BONET FRANCESC;SERRA MORLA RAMON;BORDAS PASCUAL ROGER.Nombramientos. Apo.Manc.: FONT HERRERA RAMON;SERRA MORLA RAMON;BORDAS PASCUAL ROGER. Datos registrales.T 2798 , F 50, S 8, H T 18175, I/A 17 (23.10.19).

Revocaciones. Apoderado: ANGUELA BONET FRANCESC. Nombramientos. Apoderado: FONT HERRERA RAMON. Datosregistrales. T 2798 , F 50, S 8, H T 18175, I/A 18 (23.10.19).

22 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ RIBAS EDUARD. Presidente: GONZALEZ RIBAS EDUARD. Consejero: PAGAEXPOSITO EMILIO;PALLARES SERRA JORDI;ESTEVE SOLE JOAN MARIA;PLUVINET SOLA NEUS;ULLDEMOLINS BALLESPIFRANCISCO JAVIER;ORDINA ROIG RAMON;BELLO LOPEZ FELIX;MENERO GUELL JOSEP;FERRANDO FOLCH CARME;ROIGARAN ARTEMI. Secretario: NAVARRO URGELL MONTSERRAT. Nombramientos. Consejero: ANGUELA BONET FRANCESC.Presidente: ANGUELA BONET FRANCESC. Consejero: FARRE CUADRAS MARIA DOLORS;BIGORRA SUGRAÑES ALBERT;ROIGARAN ARTEMI;ESPLUGAS PABLO XAVIER;BASTIDA AUBAREDA TAIS;BELLO LOPEZ FELIX;GARCIA PARRA JOSE LUIS.Secretario: NAVARRO URGELL MONTSERRAT. Datos registrales. T 2798 , F 46, S 8, H T 18175, I/A 12 (11.03.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ RIBAS EDUARD;SERRA MORLA RAMON;BORDAS PASCUAL ROGER. Nombramientos.Apo.Manc.: ANGUELA BONET FRANCESC;SERRA MORLA RAMON;BORDAS PASCUAL ROGER. Datos registrales. T 2798 , F48, S 8, H T 18175, I/A 13 (11.03.16).

Nombramientos. Apoderado: ANGUELA BONET FRANCESC. Datos registrales. T 2798 , F 48, S 8, H T 18175, I/A 14 (11.03.16).

Ceses/Dimisiones. Gerente: SERRA MORLA RAMON. Nombramientos. Gerente: SERRA MORLA RAMON. Datos registrales. T2798 , F 48, S 8, H T 18175, I/A 15 (11.03.16).

08 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOTO DE LA CRUZ VIRGILIO. Nombramientos. Consejero: BELLO LOPEZ FELIX;MENEROGUELL JOSEP;FERRANDO FOLCH CARME;ROIG ARAN ARTEMI. Datos registrales. T 2798 , F 46, S 8, H T 18175, I/A 11 (1.08.14).

20 de Marzo de 2014
Otros conceptos: Refundicion estatutaria.- Datos registrales. T 1469 , F 9, S 8, H T 18175, I/A 10 (11.03.14).

29 de Octubre de 2013
Nombramientos. Gerente: SERRA MORLA RAMON. Datos registrales. T 1469 , F 9, S 8, H T 18175, I/A 9 (23.10.13).

29 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ RIBAS EDUARD;SERRA MORLA RAMON;BORDAS PASCUAL ROGER. Datosregistrales. T 1469 , F 8, S 8, H T 18175, I/A 8 (21.06.12).

19 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ABAD SOLE JOAN. Datos registrales. T 1469 , F 7, S 8, H T 18175, I/A 6 ( 4.04.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: RECHE VALDIVIESO JUAN RAMON;TRAGUANY MASONI AMADEO;BIGORRA SUGRAÑESALBERT. Presidente: BIGORRA SUGRAÑES ALBERT. Consejero: ODINA ROIG MANUEL;LEIVA CABUS SERGI;SORROCHEMAÑAS ANTONIO;TOUS RUBIO JAUME;PLUVINET SOLA NEUS. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ RIBAS EDUARD.Presidente: GONZALEZ RIBAS EDUARD. Consejero: PAGA EXPOSITO EMILIO;PALLARES SERRA JORDI;ESTEVE SOLE JOANMARIA;SOTO DE LA CRUZ VIRGILIO;PLUVINET SOLA NEUS;ULLDEMOLINS BALLESPI FRANCISCO JAVIER;ORDINA ROIGRAMON. Datos registrales. T 1469 , F 7, S 8, H T 18175, I/A 5 ( 4.04.12).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RIBAS EDUARD. Datos registrales. T 1469 , F 8, S 8, H T 18175, I/A 7 ( 4.04.12).

19 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUILAR HISADO MIGUEL ANGEL;BLANCH ELIAS LUIS. Nombramientos. Consejero: ABADSOLE JOAN;PLUVINET SOLA NEUS. Datos registrales. T 1469 , F 6, S 8, H T 18175, I/A 4 (10.08.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información