Actos BORME de Valls Quimica Sociedad Anonima
27 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: CARMONA LAURENT SERGE. Presidente: CARMONA LAURENT SERGE. Consejero: MORINEAUFRANCK VICTOR JULES;ESTEVEZ MUÑOZ JUAN JOSE;PAZ FERNANDEZ FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: SECHEMAXIME PATRICK ROGER;ESTEVEZ MUÑOZ JUAN JOSE;PAZ FERNANDEZ FRANCISCO;MORINEAU FRANCK VICTORJULES;ROGEAU NICOLAS JEAN. Presidente: SECHE MAXIME PATRICK ROGER. Datos registrales. T 2687 , F 107, S 8, H T3569, I/A 72 (20.09.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: ESTEVEZ MUÑOZ JUAN JOSE;CARMONA LAURENT SERGE. Nombramientos. Apo.Sol.: ESTEVEZMUÑOZ JUAN JOSE;ROGEAU NICOLAS JEAN. Datos registrales. T 2687 , F 108, S 8, H T 3569, I/A 73 (20.09.23).
03 de Agosto de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Auditor:MAZARS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2687 , F 107, S 8, H T 3569, I/A 71 (27.07.21).
15 de Julio de 2020Otros conceptos: REFUNDIDOS LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD; ASIMISMO CAMBIADO ELDOMICILIO SOCIAL, AMPLIADO EL OBJETO SOCIAL Y CAMBIADA LA DURACION DE LOS CARGOS DEL ORGANO DEADMINISTRACION PASANDO A SER DE 6 AÑOS.- Ampliacion del objeto social. LA COMERCIALIZACION, IMPORTACION YEXPORTACION DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS ANTES INDICIADOS ASI COMO LACOMERCIALIZACION Y ARRENDAMIENTO DE PRODUCTOS.- Cambio de domicilio social. C/ BASTERS.- 1-3 - POLIGONOINDUSTRIAL VALLS.- (VALLS). Datos registrales. T 2687 , F 90, S 8, H T 3569, I/A 70 ( 6.07.20).
17 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: MANENT OSTARIZ LUIS;MANENT OSTARIZ LUIS;SOLORZANO BALSERA JOSEFA. Datosregistrales. T 2687 , F 89, S 8, H T 3569, I/A 69 (10.02.20).
12 de Febrero de 2020Otros conceptos: Cambida la denominación del socio único TREDI, SA, siendo el actual TREDI, SAS -Sociedad por accionessimplificada, así como su domicilio social.- Datos registrales. T 1454 , F 145, S 8, H T 3569, I/Anota2 ( 5.02.20).
07 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ESTEVEZ MUÑOZ JUAN JOSE;CARMONA LAURENT SERGE. Apoderado: SOLORZANO BALSERAJOSEFA. Datos registrales. T 2687 , F 83, S 8, H T 3569, I/A 68 (27.09.19).
04 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Secretario: PAZ FERNANDEZ FRANCISCO. Consejero: MANENT OSTARIZ LUIS. Presidente: MANENTOSTARIZ LUIS. Consejero: PAUL CALOT PHILIPPE GERARD CLAUDE;MORINEAU FRANCK VICTOR JULES. Nombramientos.Consejero: CARMONA LAURENT SERGE. Presidente: CARMONA LAURENT SERGE. Consejero: MORINEAU FRANCK VICTORJULES;ESTEVEZ MUÑOZ JUAN JOSE;PAZ FERNANDEZ FRANCISCO. SecreNoConsj: SOLORZANO BALSERA JOSEFA. Datosregistrales. T 2687 , F 82, S 8, H T 3569, I/A 67 (27.09.19).
13 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MONNIER CHRISTIAN MARCEL. Nombramientos. Consejero: MORINEAU FRANCK VICTORJULES. Datos registrales. T 2687 , F 49, S 8, H T 3569, I/A 66 ( 6.02.19).
30 de Julio de 2018Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITE SL. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SOCIEDADLIMITADA. Datos registrales. T 2687 , F 49, S 8, H T 3569, I/A 65 (23.07.18).
08 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: PHILIPPE CALOT. Nombramientos. Consejero: PAUL CALOT PHILIPPE GERARD CLAUDE.Datos registrales. T 2687 , F 49, S 8, H T 3569, I/A 64 (27.04.18).
02 de Agosto de 2017Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITE SL. Datos registrales.T 2687 , F 48, S 8, H T 3569, I/A 63 (26.07.17).
24 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MANENT OSTARIZ LUIS. Presidente: MANENT OSTARIZ LUIS. Nombramientos. Consejero:MANENT OSTARIZ LUIS. Presidente: MANENT OSTARIZ LUIS. Datos registrales. T 2687 , F 48, S 8, H T 3569, I/A 62 (15.05.17).
10 de Agosto de 2016Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales.T 2687 , F 48, S 8, H T 3569, I/A 61 ( 2.08.16).
11 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BLOND CHRISTIAN. Nombramientos. Consejero: MONNIER CHRISTIAN MARCEL. Datosregistrales. T 2687 , F 47, S 8, H T 3569, I/A 60 ( 4.07.16).
03 de Agosto de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITE SL. Datos registrales.T 2687 , F 47, S 8, H T 3569, I/A 59 (27.07.15).
27 de Julio de 2015Otros conceptos: Modifcación del artículo 31º de los Estatutos sociales.- Retribución del cargo.- Datos registrales. T 2687 , F 47, S8, H T 3569, I/A 58 (14.07.15).
29 de Julio de 2014Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales.T 2687 , F 46, S 8, H T 3569, I/A 57 (18.07.14).
20 de Mayo de 2014Otros conceptos: Cambiado el domicilio social del accionista único, la mercantil "TREDI, SA".- Datos registrales. T 1454 , F 145, S8, H T 3569, I/ANOTA1 ( 8.05.14).
30 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: CAMPAMA CUSCO JOSE. Nombramientos. Apoderado: ROVIRA GARRIGA SERGIO. Datosregistrales. T 2687 , F 45, S 8, H T 3569, I/A 56 (18.12.13).
11 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: BLOND CHRISTIAN;LAURENT JEAN PIERRE. Nombramientos. Consejero: PHILIPPECALOT;BLOND CHRISTIAN. Datos registrales. T 2687 , F 45, S 8, H T 3569, I/A 55 ( 4.10.13).
29 de Julio de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales.T 2687 , F 45, S 8, H T 3569, I/A 54 (18.07.13).
02 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MANENT OSTARIZ LUIS. Presidente: MANENT OSTARIZ LUIS. Consejero: LAURENT JEANPIERRE. Nombramientos. Consejero: MANENT OSTARIZ LUIS. Presidente: MANENT OSTARIZ LUIS. Consejero: LAURENT JEANPIERRE. Datos registrales. T 2687 , F 44, S 8, H T 3569, I/A 51 (20.07.12).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA SOLERA ANA MARIA. Datos registrales. T 2687 , F 44, S 8, H T 3569, I/A 52 (20.07.12).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2687 , F 44, S 8, H T 3569, I/A 53 (23.07.12).
15 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: SOLORZANO BALSERA JOSEFA. Datos registrales. T 1454 , F 145, S 8, H T 3569, I/A 50 ( 5.06.12).
03 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1454 , F 144, S 8, H T 3569, I/A 49 (26.07.11).
12 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA SOLERA ANA MARIA. Nombramientos. Secretario: PAZ FERNANDEZ FRANCISCO.Datos registrales. T 1454 , F 144, S 8, H T 3569, I/A 48 ( 1.04.11).
06 de Agosto de 2010Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales.T 1454 , F 144, S 8, H T 3569, I/A 47 (28.07.10).
23 de Noviembre de 2009Modificaciones estatutarias. 31. Otros.-Retribucion administradores. Datos registrales. T 1454 , F 144, S 8, H T 3569, I/A 46(11.11.09).
11 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1454 , F 86, S 8, H T 3569, I/A 45 (24.07.09).