Actos BORME de Vancoval Mediterraneo Sociedad Anonima
28 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ COLLADO PEDRO;ACINAS GARCIA JULIO;MORENO CARRASCO JOSEVICTORIANO;CATALAN GOMEZ SANTIAGO MIGUEL. Presidente: CATALAN GOMEZ SANTIAGO MIGUEL. Vicepresid.: MARTINEZCOLLADO PEDRO. Secretario: VERDU ORTIZ ANDRES. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1283/2014. FIRME: Si,Fecha de resoluci贸n 29/01/2015. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEVALENCIA. Juez: JOSE MARIA CUTILLAS TORNS. Resoluciones: Se declara de estado de concurso voluntario de la mercantil. Sedeclara la conclusi贸n del concurso por insuficiencia de la masa activa. Se declara la disoluci贸n de la sociedad y el cierre o cancelaci贸nde la hoja registral y asimismo su extinci贸n. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 7039, L 4342, F 9, S 8, H V80505, I/A 21 (21.05.15).
17 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ COLLADO PEDRO. Vicepresid.: CATALAN GOMEZ SANTIAGO MIGUEL.Nombramientos. Presidente: CATALAN GOMEZ SANTIAGO MIGUEL. Vicepresid.: MARTINEZ COLLADO PEDRO. Reelecciones.Secretario: VERDU ORTIZ ANDRES. Datos registrales. T 7039, L 4342, F 9, S 8, H V 80505, I/A 20 (10.10.13).
05 de Abril de 2013Cambio de domicilio social. C/ FINLANDIA 23 BAJO (VALENCIA). Datos registrales. T 7039, L 4342, F 9, S 8, H V 80505, I/A 19(28.03.13).
12 de Julio de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 528.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 72.000,00 Euros. Datos registrales. T 7039, L4342, F 8, S 8, H V 80505, I/A 18 ( 3.07.12).
04 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ FERNANDEZ JAVIER. Apoderado: VIDALLACH BLAZQUEZ AMPARO. Apo.Sol.: MARCOPALACIOS CARMEN;DE CACHAVERA MARCO JOSE LUIS;GOMEZ CERVERA JUAN MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.:MORENO CARRASCO JOSE VICTORIANO. Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: CATALAN GOMEZ SANTIAGOMIGUEL;MARTINEZ COLLADO PEDRO;ACINAS GARCIA JULIO;MORENO CARRASCO JOSE VICTORIANO. Datos registrales. T7039, L 4342, F 8, S 8, H V 80505, I/A 17 (23.04.12).
20 de Febrero de 2012Cambio de domicilio social. G.V. FERNANDO EL CATOLICO 5 BAJO (VALENCIA). Datos registrales. T 7039, L 4342, F 8, S 8, HV 80505, I/A 16 ( 9.02.12).
17 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: CATALAN GOMEZ SANTIAGO MIGUEL. Vicepresid.: MARTINEZ COLLADO PEDRO.Nombramientos. Presidente: MARTINEZ COLLADO PEDRO. Vicepresid.: CATALAN GOMEZ SANTIAGO MIGUEL. Reelecciones.Consejero: MARTINEZ COLLADO PEDRO;ACINAS GARCIA JULIO;MORENO CARRASCO JOSE VICTORIANO;CATALAN GOMEZ
09 de Febrero de 2010Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 7039, L 4342, F 7, S 8, H V 80505, I/A 14 (29.01.10).
15 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ COLLADO PEDRO. Vicepresid.: CATALAN GOMEZ SANTIAGO MIGUEL. Secretario:VERDU ORTIZ ANDRES. Nombramientos. Secretario: VERDU ORTIZ ANDRES. Presidente: CATALAN GOMEZ SANTIAGOMIGUEL. Vicepresid.: MARTINEZ COLLADO PEDRO. Otros conceptos: Los cargos de los miembros del Consejo ser谩n efectivosdesde el d铆a 21 de septiembre de 2009, de conformidad con la RDGRN de 6 de junio de 2009. Datos registrales. T 7039, L 4342, F 7,S 8, H V 80505, I/A 13 ( 3.12.09).
30 de Marzo de 2009Cambio de domicilio social. C/ MAYOR 42 (PATERNA). Datos registrales. T 7039, L 4342, F 7, S 8, H V 80505, I/A 12 (18.03.09).