Actos BORME de Vasco Catalana De Consignaciones Sociedad Anonima
28 de Marzo de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 99.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 696.880,00 Euros. Datos registrales. T 4879 , F 44,S 8, H BI 4773,A , I/ 91 .(15.03.23).
21 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: TEMIS AUDICON SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 44, S 8, H BI 4773,A , I/ 89 .(7.12.22).
Revocaciones. Apoderado: URRUTIA LIBARONA MIKEL. Datos registrales. T 4879 , F 44, S 8, H BI 4773,A , I/ 90 .(13.12.22).
25 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: ALAVA MARTIN JOSE LUIS;BENGOETXEA MARTIN DIONISIO. Datos registrales. T 4879 , F 44, S 8,H BI 4773,A , I/ 88 .(11.10.22).
10 de Marzo de 2022Reelecciones. Consejero: AZARLOZA GONZALEZ KEPA;AZARLOZA GONZALEZ JON;AZARLOZA GONZALEZXABIER;CABALLERO LASKIBAR ENEKO. Con.Delegado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Datos registrales. T 4879 , F 44, S 8, H BI4773,A , I/ 87 .( 3.03.22).
03 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: TEMIS AUDICON SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 43, S 8, H BI 4773,A , I/ 85.(24.12.21).
Reelecciones. Auditor: TEMIS AUDICON SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 44, S 8, H BI 4773,A , I/ 86.(24.12.21).
31 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: VIDAL ALAPONT MARIA AMPARO;MARTIN MENA GUADALUPE;VERDE CABALLERO JOSEMIGUEL;FEBLES MORALES ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 4879 , F 43, S 8, H BI 4773,A , I/ 84 .(21.07.20).
17 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: AZARLOZA GOIRIA KEPA. Consejero: AZARLOZA GOIRIA KEPA. Nombramientos. Presidente:AZARLOZA GONZALEZ JON. Otros conceptos: Establecer en cuatro el n煤mero de miembros del consejo de administraci贸n. Datosregistrales. T 4879 , F 43, S 8, H BI 4773,A , I/ 83 .( 9.10.19).
22 de Febrero de 2019P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 4879 , F 43, S 8, H BI 4773,A , I/ 82 .(14.02.19).
18 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: FEBLES MORALES ENRIQUE CARLOS. Datos registrales. T 4879 , F 43, S 8, H BI 4773,A , I/ 81 .(4.12.18).
03 de Abril de 2018Nombramientos. Auditor: TEMIS AUDICON SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 42, S 8, H BI 4773,A , I/ 80.(23.03.18).
21 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: PASCUAL NATIVIDAD JOSE. Datos registrales. T 4879 , F 42, S 8, H BI 4773,A , I/ 79 .(12.02.18).
27 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: VERDE CABALLERO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 4879 , F 42, S 8, H BI 4773,A , I/ 78.(20.10.17).
19 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Datos registrales. T 4879 , F 42, S 8, H BI 4773,A , I/ 77 .(10.10.17).
16 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Datos registrales. T 4879 , F 42, S 8, H BI 4773,A , I/ 76 .( 5.10.17).
11 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Datos registrales. T 4879 , F 41, S 8, H BI 4773,A , I/ 74 .( 2.10.17).
Nombramientos. Apoderado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Datos registrales. T 4879 , F 41, S 8, H BI 4773,A , I/ 75 .( 2.10.17).
29 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Datos registrales. T 4879 , F 41, S 8, H BI 4773,A , I/ 73 .(19.06.17).
18 de Abril de 2017Reelecciones. Consejero: AZARLOZA GOIRIA KEPA;AZARLOZA GONZALEZ KEPA;AZARLOZA GONZALEZ JON;AZARLOZAGONZALEZ XABIER;CABALLERO LASKIBAR ENEKO. Con.Delegado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Datos registrales. T 4879 , F41, S 8, H BI 4773,A , I/ 72 .( 3.04.17).
15 de Marzo de 2017Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 41, S 8, H BI 4773,A , I/ 71 .(6.03.17).
16 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: BARRIUSO GOMEZ ISMAEL. Datos registrales. T 4879 , F 41, S 8, H BI 4773,A , I/ 70 .( 3.03.16).
26 de Agosto de 2014Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 40, S 8, H BI 4773,A , I/ 69.(13.08.14).
09 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: MEDRANO PEREZ PEDRO ALBERTO. Datos registrales. T 4879 , F 40, S 8, H BI 4773,A , I/ 68.(29.04.13).
12 de Marzo de 2013Revocaciones. Apoderado: LONGHURST RAMOS DAVID LUIS. Datos registrales. T 4879 , F 39, S 8, H BI 4773,A , I/ 66.(28.02.13).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MENA GUADALUPE. Datos registrales. T 4879 , F 40, S 8, H BI 4773,A , I/ 67 .(28.02.13).
23 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: BARRIUOSO GOMEZ ISMAEL. Datos registrales. T 4879 , F 39, S 8, H BI 4773,A , I/ 65 .(10.10.12).
07 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: LAVIN GONZALEZ JON MIKEL;BERASALUCE RIVAS IGOR;GONZALEZ MOLERO RAUL. Datosregistrales. T 4879 , F 39, S 8, H BI 4773,A , I/ 64 .(23.05.12).
01 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: FERRER MU脩OZ-SECA JAVIER. Revocaciones. Apoderado: FERRER MU脩OZ-SECAJAVIER;FERRER MU脩OZ-SECA JAVIER. Consejero: AZARLOZA GOIRIA KEPA;AZARLOZA GONZALEZ XAVIER;AZARLOZAGONZALEZ KEPA;AZARLOZA GONZALEZ JON;CABALLERO LASKIBAR ENEKO. Presidente: AZARLOZA GOIRIA KEPA.Secretario: EGUIA ISPIZUA JOSE. Con.Delegado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Nombramientos. Consejero: AZARLOZA GOIRIAKEPA;AZARLOZA GONZALEZ KEPA;AZARLOZA GONZALEZ JON;AZARLOZA GONZALEZ XABIER;CABALLERO LASKIBARENEKO. Presidente: AZARLOZA GOIRIA KEPA. Con.Delegado: AZARLOZA GONZALEZ JON. Secretario: EGUIA ISPIZUA JOSE.Datos registrales. T 4879 , F 37, S 8, H BI 4773,A , I/ 61 .(14.02.12).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INVERSIONES ERGOIEN SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 38,S 8, H BI 4773,A , I/ 62 .(14.02.12).
Nombramientos. Apoderado: URRUTIA LIBARONA MIKEL. Datos registrales. T 4879 , F 38, S 8, H BI 4773,A , I/ 63 .(14.02.12).
17 de Agosto de 2011Nombramientos. Auditor: MP4 AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4879 , F 37, S 8, H BI 4773,A , I/ 60.(22.07.11).
06 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: VIDAL ALAPONT MARIA AMPARO. Datos registrales. T 4879 , F 37, S 8, H BI 4773,A , I/ 59.(20.04.11).
28 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: AZARLOZA GONZALEZ XABIER. Datos registrales. T 4879 , F 37, S 8, H BI 4773,A , I/ 58.(15.03.11).
24 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: LONGHURST RAMOS DAVID LUIS. Datos registrales. T 4879 , F 36, S 8, H BI 4773,A , I/ 57.(12.01.11).