Buscador CIF Logo

Actos BORME Vayper Galicia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Vayper Galicia Sl

Actos BORME Vayper Galicia Sl - B15213580

Tenemos registrados 34 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Vayper Galicia Sl con CIF B15213580

馃敊 Perfil de Vayper Galicia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Vayper Galicia Sl

15 de Octubre de 2021
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 37924 , F 99, S 8, H M 675307, I/A 11 ( 7.10.21).

13 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: ROMAN SANCHEZ-RUBIO JOSE LUIS. Datos registrales. T 37924 , F 97, S 8, H M 675307, I/A 10 (6.03.20).

11 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ BRAVO SERGIO. Datos registrales. T 37924 , F 95, S 8, H M 675307, I/A 7 ( 4.11.19).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ OJEDA ELOY. Datos registrales. T 37924 , F 97, S 8, H M 675307, I/A 8 ( 4.11.19).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ OJEDA ELOY. Nombramientos. Adm. Mancom.: ROMAN SANCHEZ-RUBIOJOSE LUIS. Datos registrales. T 37924 , F 97, S 8, H M 675307, I/A 9 ( 4.11.19).

21 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Apo.Sol.: VILLARINO TEJADA JUAN CARLOS. Apo.Manc.:VILLARINO TEJADA JUAN CARLOS. Apo.Sol.: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE LUIS.Apo.Man.Soli: ORNELAS VALLE IRMA GUADALUPE. Apo.Sol.: PARRA LOPEZ CARLOS MARIA. Datos registrales. T 37924 , F 94,S 8, H M 675307, I/A 6 (14.01.19).

19 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: ALONSO SOROA VALENTIN. Datos registrales. T 37924 , F 91, S 8, H M 675307, I/A 5 (12.11.18).

17 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALONSO SOROA VALENTIN. Nombramientos. Adm. Mancom.: ALONSO SOROAVALENTIN;DURAN REGIS MARTHA ANGELICA;FERNANDEZ OJEDA ELOY. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 37924 , F 91, S 8, H M 675307, I/A 4 (9.10.18).

18 de Julio de 2018
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n y nueva redacci贸n de la totalidad de los estatutos sociales.. Cambio de domicilio social.C/ SAN NORBERTO 48 (MADRID). Cambio de objeto social. La adquisici贸n y/o explotaci贸n, de intercambiadores de transporte y deestaciones terminales y/o -apeaderos de autobuses, as铆 como los servicios inherentes occiinPrerhentarios de tal actividad b) Lacreaci贸n, organizaci贸n y explotaci贸n de todo tipo de servicios de comidas y bebidas: restaurantes y. Datos registrales. T 37924 , F87, S 8, H M 675307, I/A 2 (10.07.18).

14 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: DURAN REGIS MARTHA ANGELICA. Apo.Sol.: DURAN REGIS MARTHA ANGELICA. Datosregistrales. T 877 , F 110, S 8, H OR 291, I/A 35 ( 7.05.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: TRIGUEROS RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 898 , F 127, S 8, H OR 291, I/A 36 (7.05.18).

06 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: DUPERIER PRADO ARTURO JAVIER. Datos registrales. T 877 , F 108, S 8, H OR 291, I/A 31(25.10.17).

Nombramientos. Apoderado: HERREROS SIERRA JOSE MARIA. Datos registrales. T 877 , F 109, S 8, H OR 291, I/A 32(25.10.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ BRAVO FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: PEREZ BRAVO FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 877 , F 110, S 8, H OR 291, I/A 33 (25.10.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: MERCADO GOMEZ WILFRIDO. Apoderado: GONZALEZ LOZANO LIGIA CLAUDIA. Datos registrales. T877 , F 110, S 8, H OR 291, I/A 34 (25.10.17).

24 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 862 , F 105, S 8, H OR 291, I/A 20(16.08.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORNELAS VALLE IRMA GUADALUPE. Datos registrales. T 877 , F 98, S 8, H OR 291, I/A 21(16.08.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ DE DIEGO ELOISA. Datos registrales. T 877 , F 100, S 8, H OR 291, I/A 22 (16.08.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA DE LEANIZ CANOSA IGNACIO CESAR. Datos registrales. T 877 , F 101, S 8, H OR 291,I/A 23 (16.08.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ FERNANDEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 877 , F 102, S 8, H OR 291, I/A 24(16.08.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA JULIO RAMON. Datos registrales. T 877 , F 103, S 8, H OR 291, I/A 25 (16.08.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: HIDALGO SALCEDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 877 , F 104, S 8, H OR 291, I/A 26 (16.08.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DOMINGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO;PEREZ MARTINEZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 877 , F 105, S 8, H OR 291, I/A 27 (16.08.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA PASTOR ANTONIO. Datos registrales. T 877 , F 106, S 8, H OR 291, I/A 28 (16.08.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: PARRA LOPEZ CARLOS MARIA. Datos registrales. T 877 , F 107, S 8, H OR 291, I/A 29 (16.08.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: TRIGUEROS RODRIGUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 877 , F 108, S 8, H OR 291, I/A 30(16.08.16).

28 de Junio de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ OJEDA ELOY. Datos registrales. T 862 , F 103, S 8, H OR 291, I/A 19 (17.06.16).

29 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: VILLARINO TEJADA JUAN CARLOS. Apo.Manc.: VILLARINO TEJADA JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 371 , F 90, S 8, H OR 291, I/A 17 (20.05.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: DEL SOL RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales.T 862 , F 103, S 8, H OR 291, I/A 18 (20.05.15).

04 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ TORRALBA FLORENTINO JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: ALONSO SOROAVALENTIN. Datos registrales. T 371 , F 88, S 8, H OR 291, I/A 13 (17.04.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ ANTON JOSE ANTONIO;URIARTE AMANN JUAN CARLOS;PEREZ ALONSOAURELIO;MERCADO GOMEZ WILFRIDO. Datos registrales. T 371 , F 88, S 8, H OR 291, I/A 14 (17.04.15).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LOZANO LIGIA CLAUDIA. Datos registrales. T 371 , F 89, S 8, H OR 291, I/A 15(17.04.15).

Nombramientos. Apoderado: LOZANO BONFIL LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 371 , F 90, S 8, H OR 291, I/A 16(17.04.15).

11 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ BRAVO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: PEREZ BRAVO FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 371 , F 87, S 8, H OR 291, I/A 12 (30.11.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n