Buscador CIF Logo

Actos BORME Velaboit Opportunities Sicav Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Velaboit Opportunities Sicav Sa

Actos BORME Velaboit Opportunities Sicav Sa - A82725706

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Velaboit Opportunities Sicav Sa con CIF A82725706

馃敊 Perfil de Velaboit Opportunities Sicav Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Velaboit Opportunities Sicav Sa

01 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SOSTRES LUCAS RAMON;TOLEDANO VILLA DOLORES-PILAR;NOUVILAS ALOS ALBERTO.Secretario: NOUVILAS ALOS ALBERTO. Presidente: SOSTRES LUCAS RAMON. Ent. Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT SASGIIC. EntidDeposit: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. Auditor: KPMG AUDITORES SL. VsecrNoConsj: LOUREIROBOTANA CONCEPCION. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Revocaciones.Apoderado: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC. Nombramientos. LiquiSoli: SOSTRES LUCAS RAMON;NOUVILAS ALOSALBERTO;TOLEDANO VILLA DOLORES-PILAR. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 31578 , F 165, S 8, H M258799, I/A 42 (25.01.19).

28 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. EntidDeposit: BANCO DEPOSITARIO BBVA SA. Nombramientos. EntidDeposit: BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA SA. Modificaciones estatutarias. 1. Denominaci贸n social y designaci贸n de depositario.. 9. Organos de la sociedad..Datos registrales. T 31578 , F 165, S 8, H M 258799, I/A 41 (20.09.17).

20 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 31578 , F 164, S 8, H M 258799, I/A 40 (11.09.17).

23 de Mayo de 2016
Otros conceptos: FIJADAS NUEVAS CIFRAS DE CAPITAL ESTATUTARIO MINIMO Y MAXIMO, QUE QUEDAN ESTABLECIDASEN 6.000.002,70E Y 60.000.027E, RESPECTIVAMENTE. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 36& LAPUBLICACION DEL ACTO DE OTROS ACTOS INSCRIBIBLES. Datos registrales. T 31578 , F 163, S 8, H M 258799, I/A 36 (5.01.15).

21 de Enero de 2016
Revocaciones. Apoderado: ESCOBAR DE LA TORRE GREGORIO;JUAREZ SARDINERO GREGORIO;PEREZ GARRIGUESRICARDO;SANCHEZ MOLINA RAFAEL;MOLINA DEL POZO ELENA;CESPEDES LEON ARACELI. Apo.Sol.: ARRIMADAS GARCIAPILAR MARIA. Apoderado: BBVA PATRIMONIOS GESTORA SGIIC SA. Datos registrales. T 31578 , F 164, S 8, H M 258799, I/A 39(13.01.16).

20 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PETTENATI MICHELE. Presidente: PETTENATI MICHELE. Con.Delegado: PETTENATI MICHELE.Secretario: SOSTRES LUCAS RAMON. Consejero: MARTINEZ ALBADALEJO PEDRO MANUEL. Nombramientos. Consejero:TOLEDANO VILLA DOLORES-PILAR;NOUVILAS ALOS ALBERTO. Secretario: NOUVILAS ALOS ALBERTO. Presidente: SOSTRESLUCAS RAMON. Datos registrales. T 31578 , F 163, S 8, H M 258799, I/A 38 (13.01.16).

21 de Septiembre de 2015
Cambio de domicilio social. C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID). Datos registrales. T 31578 , F 163, S 8, H M 258799, I/A 37(11.09.15).

13 de Enero de 2015
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 31578 , F163, S 8, H M 258799, I/A 36 ( 5.01.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n