Buscador CIF Logo

Actos BORME Ventillainver Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ventillainver Sa

Actos BORME Ventillainver Sa - A79561445

Tenemos registrados 27 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ventillainver Sa con CIF A79561445

馃敊 Perfil de Ventillainver Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ventillainver Sa

30 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 35454 , F 199, S 8, H M 12196, I/A 44 (23.05.23).

25 de Mayo de 2023
Reelecciones. Consejero: CANETONIN SL;ANGERAN SL;VALDEQUINILLA SL. Datos registrales. T 35454 , F 199, S 8, H M12196, I/A 43 (18.05.23).

13 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 35454 , F 198, S 8, H M 12196, I/A 42 ( 2.12.21).

21 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Datos registrales. T 35454 , F 198, S 8, H M 12196, I/A 41 (14.12.20).

31 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ CALVOGERARDO. Datos registrales. T 35454 , F 197, S 8, H M 12196, I/A 40 (23.12.19).

19 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Consejero: MAHOU HERRAIZ JOSE ANTONIO;CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 35454 , F 197, S 8, H M 12196, I/A 39 (12.11.19).

03 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 35454 , F 196, S 8, H M 12196, I/A 38 (26.06.19).

18 de Enero de 2019
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Nombramientos. VsecrNoConsj: SILVA RUIZ DEL OLMOBLANCA. Datos registrales. T 35454 , F 196, S 8, H M 12196, I/A 37 (10.01.19).

19 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 35454 , F 196, S 8, H M 12196, I/A 36 (11.07.18).

31 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 35454 , F 195, S 8, H M 12196, I/A 35 (21.08.17).

26 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ DEL HIERRO PEREZ MINGUEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan:VARELA TORRES NURIA MARTA. Datos registrales. T 35454 , F 195, S 8, H M 12196, I/A 34 (18.07.17).

23 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Nombramientos. Consejero: CANETONIN SL;ANGERANSL;VALDEQUINILLA SL. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Representan: PETROSSI VALDES EDUARDOALFREDO;LOPEZ DEL HIERRO PEREZ MINGUEZ FRANCISCO JAVIER;RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO. Presidente:GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Modificaciones estatutarias. Se modifican los estatutos sociales mediante la aprobaci贸n deun nuevo texto. Ampliacion del objeto social. La suscripci贸n, compra, venta y tenencia de valores mobiliarios, acciones,obligaciones, bonos, participaciones sociales y cualquier otro tipo de t铆tulo valor de cualquier tipo de sociedades civiles o mercantiles.Datos registrales. T 12554 , F 225, S 8, H M 12196, I/A 33 (13.06.17).

13 de Febrero de 2017
Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Fe deerratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 32 la reelecci贸n de presidente y vicepresidente siendo lo correcto el nombramientocomo presidente de do帽a Ana Francisca Gerv谩s Hierro y como vicepresidente de do帽a Christelle Eva Gerv谩s Germina. Datosregistrales. T 12554 , F 225, S 8, H M 12196, I/A 32 ( 9.12.16).

16 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datos registrales.T 12554 , F 225, S 8, H M 12196, I/A 32 ( 9.12.16).

19 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datos

20 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 12554 , F 225, S 8, H M 12196, I/A 30 (12.06.14).

16 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MARIA MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 12554 , F 224, S 8, H M 12196, I/A 29 ( 9.12.13).

17 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA.

15 de Octubre de 2013
Nombramientos. Auditor: ATA AUDITORES SL. Datos registrales. T 12554 , F 223, S 8, H M 12196, I/A 27 ( 7.10.13).

11 de Julio de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: CALVO CAMINERO MARIA MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 12554 , F 222, S 8, H M 12196, I/A 26 ( 3.07.13).

03 de Julio de 2012
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINEROMERCEDES. Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA.Datos registrales. T 12554 , F 222, S 8, H M 12196, I/A 25 (21.06.12).

27 de Junio de 2012
Cambio de domicilio social. C/ GUZMAN EL BUENO 133 - PLANTA 9& (MADRID). Datos registrales. T 12554 , F 222, S 8, H M12196, I/A 24 (15.06.12).

15 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 12554 , F 222, S 8, H M 12196, I/A 23 ( 3.06.11).

17 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Secretario: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE.Nombramientos. SecreNoConsj: TRIGO SIERRA LUIS. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVASGERMINA CHRISTELLE EVA. VsecrNoConsj: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Datos registrales. T 12554 , F 221, S 8, H M12196, I/A 22 ( 7.09.10).

29 de Octubre de 2009
Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. SecreNoConsj: DIAZ ALBISU JOSE LUIS. Consejero:GERVAS DIEZ GERMAN. Presidente: GERVAS DIEZ GERMAN. Con.Delegado: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. SecreNoConsj: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 12554 , F 218, S 8, H M 12196, I/A 19 (16.10.09).

Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 12554 , F 219, S 8, H M 12196, I/A 20 (19.10.09).

Nombramientos. Apoderado: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE;CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 12554 , F 220, S 8, H M 12196, I/A 21 (19.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n