Actos BORME de Veravic Sl
26 de Julio de 2023Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANCHEZ MARCOS. Datos registrales. T 1051, L 878, F 162, S 8, H CC 189, I/A 47 (5.07.23).
Nombramientos. Apoderado: FLORES FRUTOS DAVID. Datos registrales. T 1051, L 878, F 163, S 8, H CC 189, I/A 48 ( 5.07.23).
02 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL;GONZALEZ VELA CARLOS;DE LOSSANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 162, S 8, H CC 189, I/A 45 (22.02.23).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL;MORALEDA OLIVARES MOISES JOSE;GONZALEZ VELACARLOS;DE LOS SANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 162, S 8, H CC 189, I/A 46 (22.02.23).
16 de Febrero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GODINO MORENO YOLANDA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 162, S 8, H CC 189, I/A 42 ( 6.02.23).
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ GRANDE RAFAEL. Datos registrales. T 1051, L 878, F 162, S 8, H CC 189, I/A 44 (6.02.23).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANCHEZ MARCOS. Datos registrales. T 1051, L 878, F 162, S 8, H CC 189, I/A 43 (6.02.23).
29 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 161, S 8, H CC 189, I/A 39(22.12.21).
Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL;GONZALEZ VELA CARLOS;DELOS SANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 161, S 8, H CC 189, I/A 40 (22.12.21).
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1051, L 878, F 162, S 8, H CC 189, I/A 41 (22.12.21).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HUETE GEMMA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 161, S 8, H CC 189, I/A 38(25.10.21).
09 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MANZANO EVA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 160, S 8, H CC 189, I/A 36(27.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: HERRAIZ MONTERO MARIA DE LA CARIDAD;ARIAS DEL BARCO MARIA MONTSERRAT;GODINOMORENO YOLANDA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 160, S 8, H CC 189, I/A 37 (27.05.21).
02 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ GRANDE FRANCISCO. Apo.Sol.: MORENO MU脩OZ CARLOS;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL.Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 160, S 8, H CC 189, I/A 35 (19.02.21).
10 de Febrero de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AVICOLA VMR SL. Datos registrales. T1051, L 878, F 159, S 8, H CC 189, I/A 33 ( 2.02.21).
Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 8 de los estatutos sociales relativo a la transmisi贸n de las participaciones sociales, y sea帽ade el art铆culo 8 bis relativo a la prenda sobre las participaciones. Datos registrales. T 1051, L 878, F 159, S 8, H CC 189, I/A 34 (2.02.21).
08 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: VALERO MARTINEZ IRENE. Datos registrales. T 1051, L 878, F 159, S 8, H CC 189, I/A 32 (29.09.20).
07 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MU脩OZ MARTIN ALVARO;GONZALEZ MARTINEZ IGNACIO;CARPINTERO GARCIA ARIASBORJA;PUYOL CAVERO JORGE;NOVO MARTIN ENRIQUE. Datos registrales. T 1051, L 878, F 158, S 8, H CC 189, I/A 31(28.08.20).
29 de Julio de 2020Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ GRANDE RAFAEL. Datos registrales. T 422, L 250, F 209, S 8, H CC 189, I/A 24(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: SANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 143, S 8, H CC 189, I/A 25(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ VELA CARLOS. Datos registrales. T 1051, L 878, F 147, S 8, H CC 189, I/A 26(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: CARBAYO CARBAYO SANTOS. Datos registrales. T 1051, L 878, F 153, S 8, H CC 189, I/A 27(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 153, S 8, H CC 189, I/A 28(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: VALERO MARTINEZ IRENE. Datos registrales. T 1051, L 878, F 153, S 8, H CC 189, I/A 29(21.07.20).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HUETE GEMMA. Datos registrales. T 1051, L 878, F 153, S 8, H CC 189, I/A 30(21.07.20).
23 de Abril de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ DE LAIGLESIA PAN CARLOS JOSE;GARCIA-BOENTE DAVILA ANA. Datos registrales. T422, L 250, F 208, S 8, H CC 189, I/A 21 (27.03.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: VAZQUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 422, L 250, F 208, S 8, H CC 189, I/A 22(27.03.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO AVICOLA VMR SL. Nombramientos. Adm. Unico:GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AVICOLA VMR SL. Datos registrales. T 422, L 250, F 209, S 8, H CC 189, I/A 23 (27.03.20).
16 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: VILLANUEVA ROMERO MONICA. Datos registrales. T 422, L 250, F 208, S 8, H CC 189, I/A 20 (9.07.19).
07 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: KRESTON IBERAUDIT MADRID SLP. Datos registrales. T 422, L 250, F 208, S 8, H CC 189, I/A 19(22.01.19).
02 de Febrero de 2018Nombramientos. Auditor: KRESTON IBERAUDIT MADRID SLP. Datos registrales. T 422, L 250, F 208, S 8, H CC 189, I/A 18(22.01.18).
06 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MORENO MU脩OZ JOSE ANTONIO;MORENO MU脩OZ CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico:GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO AVICOLA VMR SL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 422, L 250, F 66, S 8, H CC 189, I/A 15 (29.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO MU脩OZ CARLOS;VAZQUEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL;VAZQUEZ GRANDE RAFAEL. Datosregistrales. T 422, L 250, F 66, S 8, H CC 189, I/A 16 (29.09.16).
06 de Noviembre de 2014Nombramientos. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES MADRID SLP. Datos registrales. T 422, L 250, F 66, S 8, H CC 189, I/A 14(30.10.14).
09 de Septiembre de 2013Otros conceptos: Se conceden incentivos regionales que se concretan en una subvenci贸n a fondo perdido por un importe de1.047.121,05 resultado de aplicar el porcentaje del 15% a la inversi贸n aprobada de 6.980.807,00 euros. Datos registrales. T 183, L12, F 34, S 8, H CC 189, I/A 1 4 ( 2.09.13).
04 de Enero de 2012Nombramientos. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES MADRID SLP. Datos registrales. T 422, L 250, F 66, S 8, H CC 189, I/A 13(12.12.11).
08 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.900.061,50 Euros. Resultante Suscrito: 1.998.595,45 Euros. Datos registrales. T 422, L 250, F 64,S 8, H CC 189, I/A 11 (27.10.11).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.099.950,20 Euros. Resultante Suscrito: 3.098.545,65Euros. Datos registrales. T 422, L 250, F 65, S 8, H CC 189, I/A 12 (27.10.11).
23 de Marzo de 2011Ampliacion del objeto social. El desarrollo de explotacones agr铆colas y ganaderas, en especial av铆colas.La explotaci贸n de campos,granjas. Cambio de domicilio social. C/ CANDALEA S/N (CUACOS DE YUSTE). Datos registrales. T 422, L 250, F 64, S 8, H CC189, I/A 10 (11.03.11).
29 de Enero de 2010Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO AVICOLA VMR SL. Datos registrales. T422, L 250, F 64, S 8, H CC 189, I/A 9 (19.01.10).
10 de Febrero de 2009Nombramientos. Auditor: GESTION DE ANALISIS Y AUDITORIAS SL. Datos registrales. T 422, L 250, F 64, S 8, H CC 189, I/A 8(19.01.09).