Actos BORME de Verdiales Sl
02 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: TORRES LOPEZ JORDI. Datos registrales. T 5935 , F 20, S 8, H SE 12249, I/A 70 (25.07.23).
06 de Junio de 2023Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 19, S 8, H SE 12249, I/A 69 (30.05.23).
21 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 19, S 8, H SE 12249, I/A 68 (10.11.22).
18 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MARTI SOPENA SARA;SCHRODER ANDREA PATRICIA;PONS GOMEZ MARIA;TANTINYA CUNI ANNA.Datos registrales. T 5935 , F 19, S 8, H SE 12249, I/A 67 ( 9.03.22).
21 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: ALBERTO SASTRE EDUARD. Apo.Sol.: ALBERTO SASTRE EDUARD. Datos registrales. T 5935 , F18, S 8, H SE 12249, I/A 66 (14.12.21).
20 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBERTO SASTRE EDUARD. Secretario: ALBERTO SASTRE EDUARD. Vicepresid.: ALBERTOSASTRE EDUARD. Nombramientos. Consejero: SAURET REQUENA MIREYA. Secretario: SAURET REQUENA MIREYA. Datosregistrales. T 5935 , F 18, S 8, H SE 12249, I/A 65 (13.12.21).
18 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAURET REQUENA MIREYA. Datos registrales. T 5935 , F 17, S 8, H SE 12249, I/A 64 ( 6.10.21).
19 de Julio de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 17, S 8, H SE 12249, I/A 63 ( 6.07.21).
21 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 16, S 8, H SE 12249, I/A 62 (13.08.20).
13 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 16, S 8, H SE 12249, I/A 61 ( 4.03.19).
14 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: RAFAEL VERA GARCIA;ROMERO GONZALEZ RAFAEL;RUIZ SOLIS JESUS ENRIQUE;GUTIERREZSANCHEZ LUIS;RICHARTE MARIN MIGUEL. Datos registrales. T 5935 , F 16, S 8, H SE 12249, I/A 60 ( 7.12.18).
04 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 15, S 8, H SE 12249, I/A 58 (25.04.18).
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 15, S 8, H SE 12249, I/A 59 (25.04.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: BRUGUERA CHAVARRIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 5935 , F 14, S 8, H SE 12249, I/A 57 (7.02.18).
17 de Enero de 2018Revocaciones. Apoderado: CAMACHO GOMEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 5935 , F 14, S 8, H SE 12249, I/A 56 (10.01.18).
11 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: CIRERA MECA BERTA. Nombramientos. Apo.Sol.: TANTINYA CUNI ANNA. Datos registrales. T 5935 ,F 14, S 8, H SE 12249, I/A 55 ( 3.08.17).
07 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ SANCHEZ LUIS. Datos registrales. T 5935 , F 13, S 8, H SE 12249, I/A 54 (25.10.16).
20 de Junio de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5935 , F 13, S 8, H SE 12249, I/A 53 ( 7.06.16).
11 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: CAMACHO GOMEZ FRANCISCO. Nombramientos. Apoderado: CAMACHO GOMEZ FRANCISCO.Datos registrales. T 5935 , F 12, S 8, H SE 12249, I/A 52 ( 1.03.16).
12 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: CIRERA MECA BERTA. Datos registrales. T 5935 , F 12, S 8, H SE 12249, I/A 51 ( 2.06.15).
14 de Mayo de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: GABRIEL CALDERON MERA. Apo.Man.Soli: MARIA ROSA GARCIA MORIEL. Apo.Sol.: LUIS ANTONIOMARTINEZ RODRIGUEZ;GUTIERREZ SANCHEZ LUIS;CUDER ALVAREZ ALBERTO;GARIA GAMERO CARMEN;RUDILLAGONZALEZ ANGEL;RAMIREZ ESTEVEZ PILAR;RAFAEL VERA GARCIA;RIBA TORNDELACREU ANNA. Datos registrales. T 5935, F 12, S 8, H SE 12249, I/A 50 ( 7.05.15).
09 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ALBERTO SASTRE EDUARD. Datos registrales. T 5935 , F 11, S 8, H SE 12249, I/A 49 (26.02.15).
19 de Diciembre de 2014Nombramientos. Consejero: ZORRILLA NEBOT ALBERTO. Con.Delegado: ZORRILLA NEBOT ALBERTO. Datos registrales. T5935 , F 11, S 8, H SE 12249, I/A 48 (11.12.14).
20 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: IBAÑEZ BERNALDO DE QUIROS JORGE. Con.Delegado: IBAÑEZ BERNALDO DE QUIROSJORGE. Datos registrales. T 5935 , F 11, S 8, H SE 12249, I/A 47 (11.11.14).
02 de Enero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES PEREZ PEDRO. Datos registrales. T 3992 , F 59, S 8, H SE 12249, I/A 46 (20.12.13).
23 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: JUAN ANTONIO CAMACHO MARTINEZ. Datos registrales. T 3992 , F 58, S 8, H SE 12249, I/A 45(14.10.13).
25 de Junio de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3992 , F 58, S 8, H SE 12249, I/A 44 (17.06.13).
10 de Febrero de 2012Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 14. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 3992 , F 58, S 8, H SE 12249,I/A 43 (30.01.12).
09 de Enero de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANDREU VILA JORDI;ALBERTO SASTRE EDUARD. Nombramientos. Apo.Manc.: ANDREU VILAJORDI;ALBERTO SASTRE EDUARD;TORRES LOPEZ JOAQUIM JORDI. Apo.Man.Soli: ANDREU VILA JORDI;ALBERTO SASTREEDUARD. Datos registrales. T 3992 , F 57, S 8, H SE 12249, I/A 42 (19.12.11).
03 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: ENRIC MILAN VILLAR. Consejero: ENRIC MILAN VILLAR. Vicepresid.: ELISABET BASSOLSMARTIN DE LOS SANTOS. Secretario: ELISABET BASSOLS MARTIN DE LOS SANTOS. Consejero: ELISABET BASSOLS MARTINDE LOS SANTOS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ENRIC MILAN VILLAR;ELISABET BASSOLS MARTIN DE LOS SANTOS.Apoderado: ARRUGA FERNANDEZ EDUARDO. Nombramientos. Consejero: ANDREU VILA JORDI;ALBERTO SASTRE EDUARD.Presidente: ANDREU VILA JORDI. Secretario: ALBERTO SASTRE EDUARD. Vicepresid.: ALBERTO SASTRE EDUARD.Apo.Man.Soli: ANDREU VILA JORDI;ALBERTO SASTRE EDUARD. Apo.Sol.: JUNQUERA BERNAL XAVIER;MARTI SOPENASARA;SCHRODER ANDREA PATRICIA;RIBA TORNDELACREU ANNA;PONS GOMEZ MARIA. Datos registrales. T 3992 , F 55, S8, H SE 12249, I/A 41 (15.07.11).
18 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: ANDREU VILA JORDI. Datos registrales. T 3992 , F 54, S 8, H SE 12249, I/A 39 ( 4.01.11).
Nombramientos. Apoderado: TORRES LOPEZ JOAQUIM JORDI. Datos registrales. T 3992 , F 55, S 8, H SE 12249, I/A 40 (4.01.11).
29 de Noviembre de 2010Nombramientos. Auditor: ERNEST & YOUNG SL. Datos registrales. T 3992 , F 54, S 8, H SE 12249, I/A 38 (15.11.10).
20 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: VALENTIN CORUÑA PEREZ. Secretario: VALENTIN CORUÑA PEREZ. Con.Delegado: VALENTINCORUÑA PEREZ. Nombramientos. Consejero: IBAÑEZ BERNALDO DE QUIROS JORGE. Con.Delegado: IBAÑEZ BERNALDO DEQUIROS JORGE. Secretario: ELISABET BASSOLS MARTIN DE LOS SANTOS. Datos registrales. T 3992 , F 53, S 8, H SE 12249,I/A 37 ( 6.09.10).
30 de Septiembre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3992 , F 53, S 8, H SE 12249, I/A36 (17.09.09).