Actos BORME de Vereda Del Valle Sa
18 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CUESTA VEGUILLA SA;JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL;LOPEZ GOMEZFRUCTUOSO;ARQUITRABE ACTIVOS SL;LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL;PROMOTORA GE-TRES SA;DIVERSIS SERVICIOSINMOBILIARIOS SL;LOPEZ GONZALEZ ALBERTO. Vicesecret.: JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL. Cons.Del.Sol: LOPEZGOMEZ FRUCTUOSO. Presidente: LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO. Cons.Del.Man: LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO. Cons.Del.Sol:ARQUITRABE ACTIVOS SL. Secretario: ARQUITRABE ACTIVOS SL. Cons.Del.Man: ARQUITRABE ACTIVOS SL. Cons.Del.Sol:LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL. Cons.Del.Man: LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: LOPEZGOMEZ FRUCTUOSO;LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL;LOPEZ GONZALEZ ALBERTO;JAF PROYECTOS Y SERVICIOSAGUILA SL. Presidente: LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO. Secretario: JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL. Cons.Del.Sol: JAFPROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL;LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL;LOPEZ GONZALEZ ALBERTO;LOPEZ GOMEZFRUCTUOSO. Otros conceptos: Cambiado el representante persona fisica de "DIVERSIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL" pordoña Emma Antolín Granet. Datos registrales. T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 12 ( 3.01.19).
Fe de erratas: Rectificada la cantidad desembolsada siendo la correcta 104.413 euros. Datos registrales. T 1544 , F 24, S 8, H TO24786, I/A 13 (10.01.19).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 10.336,00 Euros. Datos registrales. T 1544 , F 24, S 8, H TO 24786, I/A 14(10.01.19).
Reducción de capital. Importe reducción: 1.399.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.600.800,00 Euros. Datos registrales. T 1544 ,F 24, S 8, H TO 24786, I/A 15 (10.01.19).
12 de Noviembre de 2012Otros conceptos: Cambiado el representante persona física en la Sociedad "PROMOTORA GE-TRES, SA", siendo el actual DonMiguel Angel Arranz Alonso de Celada. Datos registrales. T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 11 (29.10.12).
05 de Octubre de 2012Nombramientos. Vicesecret.: JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL. Datos registrales. T 1543 , F 35, S 8, H TO 24786, I/A9 (24.09.12).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 104.450,94 Euros. Datos registrales. T 1543 , F 36, S 8, H TO 24786, I/A 10(24.09.12).
06 de Junio de 2012Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 486.051,00 Euros. Datos registrales. T 1543 , F 35, S 8, H TO 24786, I/A 8(28.05.12).
25 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ VILLAESCUSA EDUARDO. Cons.Del.Man: LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL.Cons.Del.Sol: LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL;LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO. Cons.Del.Man: LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO.Nombramientos. Cons.Del.Sol: LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO;LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL;ARQUITRABE ACTIVOS SL.Cons.Del.Man: LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO;LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL;ARQUITRABE ACTIVOS SL. Reelecciones.Consejero: ARQUITRABE ACTIVOS SL;JAF PROYECTOS Y SERVICIOS AGUILA SL;LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO;PROMOTORAGE-TRES SA;CUESTA VEGUILLA SA;LOPEZ GONZALEZ JOSE MANUEL;DIVERSIS SERVICIOS INMOBILIARIOS SL;LOPEZGONZALEZ ALBERTO. Presidente: LOPEZ GOMEZ FRUCTUOSO. Secretario: ARQUITRABE ACTIVOS SL. Datos registrales. T1338 , F 56, S 8, H TO 24786, I/A 7 (16.04.12).
26 de Enero de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 2.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1338 , F 56, S 8, H TO 24786, I/A 5(12.01.09).