Actos BORME de Verica Atlantica Sl
11 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: NOAIN LARRINAGA CARMEN;COLAS YBA脩EZ INES. Revocaciones. Apoderado: FRAGAMORENO MANUEL;JERAK IVAN;FRAGA DE LEON RAUL ELADIO;JERAK KAREL;FERRAZ ROMERO LUIS JAIME.Nombramientos. VsecrNoConsj: COLAS YBA脩EZ INES;MORENO DE LA SANTA ZABIA PALOMA. Otros conceptos: Se revocanlos poderes D陋 BEATRIZ DIEZ ARRANZ, D陋 CARMEN ROZPIDE ORBEGOZO, D潞 MANUEL FRAGA MORENO, D潞 IVAN JERAK, D潞RAUL ELADIO FRAGA DE LEON, D潞 KAREL JERAK, D潞 LUIS JAIME FERRAZ ROMERO, en relaci贸n con las cuentas bancariastitularidad de la sociedad abiertas en el Banco Santander Se revocan los poderes otorgados a D. Ra煤l Eladio Fraga de Le贸n y D. Iv谩nJerak, que causo la inscripcion 2潞, dejando VIGENTES respecto de los otros apoderados de dicha inscripci贸n. Datos registrales. T26967 , F 187, S 8, H M 479110, I/A 28 ( 4.08.23).
19 de Abril de 2022Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 26967 , F 186, S 8, H M 479110, I/A 26 ( 8.04.22).
07 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FRAGA DE LEON RAUL ELADIO. VsecrNoConsj: GARCIA SILVESTRE IGNACIO. Nombramientos.Consejero: FRAGA SALAZAR ENRIQUE. VsecrNoConsj: NOAIN LARRINAGA CARMEN. Datos registrales. T 26967 , F 186, S 8, HM 479110, I/A 25 (30.09.21).
14 de Agosto de 2019Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 26967 , F 186, S 8, H M 479110, I/A 24 ( 7.08.19).
24 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social . Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41 - 4潞PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 26967 , F 185, S 8, H M 479110, I/A 23 (17.04.18).
27 de Abril de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 72.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.706.050,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:55.208,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.761.258,00 Euros. Datos registrales. T 26967 , F 183, S 8, H M 479110, I/A 21 (19.04.17).
31 de Enero de 2017Otros conceptos: Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia dela escritura de fusi贸n y segregaci贸n que caus贸 la inscripci贸n 1陋 de la hoja 624.626. Datos registrales. T 26967 , F 181, S 8, H M479110, I/A 17M (16.01.17).
20 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: JERAK KAREL;FRAGA LEON LUIS ENRIQUE;FRAGA SALVAGGIO MANUEL ANTONIO.Cons.Del.Sol: FRAGA LEON LUIS ENRIQUE;FRAGA MORENO MANUEL. Nombramientos. Consejero: FRAGA LEONJAVIER;CASTRECHINI ANTONIO;PRIETO HERRERA RICARDO JOSE. Datos registrales. T 26967 , F 183, S 8, H M 479110, I/A 20(13.04.16).
22 de Febrero de 2016Modificaciones estatutarias. Aprobado nuevo texto de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 26967 , F 181, S 8, H M 479110,I/A 19 (15.02.16).
30 de Noviembre de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: VERICA HOLDINGS NV. Datos registrales. T 26967 , F 181, S 8, H M 479110, I/A18 (23.11.15).
26 de Noviembre de 2015Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 26967 , F 180, S 8, H M 479110, I/A 17 (18.11.15).
28 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: MELENDEZ ACEDO ELISA. Nombramientos. VsecrNoConsj: GARCIA SILVESTRE IGNACIO.Datos registrales. T 26967 , F 180, S 8, H M 479110, I/A 16 (21.01.15).
10 de Abril de 2014P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 26967 , F 180, S 8, H M 479110, I/A 15 ( 3.04.14).
29 de Octubre de 2012Reelecciones. Aud.C.Con.: AUREN AUDITORES MADRID SL. Datos registrales. T 26967 , F 180, S 8, H M 479110, I/A 14(18.10.12).
29 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: FRAGA MORENO MANUEL. Nombramientos. Consejero: OLMOS GIBAJA JAIME. Presidente:OLMOS GIBAJA JAIME. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ART. 11潞. Datos registrales. T 26967 , F 179, S 8, H M479110, I/A 13 (17.12.10).
30 de Noviembre de 2010Nombramientos. Cons.Del.Sol: FRAGA LEON LUIS ENRIQUE;FRAGA MORENO MANUEL. Datos registrales. T 26967 , F 179, S8, H M 479110, I/A 12 (18.11.10).
13 de Septiembre de 2010Cambio de objeto social. La compraventa, comercializacion y distribucion de insumos y productos agricolas, fertilizantes, asi comocualesquiera otras materias primas o productos terminados relacionados directa o indirecamente con el sector agricola. Datosregistrales. T 26967 , F 178, S 8, H M 479110, I/A 11 ( 1.09.10).
29 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: SANCHEZ LOPEZ CHICHERI ALVARO. Nombramientos. Vicesecret.: MELENDEZ ACEDO ELISA.Datos registrales. T 26967 , F 178, S 8, H M 479110, I/A 10 (19.07.10).
19 de Abril de 2010Nombramientos. Aud.C.Con.: AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 26967 , F 178, S 8, H M479110, I/A 9 ( 7.04.10).
08 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: JERAK IVAN;FERRAZ ROMERO JAIME. Nombramientos. Consejero: FRAGA LEON LUISENRIQUE;FRAGA SALVAGGIO MANUEL ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/4. Datosregistrales. T 26585 , F 68, S 8, H M 479110, I/A 8 (26.03.10).
11 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: FRAGA MORENO MANUEL;JERAK IVAN;FRAGA DE LEON RAUL ELADIO;JERAK KAREL;FERRAZROMERO LUIS JAIME. Datos registrales. T 26585 , F 67, S 8, H M 479110, I/A 7 (29.12.09).
25 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apoderado: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Apo.Man.Soli: DIEZ ARRANZ BEATRIZ;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN.Apo.Manc.: JERAK IVAN;FRAGA DE LEON RAUL ELADIO;JERAK KAREL;FERRAZ ROMERO JAIME;FRAGA MORENO MANUEL.Datos registrales. T 26585 , F 66, S 8, H M 479110, I/A 5 (16.11.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datos registrales. T 26585 , F 67, S 8, H M479110, I/A 6 (16.11.09).
17 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INTERTRUST (SPAIN) SA. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Nombramientos.SecreNoConsj: D'ONZA ROSSANNA. Vicesecret.: SANCHEZ LOPEZ CHICHERI ALVARO. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ.Consejero: FRAGA MORENO MANUEL;JERAK IVAN;FRAGA DE LEON RAUL ELADIO;JERAK KAREL;FERRAZ ROMEROJAIME;INTERTRUST (SPAIN) SA. Presidente: FRAGA MORENO MANUEL. Vicepresid.: INTERTRUST (SPAIN) SA. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 26585 ,F 65, S 8, H M 479110, I/A 4 (31.08.09).
28 de Agosto de 2009Otros conceptos: EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD DE ESTE HOJA: -FORTISINTERTRUST (SPAIN) SA-, HACAMBIADO SU DENOMINACION SOCIAL,SIENDO LA ACTUAL, -INTERTRUST (SPAIN) SA-. Datos registrales. T 26585 , F 62, S 8,H M 479110, I/A 1-M (19.08.09).
18 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.300,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.627.000,00Euros. Resultante Suscrito: 3.633.300,00 Euros. Otros conceptos: SE A脩ADE A LOS ESTATUTOS SOCIALES UN NUEVOARTICULO, "ARTICULO 5 BIS" GRUPOS DE PARTICIPACIONES. Datos registrales. T 26585 , F 64, S 8, H M 479110, I/A 3 (3.06.09).
22 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: FRAGA MORENO MANUEL;FERRAZ ROMERO LUIS;JERAK ZABKAR IVAN;FRAGA DE LEONRAUL;JERAL LLIJA KAREL;POSADA SESSAREGO ALVARO;REYES MARIA EUGENIA;CELIS MARIA DE LOS ANGELES;LEALMARIA ISABEL;PAUL MARIA LUISA. Datos registrales. T 26585 , F 63, S 8, H M 479110, I/A 2 (11.05.09).
20 de Abril de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 27.03.09. Objeto social: LA ADQUISICION TENENCIA, GESTION Y ADMINISTRACION DEVALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPA脩OL...Domicilio: C/ HERMOSILLA 11 4潞 A (MADRID). Capital: 3.300,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico:COOPERATIEVE VERENIGING VERICA U.A. Nombramientos. Adm. Unico: FORTIS INTERTRUST SPAIN SA. Representan: DIEZARRANZ BEATRIZ. Datos registrales. T 26585 , F 62, S 8, H M 479110, I/A 1 ( 3.04.09).