Actos BORME de Versalya Pharma Sl
13 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: D'ANTUONO MARGHERITA. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ZAPATA FRANCISCOJOSE;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDO HUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;NOMBELA GORDOLEONOR ELENA;GARCIA ESTEBAN VERONICA;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;VILCHEZ QUINO TATIANA ARACELLI. Datosregistrales. T 30236 , F 200, S 8, H M 544221, I/A 26 ( 6.06.23).
13 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: MAS GARCIA ENCARNACION. Apo.Manc.: FERNANDEZ MILLAN JAIME. Nombramientos.Apo.Manc.: NOMBELA GORDO LEONOR ELENA. Apo.Sol.: NOMBELA GORDO LEONOR ELENA;PRESEDO HUETE JAVIER.Apo.Manc.: PRESEDO HUETE JAVIER;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;GARCIA MARIN JOSE. Datos registrales. T 30236 , F199, S 8, H M 544221, I/A 25 ( 6.03.23).
18 de Enero de 2023Cambio de objeto social. La comercializaci贸n, importaci贸n, exportaci贸n, distribuci贸n y venta de toda clase de productosfarmac茅uticos, parafarmac茅uticos, productos sanitarios, diet茅ticos, alimenticios, cosm茅ticos y de perfumer铆a y sus derivados, as铆 comotodas aquellas operaciones conexas, accesorias y complementarias... Datos registrales. T 30236 , F 199, S 8, H M 544221, I/A 24(11.01.23).
23 de Diciembre de 2022Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30236 , F 198, S 8, H M 544221, I/A 23 (16.12.22).
28 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: NIETO MAGRO CONCEPCION;BERRADA EL MAADINI BOURY SANAA. Nombramientos.Apoderado: BARJA DE SOROA MARIA PALOMA. Datos registrales. T 30236 , F 198, S 8, H M 544221, I/A 22 (20.07.22).
10 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ LOPEZ CELIA;NOVA NOVA MYRIAM. Datos registrales. T 30236 , F 197, S 8, H M544221, I/A 21 ( 3.05.22).
08 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30236 , F 197, S 8, H M 544221,I/A 20 (29.10.21).
27 de Septiembre de 2021Modificaciones estatutarias. INCLUSION DEL ARTICULO 23 BIS Y MODIFICACION DEL ARTICULO 29 BIS DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.. Datos registrales. T 30236 , F 196, S 8, H M 544221, I/A 19 (20.09.21).
06 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: MBAPPE USAGE MILLA CAROLE-NATHALIE HELENE;FERNANDEZ MILLAN JAIME;D'ANTUONOMARGHERITA. Datos registrales. T 30236 , F 196, S 8, H M 544221, I/A 18 (26.03.21).
30 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: PRESEDO HUETE JAVIER;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA.Datos registrales. T 30236 , F 195, S 8, H M 544221, I/A 17 (22.10.19).
13 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: MAS GARCIA ENCARNACION;SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;GARCIA MARIN JOSE;SAENZESPINOSA JOSE ANTONIO. Apo.Man.Soli: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;MARTINEZESPIN MARIA-DOLORES. Apo.Manc.: LAMI FRANCESCO MARIA;MBAPPE USAGE MILLA CAROLE-NATHALIE HELENE. Apo.Sol.:GARCIA MARIN JOSE. Apo.Manc.: RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA. Apo.Sol.: NIETO MAGRO CONCEPCION. Apo.Man.Soli:MAS GARCIA ENCARNACION;HERAS CA脩AS INES. Nombramientos. Apoderado: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;PRESEDOHUETE JAVIER;RODRIGUEZ BELTRAN TERESA;NIETO MAGRO CONCEPCION;MAS GARCIA ENCARNACION;GARCIA MARINJOSE;MBAPPE USAGE MILLA CAROLE-NATHALIE HELENE;BERRADA EL MAADINI BOURY SANAA. Datos registrales. T 30236 ,F 192, S 8, H M 544221, I/A 16 ( 6.08.19).
28 de Diciembre de 2018Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 30236 , F 192, S 8, H M 544221,I/A 15 (20.12.18).
30 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: LOPEZ CAMPILLO RAQUEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: DOMENECH CIANCAS JOSEMIGUEL. Datos registrales. T 30236 , F 192, S 8, H M 544221, I/A 14 (23.08.18).
12 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Presidente: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Con.Delegado:SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Revocaciones. Apo.Sol.: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Nombramientos. Presidente:ACEBRON FERNANDEZ ALVARO. Consejero: BARALLOBRE GORDON CARLOS. Datos registrales. T 30236 , F 191, S 8, H M544221, I/A 13 ( 1.03.18).
08 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMI FRANCESCO MARIA. Nombramientos. Consejero: ACEBRON FERNANDEZ ALVARO.Datos registrales. T 30236 , F 191, S 8, H M 544221, I/A 12 (27.04.17).
11 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: PUIG-DURAN FRESCO RAFAEL. Datos registrales. T 30236 , F 190, S 8, H M 544221, I/A 10 (31.10.16).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CAMPILLO RAQUEL;DOMENECH CIANCAS JOSE MIGUEL;FERNANDEZ ESCRIBANOFERNANDEZ JOAQUIN IGNACIO. Datos registrales. T 30236 , F 191, S 8, H M 544221, I/A 11 (31.10.16).
28 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ SANCHEZ REGINO. Datos registrales. T 30236 , F 190, S 8, H M 544221, I/A 8 (22.11.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS;FERNANDEZ ESCRIBANO FERNANDEZ MARIA DEL PILAR.Datos registrales. T 30236 , F 190, S 8, H M 544221, I/A 9 (22.11.13).
25 de Enero de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 450.000,00 Euros. Datos registrales. T 30236 , F 157, S 8,H M 544221, I/A 7 (17.01.13).
24 de Enero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;ACEBRON FERNANDEZ ALVARO;MARTINEZ ESPIN MARIA-DOLORES. Apo.Manc.: LAMI FRANCESCO MARIA;MBAPPE USAGE MILLA CAROLE-NATHALIE HELENE. Apo.Sol.: GARCIAMARIN JOSE. Apo.Manc.: RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA. Apo.Sol.: SCIALDONE SAVERIO GUELFO;NIETO MAGROCONCEPCION. Apo.Man.Soli: MAS GARCIA ENCARNACION;HERAS CA脩AS INES. Apo.Sol.: LOPEZ CAMPILLO RAQUEL;PUIG-DURAN FRESCO RAFAEL;DE EMBRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA. Modificaciones estatutarias. SE INCLUYE ELARTICULO 29-BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Administraci贸n y Representacion.-. Otros conceptos: SE RATIFICAN LOSACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 25 DE OCTUBRE DE 2012. Datos registrales. T 30236 ,F 153, S 8, H M 544221, I/A 6 (16.01.13).
21 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: MAS GARCIA ENCARNACION. Datos registrales. T 30236 , F 152, S 8, H M 544221, I/A 2(11.01.13).
Nombramientos. Apoderado: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30236 , F 152, S 8, H M 544221, I/A 3(14.01.13).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARIN JOSE;DE ENTRAMBASAGUAS ARCONES OLGA MARIA. Datos registrales. T30236 , F 152, S 8, H M 544221, I/A 4 (14.01.13).
Nombramientos. Apoderado: SAENZ ESPINOSA JOSE ANTONIO;RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA. Datos registrales. T 30236, F 153, S 8, H M 544221, I/A 5 (14.01.13).
01 de Octubre de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.07.12. Objeto social: La comercializaci贸n, importaci贸n, exportaci贸n, distribuci贸n y ventade toda clase de productos farmac茅uticos y sus derivados, as铆 como todas aquellasoperaciones conexas, accesorias ycomplementarias relacionadas con la actividad principal. La fabricaci贸n, comercializaci贸n, importaci贸n, exportaci贸n,. Domicilio: C/ SANRAFAEL 3 (ALCOBENDAS). Capital: 200.000,00 Euros. Nombramientos. SecreNoConsj: ENSE脩AT BENLLIURE JAIME LUIS.Consejero: SCIALDONE SAVERIO GUELFO;MBAPPE USAGE MILLA CAROLE-NATHALIE HELENE;LAMI FRANCESCO MARIA.Presidente: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. Con.Delegado: SCIALDONE SAVERIO GUELFO. VsecrNoConsj: LOPEZ CAMPILLORAQUEL. Datos registrales. T 30236 , F 147, S 8, H M 544221, I/A 1 (20.09.12).