Actos BORME de Via Aquitana Sa
29 de Enero de 2019Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 732, L 523, F 64, S 8, H BU 1492, I/A 23 (23.01.19).
14 de Noviembre de 2018Otros conceptos: Cerrada provisionalmente por plazo de SEIS MESES, la hoja registral de la Sociedad "VIA AQUITANA SA",absorbida por "SEUR GEOPOST SL (Registro de MADRID) de conformidad con el art. 231 del Reglamento del Registro Mercntil.Datos registrales. T 732, L 523, F 63, S 8, H BU 1492, I/A N/22 ( 7.11.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: DELMAS YVES PIERRE LOUIS. Datos registrales. T 732, L 523, F 62, S 8, H BU 1492, I/A 22(28.02.18).
08 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: CALZON RAMOS BENJAMIN. Datos registrales. T 732, L 523, F 58, S 8, H BU 1492, I/A 20(26.07.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEBEAU ERIC GUY MAURICE;LUJAN ESPI ALBERTO;LARRA脩AGA LARRA脩AGAITSASO;ROLDAN JIMENEZ RAFAEL. Apo.Sol.: REY MANSILLA ANA BELEN;GOMEZ CHACON GARCIA MARIA INMACULADA.Datos registrales. T 732, L 523, F 59, S 8, H BU 1492, I/A 21 (26.07.17).
13 de Julio de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SEUR GEOPOST SL. P茅rdida del caracter de unipersonalidad.Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ASENJO GOMEZ JOSE SANTOS. Nombramientos. Adm. Unico: NAVARRO PEROMINGOALBERTO. Datos registrales. T 543, L 334, F 11, S 8, H BU 1492, I/A 19 ( 6.07.17).
18 de Noviembre de 2014Reelecciones. Adm. Unico: ASENJO GOMEZ JOSE SANTOS. Datos registrales. T 543, L 334, F 10, S 8, H BU 1492, I/A 18(11.11.14).