Buscador CIF Logo

Actos BORME Viales De Castilla Leon Vialcal Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Viales De Castilla Leon Vialcal Sa

Actos BORME Viales De Castilla Leon Vialcal Sa - A05112750

Tenemos registrados 37 Actos BORME del Registro Mercantil de Avila para Viales De Castilla Leon Vialcal Sa con CIF A05112750

馃敊 Perfil de Viales De Castilla Leon Vialcal Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Avila

Actos BORME de Viales De Castilla Leon Vialcal Sa

21 de Noviembre de 2014
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 146, L 104, F 32, S 8, H AV 166, I/A 103 (10.11.14).

09 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;VERAMENDI B ALEJANDRO;PASCUAL OLIVA LUISALBERTO;LAFONT TORIO JUAN;URIARTE PEREZ MOREIRA ESTIBALIZ;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBANMONICA;CALVI脩O MU脩OZ MIGUEL;MARTIN ROMERO MARIA ELENA;SALVADOR DE SANCHO RAUL;CHOITHRAMANIBECERRA PABLO;TEJADA BIURRUN JORGE;GIMENEZ GARCIA-COURTOY MARIA;ALIANA PORTUGAL ANTONIO;GARCIAPADIAL EDUARDO;MARTIN RAMOS EVA;LAFUENTE ALVAREZ ANTONIA;SANCHO ZAPATERO JUAN MANUEL;CORDOBAFERNANDEZ MARIA JESUS;TOLON BENITO PEDRO. Apo.Sol.: ALIANA PORTUGAL ANTONIO;SANCHO ZAPATERO JUANMANUEL;MARTIN RAMOS EVA;FERRAS VALDEVELL MARIA ELENA;MARCOS ESPINOSA MARIA CARMEN. Apo.Manc.: LOPEZMOZO ERNESTO;ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO;LOSADA HERNANDEZ PEDRO AGUSTIN;PASCUAL OLIVA LUIS ALBERTO.Datos registrales. T 146, L 104, F 32, S 8, H AV 166, I/A 102 (27.08.13).

18 de Abril de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 625.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.000,00 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 140.000,00 Euros. Desembolsado: 140.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 150.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:150.000,00 Euros. Datos registrales. T 146, L 104, F 31, S 8, H AV 166, I/A 101 (10.04.13).

27 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VELASCO ZULUETA ICIAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CLAVERO HERRERA CRISTINA.Datos registrales. T 146, L 104, F 30, S 8, H AV 166, I/A 100 (14.12.12).

19 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: ALBARRAN ROMERO JOSE MARIA. Datos registrales. T 146, L 104, F 28, S 8, H AV 166, I/A 99(30.10.12).

20 de Julio de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ JIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Apoderado: RAMOS MONGE MONICA. Datosregistrales. T 146, L 104, F 28, S 8, H AV 166, I/A 97 ( 9.07.12).

Nombramientos. Apoderado: MANTECA PRIETO PAOLA. Datos registrales. T 146, L 104, F 28, S 8, H AV 166, I/A 98 ( 9.07.12).

18 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: ARESTI IBARROLA IGNACIO. Datos registrales. T 146, L 104, F 27, S 8, H AV 166, I/A 96 ( 4.06.12).

23 de Enero de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 146, L 104, F 27, S 8, H AV 166, I/A 95 ( 3.01.12).

21 de Noviembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: MATIAS HERRANZ CAROLINA;FERNANDEZ MOTA JOSE MARIA;USSIA LIZASOAINALFONSO;MARTIN DE VIDALES GODINO NICOLAS;CUADROS ROCA JOSE MANUEL;LOPEZ-MIGOYA MU脩OZ MERCEDES.Datos registrales. T 146, L 104, F 24, S 8, H AV 166, I/A 94 ( 7.11.11).

04 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: BARROSO AGUILERA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 146, L 104, F 24, S 8, H AV 166, I/A 92(19.09.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ALAMO HECTOR DANIEL;GUTIERREZ JIMENEZ JAVIER. Datos registrales. T 146, L104, F 24, S 8, H AV 166, I/A 93 (19.09.11).

08 de Agosto de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 539.000,00 Euros. Desembolsado: 539.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 635.100,00 Euros.Resultante Desembolsado: 635.100,00 Euros. Datos registrales. T 146, L 104, F 24, S 8, H AV 166, I/A 91 (20.07.11).

26 de Julio de 2011
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 146, L 104, F 24, S 8, H AV 166, I/A 90 ( 6.07.11).

07 de Junio de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ ARIAS FERNANDO A;GONZALEZ GARCIA MU脩OZ SANTOS. Datos registrales. T 140, L 98, F86, S 8, H AV 166, I/A 84 (18.05.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ LOPEZ ALBERTO;ARRIETA GISBERT JOSE JULIO. Datos registrales. T 140, L 98, F 87, S 8,H AV 166, I/A 85 (18.05.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MONTERO JAIME. Datos registrales. T 146, L 104, F 21, S 8, H AV 166, I/A 86 (19.05.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: VICENTE BLANCO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 146, L 104, F 22, S 8, H AV 166, I/A 87(19.05.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN ZUASTI ERNESTO;GATELL RUIZ DE GORDEJUELA FERNANDO;GARCIA GARCIA JOSEANTONIO;CARRRO OLLERO SEBASTIAN. Datos registrales. T 146, L 104, F 22, S 8, H AV 166, I/A 88 (19.05.11).

Nombramientos. Apo.Sol.: VELASCO MARTINEZ JAVIER;CAMARA FONTANET JOSE;LAUSIN ORTEGA PASCUAL;LOPEZ DEHARO ROJO RICARDO;REINOSO DIEZ JUAN;PLASENCIA GORDILLO CARLOS. Datos registrales. T 146, L 104, F 23, S 8, H AV166, I/A 89 (19.05.11).

09 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: SEGUIN SANCHEZ CARLOS. Datos registrales. T 140, L 98, F 86, S 8, H AV 166, I/A 83 (27.04.11).

14 de Abril de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: AGUIRRE DE CARCER MORENO JAIME;AVELLO GARELLY GONZALO. Datos registrales. T 140, L98, F 86, S 8, H AV 166, I/A 82 ( 4.04.11).

11 de Abril de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: DIONIS TRENOR MARIA. Apo.Manc.: DIONIS TRENOR MARIA;DIONIS TRENOR MARIA. Datosregistrales. T 140, L 98, F 84, S 8, H AV 166, I/A 80 (29.03.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ HERMOSILLA AGUSTIN. Datos registrales. T 140, L 98, F 85, S 8, H AV 166, I/A 81(29.03.11).

23 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: VALLEJO LOPEZ JOSE ANTONIO;MARTIN RAMOS EVA;FERNANDEZ GARCIA OBLANCACRISTINA;VALLEJO GONZALEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 140, L 98, F 84, S 8, H AV 166, I/A 79 ( 7.12.10).

29 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: DOMINGUEZ DEL OLMO ELENA;SEGUIN SANCHEZ CARLOS. Datos registrales. T 140, L 98, F 83, S8, H AV 166, I/A 78 (19.10.10).

03 de Agosto de 2010
Reelecciones. Adm. Mancom.: BELTRAN GARCIA-ECHANIZ JUAN IGNACIO;GONZALEZ DE CANALES MOYANO FERNANDO.Datos registrales. T 140, L 98, F 83, S 8, H AV 166, I/A 77 ( 8.07.10).

30 de Junio de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA JOSE;SEGUIN SANCHEZ CARLOS. Datos registrales. T 140, L 98, F 82, S 8, HAV 166, I/A 76 (17.06.10).

27 de Abril de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: MUELA GIJON OSCAR. Datos registrales. T 140, L 98, F 82, S 8, H AV 166, I/A 75 (14.04.10).

03 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: DIEZ FERNANDEZ MARTINIANO. Apo.Sol.: DIEZ FERNANDEZ MARTINIANO. Nombramientos.Apo.Sol.: ORTEGA MONTERO JAIME. Datos registrales. T 140, L 98, F 81, S 8, H AV 166, I/A 74 (13.01.10).

25 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 140, L 98, F 81, S 8, H AV 166, I/A 73 ( 7.01.10).

30 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MORA GARCIA SARA CARMEN;OBIOLS MAZEN FAIDI. Datos registrales. T 134, L 92, F 225, S 8, HAV 166, I/A 72 (20.10.09).

27 de Julio de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBIO RUIZ PEDRO;BARRERA MARTIN FERNANDO;CASTELLANO LOPEZ FERNANDO;URIARTEPEREZ MOREIRAS ESTIBALIZ;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBAN MONICA;CEBADA ROLDAN FERNANDO;PORTILLORUBI JAVIER DEL;CALVI脩O MU脩OZ MIGUEL;MARTIN ROMERO MARIA ELENA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIO RUIZPEDRO;BARRERA MARTIN FERNANDO;URIARTE PEREZ MOREIRAS ESTIBALIZ;LOPEZ BERZAL LAURA;MORENO ESTEBANMONICA;CEBADA ROLDAN FERNANDO;PORTILLO RUBI JAVIER DEL;CALVI脩O MU脩OZ MIGUEL;MARTIN ROMERO MARIAELENA;SALVADOR DE SANCHO RAUL;PASCUAL OLIVA LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 134, L 92, F 224, S 8, H AV 166, I/A71 (10.07.09).

06 de Abril de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: DIEZ FERNANDEZ MARTINIANO. Datos registrales. T 134, L 92, F 224, S 8, H AV 166, I/A 70(24.03.09).

13 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN MENDICUTE GAVELA BELEN. Datos registrales. T 134, L 92, F 223, S 8, H AV 166, I/A 69(26.02.09).

17 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: FERRADAS MILLA JOSE RAMON. Datos registrales. T 134, L 92, F 222, S 8, H AV 166, I/A 67 (7.02.09).

Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ DE VEGA FERNANDO. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GARCIA MU脩OZ SANTOS.Datos registrales. T 134, L 92, F 222, S 8, H AV 166, I/A 68 ( 7.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n