Actos BORME de Vialex Constructora Aragonesa Sl
11 de Octubre de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: FINYCAR SL. Datos registrales. T 4341 , F 88, S 8, H Z 2950, I/A 76 ( 4.10.23).
30 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4341 , F 88, S 8, H Z 2950, I/A 75 (23.01.23).
26 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SORIANO SANCHEZ ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: GARCIA TAPIA LAURA. Datosregistrales. T 4341 , F 87, S 8, H Z 2950, I/A 74 (20.10.22).
08 de Agosto de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: DELGADO ALAMAN MANUEL. Datos registrales. T 4341 , F 87, S 8, H Z 2950, I/A 73 ( 1.08.22).
27 de Junio de 2022Reelecciones. Adm. Mancom.: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4341 , F 86,S 8, H Z 2950, I/A 72 (17.06.22).
16 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4341 , F 86, S 8, H Z 2950, I/A 71 (10.02.22).
03 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4341 , F 86, S 8, H Z 2950, I/A 70 (27.01.21).
19 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: ROBRES PHILIPPE FERNAND. Datos registrales. T 4341 , F 86, S 8, H Z 2950, I/A 69 (13.01.21).
17 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: AZLOR MARSI脩ACH JORDI. Datos registrales. T 4341 , F 86, S 8, H Z 2950, I/A 68 ( 9.11.20).
29 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4341 , F 85, S 8, H Z 2950, I/A 67 (22.01.20).
05 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4341 , F 85, S 8, H Z 2950, I/A 66 (25.02.19).
31 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GRASA ASO JESUS. Apo.Manc.: GRASA ASO JESUS;VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales.T 4138 , F 45, S 8, H Z 2950, I/A 65 (24.05.18).
14 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRASA ASO JESUS. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales. T 4138 , F 44, S8, H Z 2950, I/A 64 ( 4.05.18).
26 de Marzo de 2018Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HORMIGONES GIRAL SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 4138 , F 43, S8, H Z 2950, I/A 63 (20.03.18).
15 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4138 , F 43, S 8, H Z 2950, I/A 62 ( 8.02.18).
24 de Octubre de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4138 , F 43, S8, H Z 2950, I/A 61 (16.10.17).
24 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: CEREZO MURILLO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4138 , F 42, S 8, H Z 2950, I/A 60(17.07.17).
03 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS. Nombramientos. Adm.Mancom.: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4138 , F 40, S 8, H Z 2950, I/A 58(26.06.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;VALLES BLASCO ANAMARIA;DELGADO ALAMAN MANUEL;GIL BALAGUERO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR.Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO;GIL BALAGUERO JORDI;GARCIAGARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR;DELGADO ALAMAN MANUEL. Datos registrales. T 4138 , F 40, S 8, H Z 2950, I/A 59(26.06.17).
18 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4037 , F184, S 8, H Z 2950, I/A 57 (10.05.17).
31 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4037 , F 184, S 8, H Z 2950, I/A 56 (23.01.17).
11 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO;BARO DURICH ELOI;SORIANO SANCHEZ ENRIQUE;MARTINGONZALEZ ANGELES;GARCIA CRUCES MARIA PILAR;LOPEZ VILLAR MANUEL. Datos registrales. T 4037 , F 183, S 8, H Z2950, I/A 55 ( 3.05.16).
05 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4037 , F 183, S 8, H Z 2950, I/A 54 (28.01.16).
17 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA. Apo.Manc.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA. Apo.Sol.: VILLENACONTRERAS LUIS. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS;VALLES BLASCO ANA MARIA. Apo.Sol.: DELGADO ALAMANMANUEL;BERNAT NIUBO JORDI. Apo.Manc.: GARCIA GARCIA JOSE. Apo.Sol.: GARCIA GARCIA JOSE. Apo.Manc.: URBIOLACORTASA OSCAR;DELGADO ALAMAN MANUEL;BERNAT NIUBO JORDI. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPINET FERNANDEZSEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;DELGADO ALAMAN MANUEL;VALLES BLASCO ANA MARIA;GIL BALAGUEROJORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR. Datos registrales. T 4037 , F 181, S 8, H Z 2950, I/A 53 ( 8.06.15).
03 de Febrero de 2015Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4037 , F 181, S 8, H Z 2950, I/A 52 (26.01.15).
24 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ROBRES PHILIPPE FERNAND. Datos registrales. T 4037 , F 181, S 8, H Z 2950, I/A 51 (14.11.14).
07 de Noviembre de 2014Cambio de objeto social. a) La construcci贸n, mantenimiento, rehabilitaci贸n, gesti贸n, explotaci贸n y puesta en marcha de cualesquieraedificaciones, obras de ingenier铆a civil e industrial, as铆 como toda clase de instalaciones e infraestructuras, en toda clase de espacios ysuperficies. b) La construcci贸n de toda clase de pavi. Datos registrales. T 4037 , F 181, S 8, H Z 2950, I/A 50 (30.10.14).
16 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4037 , F 181, S 8, H Z 2950, I/A 49 ( 9.10.14).
05 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: AZLOR MARSI脩ACH JORDI. Datos registrales. T 2729 , F 225, S 8, H Z 2950, I/A 48 (24.04.14).