Actos BORME de Viario A31 Sa
16 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SL EN LIQUIDACION. Nombramientos. Consejero: LANTANIASA. Reelecciones. Consejero: TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SA. Presidente: TECNOLOGIA DE LACONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SA. Consejero: AECOM SPAIN DCS SL;CONSTRUCCIONES RUBAU SA;ORTIZCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA. Datos registrales. T 3726 , F 144, S 8, H A 137158, I/A 22 ( 7.11.23).
03 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3726 , F 144, S 8, H A 137158, I/A 20 (26.12.22).
07 de Octubre de 2022Fe de erratas: Error en la inscripci贸n 19陋 en cuanto al nombre del consejero nombrado, siendo el correcto el siguiente: VELASCOGRUPO EMPRESARIAL SL EN LIQUIDACION. Datos registrales. T 3726 , F 143, S 8, H A 137158, I/A 19 ( 5.05.22).
12 de Mayo de 2022Nombramientos. Consejero: VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SL. Datos registrales. T 3726 , F 143, S 8, H A 137158, I/A 19 (5.05.22).
19 de Febrero de 2021Nombramientos. VsecrNoConsj: PRIEGO LUQUE MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3726 , F 143, S 8, H A 137158, I/A 18(11.02.21).
12 de Febrero de 2021Fe de erratas: La fecha de nombramiento del sujeto nombrado por la inscripci贸n 11陋 es la de 02/08/2019 y no la que por error constapublicada. Datos registrales. T 3726 , F 77, S 8, H A 137158, I/A 11 (12.11.19).
Fe de erratas: La fecha de nombramiento del sujeto nombrado por la inscripci贸n 14陋, es la de 10/12/2019 y no la que por error constapublicada La fecha de nombramiento del sujeto nombrado por la inscripci贸n 14, es lade 19/11/2019 y no la que por error constapublicada. Datos registrales. T 3726 , F 78, S 8, H A 137158, I/A 14 ( 3.09.20).
16 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTIN FRANCO CONCEPCION. Nombramientos. SecreNoConsj: VALENCIA DEL ALCAZARGONZALO. Datos registrales. T 3726 , F 143, S 8, H A 137158, I/A 16 ( 5.11.20).
15 de Septiembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3726 , F 78, S 8, H A 137158, I/A 15 ( 4.09.20).
11 de Septiembre de 2020Nombramientos. Consejero: ONDINA DESARROLLOS SL;RUBAU CONCESIONES SA. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 28潞.Modo de deliberaci贸n y adopci贸n de acuerdos del consejo. Datos registrales. T 3726 , F 78, S 8, H A 137158, I/A 14 ( 3.09.20).
18 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SL. Datos registrales. T 3726 , F 78, S 8, H A 137158, I/A 13(10.02.20).
20 de Noviembre de 2019Nombramientos. Consejero: AGRICOLA EL CASAR SL. Datos registrales. T 3726 , F 77, S 8, H A 137158, I/A 11 (12.11.19).
04 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BELDA DE MERGELINA ROCIO. VsecrNoConsj: VALENCIA DEL ALCAZAR GONZALO.Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN FRANCO CONCEPCION. Datos registrales. T 3726 , F 77, S 8, H A 137158, I/A 10(28.05.19).
16 de Noviembre de 2018Modificaciones estatutarias. Art铆culo 18潞. Mayor铆as reforzadas para la adopci贸n de acuerdos por la junta de accionistas. Datosregistrales. T 3726 , F 77, S 8, H A 137158, I/A 8 ( 7.11.18).
13 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES SA;ARASCON VIAS Y OBRAS SA;VELASCO OBRAS YSERVICIOS SA. Presidente: CONSTRUCCIONES RUBAU SA. Nombramientos. Consejero: VELASCO GRUPO EMPRESARIALSL;TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SA. Presidente: TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRASPUBLICAS SA. Reelecciones. Consejero: AECOM INOCSA SL;CONSTRUCCIONES RUBAU SA;ORTIZ CONSTRUCCIONES YPROYECTOS SA;VELASCO GRUPO EMPRESARIAL SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 28潞. Modo de deliberaci贸n yadopci贸n de acuerdos. Datos registrales. T 3726 , F 76, S 8, H A 137158, I/A 7 ( 2.11.18).
08 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3726 , F 76, S 8, H A 137158, I/A 5 (31.01.17).
17 de Octubre de 2014Reelecciones. Consejero: AECOM INOCSA SL;CONSTRUCCIONES RUBAU SA. Presidente: CONSTRUCCIONES RUBAU SA.Consejero: ARASCON VIAS Y OBRAS SA;ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA;INFRAESTRUCTURAS TERRESTRESSA;VELASCO OBRAS Y SERVICIOS SA. Datos registrales. T 3726 , F 76, S 8, H A 137158, I/A 4 (10.10.14).
11 de Marzo de 2014Revocaciones. Auditor: AUDIFIEL SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3726 , F 76, S 8, H A137158, I/A 3 ( 3.03.14).
19 de Noviembre de 2013Cambio de domicilio social. C/ MEDICO PASCUAL PEREZ 44 2 A (ALICANTE). Datos registrales. T 3726 , F 76, S 8, H A 137158,I/A 2 (11.11.13).
21 de Mayo de 2013Nombramientos. Consejero: AECOM INOCSA SL. Representan: PABLOS ACOSTA JUAN-JOSE. Datos registrales. T 29660 , F93, S 8, H M 450206, I/A 24 (10.05.13).
14 de Marzo de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.400.084,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.029.522,00 Euros. Datos registrales. T29660 , F 92, S 8, H M 450206, I/A 23 ( 7.03.13).
26 de Junio de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 11.649.300,00 Euros. Desembolsado: 11.649.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.829.300,00Euros. Resultante Desembolsado: 17.829.300,00 Euros. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.399.694,00 Euros. ResultanteSuscrito: 15.429.606,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Art铆culo 5潞. Capital Social. Art铆culo de losestatutos: Art铆culo 5潞. Capital Social. Datos registrales. T 25688 , F 191, S 8, H M 450206, I/A 22 (14.06.12).
15 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Representan: GAMBON MORA JOSE IGNACIO. Nombramientos. Representan: DIEZ RIPOLLES FERNANDOALBERTO. Datos registrales. T 25688 , F 190, S 8, H M 450206, I/A 20 (30.05.12).
Ceses/Dimisiones. Representan: NACARINO MURIEL JOSE ANTONIO. Nombramientos. Representan: SOLER PARDOFRANCISCO. Datos registrales. T 25688 , F 190, S 8, H M 450206, I/A 21 ( 1.06.12).
04 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: DIEZ BEIZTEGUI FRANCISCO JAVIER;GAMBON MORA JOSE IGNACIO. Apo.Man.Soli: NACARINOMURIEL JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: NACARINO MURIEL JOSE ANTONIO;SOLER PARDO FRANCISCO;DIEZRIPOLLES FERNANDO ALBERTO. Datos registrales. T 25688 , F 188, S 8, H M 450206, I/A 19 (23.05.12).
20 de Abril de 2012Nombramientos. VsecrNoConsj: VALENCIA DEL ALCAZAR GONZALO. Datos registrales. T 25688 , F 187, S 8, H M 450206, I/A17 (10.04.12).
Nombramientos. Auditor: AUDIFIEL SL. Datos registrales. T 25688 , F 188, S 8, H M 450206, I/A 18 (10.04.12).
28 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: CABOT CUCURELL ANTONIO. Datos registrales. T 25688 , F 187, S 8, H M 450206, I/A 16 (17.03.11).
01 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: INOCSA INGENIERIA SL. Representan: ALFONSO PEREZ MARIA-ELENA. Datos registrales. T25688 , F 187, S 8, H M 450206, I/A 15 (16.02.11).
18 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Representan: CABOT CUCURELL ANTONIO. Nombramientos. Representan: ALFONSO PEREZ MARIA-ELENA. Datos registrales. T 25688 , F 187, S 8, H M 450206, I/A 14 ( 5.11.10).
11 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: SOTOS NICOLAS FERNANDO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: NACARINO MURIEL JOSEANTONIO. Datos registrales. T 25688 , F 186, S 8, H M 450206, I/A 13 ( 1.03.10).
15 de Febrero de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 1.048.000,00 Euros. Datos registrales. T 25688 , F 185, S 8, H M 450206, I/A12 ( 3.02.10).
10 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SOTOS NICOLAS FERNANDO JAVIER;SABUGO PEREZ JOSE MANUEL;GAMBON MORA JOSEIGNACIO;CABOT CUCURELL ANTONIO;GOMEZ SANCHEZ PABLO JESUS;ARCE ALONSO RAUL. Presidente: SABUGO PEREZJOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA;INFRAESTRUCTURASTERRESTRES SA;CONSTRUCCIONES RUBAU SA;VELASCO OBRAS Y SERVICIOS SA;ARASCON VIAS Y OBRAS SA;INOCSAINGENIERIA SL. Representan: ARCE ALONSO RAUL;NACARINO MURIEL JOSE ANTONIO;SABUGO PEREZ JOSEMANUEL;GOMEZ SANCHEZ PABLO JESUS;GAMBON MORA JOSE IGNACIO;CABOT CUCURELL ANTONIO. Datos registrales. T25688 , F 183, S 8, H M 450206, I/A 10 (26.10.09).
Nombramientos. Presidente: CONSTRUCCIONES RUBAU SA. Datos registrales. T 25688 , F 185, S 8, H M 450206, I/A 11(26.10.09).
24 de Septiembre de 2009Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ ALVAREZ JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA DOMINGO PILAR. Datosregistrales. T 25688 , F 183, S 8, H M 450206, I/A 9 (14.09.09).