Actos BORME de Viasol Assistencia Sl
26 de Abril de 2023Revocaciones. Apoderado: DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO. Apo.Manc.: DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO. Datos registrales.T 604 , F 152, S 8, H L 9230, I/A 38 (17.04.23).
27 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA;MARTIN FRANCO SILVIA.Nombramientos. Apoderado: BLANCO JUAREZ PABLO. Apo.Manc.: BLANCO JUAREZ PABLO;BLANCO JUAREZ PABLO;BACHSLOBO JAIME;LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS;LOPEZ GARCIA ALICIA. Datos registrales. T 604 , F149, S 8, H L 9230, I/A 37 (19.01.23).
02 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: BACEIREDO GARCIA VICTOR. Apo.Manc.: BACEIREDO GARCIA VICTOR;MARTIN FRANCOSILVIA;ORTEGA CARBALLO JORGE;LOPEZ GARCIA ALICIA;DE LA FUENTE SOTOMAYOR FRANCISCO JAVIER;LEIGH TOSEMICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS;BACHS LOBO JAIME. Datos registrales. T 604 , F 110, S 8, H L 9230, I/A 35(24.10.22).
08 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE;GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO. Nombramientos. Apo.Sol.:SAMPE PUEY VICENTE JOSE;ORTEGA CARBALLO JORGE. Apo.Manc.: SAMPE PUEY VICENTE JOSE. Datos registrales. T 508, F 112, S 8, H L 9230, I/A 32 (26.01.22).
Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA QUADRA SALCEDO JANINI ANDRES;FERNANDEZ OLIVA ABEL;DANEO CERRO JOSEJAVIER;MARTOS PRAT RODRIGO;MARTINEZ NIETO LAURA;SANCHEZ BOLUDA LUCIA;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DELOS COBOS EUGENIA;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA. Apoderado: LOPEZ GARCIA ALICIA;PONGRACZ
05 de Noviembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 65.343,60 Euros. Resultante Suscrito: 95.394,60 Euros. Otros conceptos: Modificaci贸n del valornominal y renumeraci贸n de las participaciones sociales. Datos registrales. T 506 , F 194, S 8, H L 9230, I/A 31 (28.10.21).
02 de Septiembre de 2021Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DE MONTFERRER-CASTELLBO 26 - LA N (MONTFERRER I CASTELLBO).Datos registrales. T 506 , F 194, S 8, H L 9230, I/A 30 (19.08.21).
26 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 506 , F 192, S 8, H L 9230, I/A 29 (18.08.21).
16 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: HERNANDO PALAHI JORDI. Datos registrales. T 506 , F 164, S 8, H L 9230, I/A 28 ( 3.04.20).
06 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apoderado: DUDE ALVAREZ ESTEFANIA;GENER MARTINEZ LAIA;GUELL BLASI ALICIA. Nombramientos.Apo.Sol.: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA;DEVLIN RORY FRANCIS;PONGRACZ VILMOS. Datosregistrales. T 506 , F 162, S 8, H L 9230, I/A 27 (26.08.19).
14 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: GUELL BLASI ALICIA;LOPEZ GARCIA ALICIA;GENER MARTINEZ LAIA;PONGRAZ VILMOS;RORYFRANCIS DEVLIN. Datos registrales. T 502 , F 174, S 8, H L 9230, I/A 25 ( 7.12.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTOS PRAT RODRIGO;DE LA QUADRA SALCEDO JANINI ANDRES;DANEO CERRO JOSEJAVIER;MARTINEZ NIETO LAURA;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA;FERNANDEZ OLIVA ABEL;SANCHEZ BOLUDALUCIA;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DE LOS COBOS EUGENIA. Datos registrales. T 506 , F 162, S 8, H L 9230, I/A 26 (7.12.18).
04 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Modificada por una diligencia, la escritura de poder autorizada por el Notario de Barcelona, don Ra煤l Gonz谩lezFuentes, el d铆a 9 de marzo de 2017, n煤mero 613 de protocolo, que motiv贸 la inscripci贸n 22陋, en la cual se omiti贸 un apartado en lafacultad n煤mero 7 de las concedidas a los apoderados. Datos registrales. T 502 , F 174, S 8, H L 9230, I/A 23 (22.11.17).
05 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE. Datos registrales. T 502 , F 139, S 8, H L 9230, I/A 21 (25.04.17).
Nombramientos. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE;GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO;DUDE ALVAREZ ESTEFANIA.Datos registrales. T 502 , F 139, S 8, H L 9230, I/A 22 (25.04.17).
08 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MURILLO RODRIGUEZ JAVIER;JOVEN MARTINEZ ANA VICTORIA. Nombramientos. Adm.Unico: ASISTENCIAS CARTER SL. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 7潞 de los Estatutos Sociales.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 498 , F57, S 8, H L 9230, I/A 17 (27.10.16).
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SERRA BLAI;VALLINAS ZORNOZA GABRIEL. Datos registrales. T 498 , F 58, S 8, H L9230, I/A 18 (27.10.16).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RADIO GRUAS SABADELL SL. Datos registrales. T 498 , F 58, S 8, H L 9230, I/A19 (27.10.16).
Nombramientos. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE. Datos registrales. T 498 , F 59, S 8, H L 9230, I/A 20 (27.10.16).
08 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL LA SEU, CALLE B-18, CASTELLCIUTAT (SEU D'URGELL (LA)). Datosregistrales. T 498 , F 57, S 8, H L 9230, I/A 16 ( 2.02.16).
19 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: VALLINAS ZORNOZA GABRIEL. Datos registrales. T 498 , F 56, S 8, H L 9230, I/A 15 ( 7.10.11).
11 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUBILL PORTA JAUME. Nombramientos. Adm. Solid.: MURILLO RODRIGUEZ JAVIER;JOVENMARTINEZ ANA VICTORIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DE MONTFERRER - PARCELA B-15 -MO(MONTFERRER I CASTELLBO). Datos registrales. T 498 , F 55, S 8, H L 9230, I/A 14 ( 2.08.11).