Buscador CIF Logo

Actos BORME Viasol Assistencia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Viasol Assistencia Sl

Actos BORME Viasol Assistencia Sl - B25075102

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Lleida para Viasol Assistencia Sl con CIF B25075102

馃敊 Perfil de Viasol Assistencia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lleida

Actos BORME de Viasol Assistencia Sl

26 de Abril de 2023
Revocaciones. Apoderado: DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO. Apo.Manc.: DE LA RUA RUESCA ALEJANDRO. Datos registrales.T 604 , F 152, S 8, H L 9230, I/A 38 (17.04.23).

27 de Enero de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA;MARTIN FRANCO SILVIA.Nombramientos. Apoderado: BLANCO JUAREZ PABLO. Apo.Manc.: BLANCO JUAREZ PABLO;BLANCO JUAREZ PABLO;BACHSLOBO JAIME;LEIGH TOSE MICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS;LOPEZ GARCIA ALICIA. Datos registrales. T 604 , F149, S 8, H L 9230, I/A 37 (19.01.23).

02 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: BACEIREDO GARCIA VICTOR. Apo.Manc.: BACEIREDO GARCIA VICTOR;MARTIN FRANCOSILVIA;ORTEGA CARBALLO JORGE;LOPEZ GARCIA ALICIA;DE LA FUENTE SOTOMAYOR FRANCISCO JAVIER;LEIGH TOSEMICHAEL BERNARD;DEVLIN RORY FRANCIS;BACHS LOBO JAIME. Datos registrales. T 604 , F 110, S 8, H L 9230, I/A 35(24.10.22).

08 de Febrero de 2022
Revocaciones. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE;GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO. Nombramientos. Apo.Sol.:SAMPE PUEY VICENTE JOSE;ORTEGA CARBALLO JORGE. Apo.Manc.: SAMPE PUEY VICENTE JOSE. Datos registrales. T 508, F 112, S 8, H L 9230, I/A 32 (26.01.22).

Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA QUADRA SALCEDO JANINI ANDRES;FERNANDEZ OLIVA ABEL;DANEO CERRO JOSEJAVIER;MARTOS PRAT RODRIGO;MARTINEZ NIETO LAURA;SANCHEZ BOLUDA LUCIA;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DELOS COBOS EUGENIA;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA. Apoderado: LOPEZ GARCIA ALICIA;PONGRACZ

05 de Noviembre de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 65.343,60 Euros. Resultante Suscrito: 95.394,60 Euros. Otros conceptos: Modificaci贸n del valornominal y renumeraci贸n de las participaciones sociales. Datos registrales. T 506 , F 194, S 8, H L 9230, I/A 31 (28.10.21).

02 de Septiembre de 2021
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DE MONTFERRER-CASTELLBO 26 - LA N (MONTFERRER I CASTELLBO).Datos registrales. T 506 , F 194, S 8, H L 9230, I/A 30 (19.08.21).

26 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ RODRIGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 506 , F 192, S 8, H L 9230, I/A 29 (18.08.21).

16 de Abril de 2020
Nombramientos. Apoderado: HERNANDO PALAHI JORDI. Datos registrales. T 506 , F 164, S 8, H L 9230, I/A 28 ( 3.04.20).

06 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: DUDE ALVAREZ ESTEFANIA;GENER MARTINEZ LAIA;GUELL BLASI ALICIA. Nombramientos.Apo.Sol.: MARTIN FRANCO SILVIA. Apo.Manc.: MARTIN FRANCO SILVIA;DEVLIN RORY FRANCIS;PONGRACZ VILMOS. Datosregistrales. T 506 , F 162, S 8, H L 9230, I/A 27 (26.08.19).

14 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: GUELL BLASI ALICIA;LOPEZ GARCIA ALICIA;GENER MARTINEZ LAIA;PONGRAZ VILMOS;RORYFRANCIS DEVLIN. Datos registrales. T 502 , F 174, S 8, H L 9230, I/A 25 ( 7.12.18).

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTOS PRAT RODRIGO;DE LA QUADRA SALCEDO JANINI ANDRES;DANEO CERRO JOSEJAVIER;MARTINEZ NIETO LAURA;VARELA-GRANDAL RUIBAL ANA PATRICIA;FERNANDEZ OLIVA ABEL;SANCHEZ BOLUDALUCIA;HERNANDEZ-ANTOLIN CABELLO DE LOS COBOS EUGENIA. Datos registrales. T 506 , F 162, S 8, H L 9230, I/A 26 (7.12.18).

04 de Diciembre de 2017
Otros conceptos: Modificada por una diligencia, la escritura de poder autorizada por el Notario de Barcelona, don Ra煤l Gonz谩lezFuentes, el d铆a 9 de marzo de 2017, n煤mero 613 de protocolo, que motiv贸 la inscripci贸n 22陋, en la cual se omiti贸 un apartado en lafacultad n煤mero 7 de las concedidas a los apoderados. Datos registrales. T 502 , F 174, S 8, H L 9230, I/A 23 (22.11.17).

05 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE. Datos registrales. T 502 , F 139, S 8, H L 9230, I/A 21 (25.04.17).

Nombramientos. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE;GARRIGA VAZ DE CONCICAO PABLO;DUDE ALVAREZ ESTEFANIA.Datos registrales. T 502 , F 139, S 8, H L 9230, I/A 22 (25.04.17).

08 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MURILLO RODRIGUEZ JAVIER;JOVEN MARTINEZ ANA VICTORIA. Nombramientos. Adm.Unico: ASISTENCIAS CARTER SL. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 7潞 de los Estatutos Sociales.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 498 , F57, S 8, H L 9230, I/A 17 (27.10.16).

Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SERRA BLAI;VALLINAS ZORNOZA GABRIEL. Datos registrales. T 498 , F 58, S 8, H L9230, I/A 18 (27.10.16).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: RADIO GRUAS SABADELL SL. Datos registrales. T 498 , F 58, S 8, H L 9230, I/A19 (27.10.16).

Nombramientos. Apoderado: SAMPE PUEY VICENTE JOSE. Datos registrales. T 498 , F 59, S 8, H L 9230, I/A 20 (27.10.16).

08 de Febrero de 2016
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL LA SEU, CALLE B-18, CASTELLCIUTAT (SEU D'URGELL (LA)). Datosregistrales. T 498 , F 57, S 8, H L 9230, I/A 16 ( 2.02.16).

19 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apoderado: VALLINAS ZORNOZA GABRIEL. Datos registrales. T 498 , F 56, S 8, H L 9230, I/A 15 ( 7.10.11).

11 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PUBILL PORTA JAUME. Nombramientos. Adm. Solid.: MURILLO RODRIGUEZ JAVIER;JOVENMARTINEZ ANA VICTORIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL DE MONTFERRER - PARCELA B-15 -MO(MONTFERRER I CASTELLBO). Datos registrales. T 498 , F 55, S 8, H L 9230, I/A 14 ( 2.08.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n