Actos BORME de Vicusgraf Sl
19 de Enero de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ARUFE GONDA MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 4259, L 4259, F 164, S 8, H PO 55598, I/A 14(11.01.23).
27 de Octubre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MORANT FERRANDO MARIA LUISA. Nombramientos. Apoderado: ARROYO GARCIA CESAR. Datosregistrales. T 4259, L 4259, F 161, S 8, H PO 55598, I/A 12 (19.10.22).
15 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SL. Datos registrales. T 3907, L 3907, F 98, S 8, H PO 55598, I/A 11 (2.12.21).
10 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: MENDEZ CARRILLO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 3907, L 3907, F 98, S 8, H PO 55598, I/A10 (30.11.18).
30 de Noviembre de 2018Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SL. Datos registrales. T 3907, L 3907, F 98, S 8, H PO 55598, I/A 9(22.11.18).
12 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANDRIES FRANK. Datos registrales. T 3907, L 3907, F 98, S 8, H PO 55598, I/A 8 ( 5.06.17).
21 de Diciembre de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BLUE BOX PARTNER IBERIA SL. Datos registrales. T 3907, L 3907, F 98, S 8, HPO 55598, I/A 7 (13.12.16).
26 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAFAEL HINOJOSA SA. Nombramientos. Adm. Unico: BLUE BOX PARTNER IBERIA SL. Datosregistrales. T 3907, L 3907, F 98, S 8, H PO 55598, I/A 6 (18.08.16).
26 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ HINOJOSA RUBEN. Apo.Man.Soli: GOMEZ CUESTA IGNACIO;CANDRIES FRANK;MERINOHINOJOSA CAROLINA. Apo.Sol.: MORANT FERRANDO MARIA LUISA;DEL MORAL ROGER SANTIAGO;ARUFE GONDA MARIA
11 de Diciembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.095.427,14 Euros. Resultante Suscrito: 1.098.427,22 Euros. Datos registrales. T 3907, L 3907, F95, S 8, H PO 55598, I/A 4 ( 4.12.14).