Actos BORME de Videomedia Sa
18 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: ARQUE FERRARI JORGE;MARTINEZ MARTINEZ ELISEO MANUEL. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 287/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 20/08/2020. Auto de conclusi贸n del concurso. Finalizacion de lafase de liquidacion. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZMAGRO. Resoluciones: Se declara concluso el procedimiento concursal de la sociedad "VIDEOMEDIA SA EN.LIQUIDACION" y seacuerda el archivo de las actuaciones. Cese de las limitaciones a las facultades de administraci贸n y disposici贸n del deudor queestuvieren subsistentes. Extinci贸n de la persona jur铆dica deudora, cierre. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 287/2014.Fecha de resoluci贸n 14/10/2014. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez:DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 20/08/2020, NIF/CIF B86575685. ACCOUNT CONTROL-IUS&AEQUITAS ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP. Extinci贸n. Datos registrales. T 30977 , F 71, S 8, H M 13026, I/A 67(11.09.20).
17 de Marzo de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 287/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 14/10/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Datos registrales.T 30977 , F 70, S 8, H M 13026, I/A 66 ( 9.03.15).
18 de Noviembre de 2014Nombramientos. Representan: MARTINEZ MARTINEZ ELISEO MANUEL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal287/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 14/10/2014. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DELO MERCANTIL. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Resoluciones: EL DEUDOR CONSERVARA LAS FACULTADES DEADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO A LA ADMINISTRACIONCONCURSAL QUE SE DESIGNARA AL EFECTO, MEDIANTE SU AUTORIZACION O CONFORMIDAD. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 287/2014. Fecha de resoluci贸n 14/10/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2 JUZGADODE LO MERCANTIL. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 14/10/2014, NIF/CIF B86575685.ACCOUNT CONTROL-IUS&AEQUITAS ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP. Datos registrales. T 30977 , F 69, S 8, H M13026, I/A A ( 7.11.14).
14 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: TRISQUE SL;ARQUE FERRARI JORGE;VERALIA CORPORACION DE PRODUCTORAS DE CINE YTELEV. Con.Delegado: ARQUE FERRARI JORGE. Presidente: ARQUE FERRARI JORGE. Representan: ARQUE FERRARIJORGE;GIDRON SANCHEZ DANIEL. Secretario: GARCIA HERRERA JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: TRISQUE SL.Representan: ARQUE FERRARI JORGE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administrador 煤nico.REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 19626 , F 225, S 8, H M13026, I/A 65 ( 6.05.13).
13 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: MARTIN GUIRADO JOSE MARIA. Nombramientos. Representan: GIDRON SANCHEZ DANIEL.Datos registrales. T 19626 , F 225, S 8, H M 13026, I/A 64 ( 5.02.13).
08 de Febrero de 2011Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 19626 , F 225, S 8, H M 13026, I/A 63 (28.01.11).
26 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ARQUE FERRARI JORGE. Presidente: ARQUE FERRARI JORGE. Consejero: TRISQUE SL;MARTINGUIRADO JOSE MARIA. Con.Delegado: ARQUE FERRARI JORGE. Nombramientos. Consejero: TRISQUE SL;ARQUE FERRARIJORGE;VERALIA CORPORACION DE PRODUCTORAS DE CINE Y TELEV. Con.Delegado: ARQUE FERRARI JORGE. Presidente:ARQUE FERRARI JORGE. Representan: MARTIN GUIRADO JOSE MARIA. Reelecciones. Representan: ARQUE FERRARIJORGE. Datos registrales. T 19626 , F 224, S 8, H M 13026, I/A 62 (13.10.10).
15 de Julio de 2010Revocaciones. Apoderado: PEREZ BENEROSO FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 19626 , F 223, S 8, H M 13026, I/A 57 (5.07.10).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ BENEROSO FRANCISCO LUIS. Datos registrales. T 19626 , F 223, S 8, H M 13026, I/A 58 (5.07.10).
Revocaciones. Apoderado: PEREZ BENEROSO FRANCISCO. Datos registrales. T 19626 , F 223, S 8, H M 13026, I/A 59 (5.07.10).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ ALONSO JAIME. Datos registrales. T 19626 , F 223, S 8, H M 13026, I/A 60 ( 5.07.10).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MOLINERO OSCAR. Datos registrales. T 19626 , F 224, S 8, H M 13026, I/A 61 (5.07.10).
14 de Julio de 2010Nombramientos. Con.Delegado: ARQUE FERRARI JORGE. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 45 LAPUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DELEGADO DE DON JORGE ARQUE FERRARI. Datos registrales. T19626 , F 217, S 8, H M 13026, I/A 45 ( 2.12.05).
12 de Marzo de 2010Modificaciones estatutarias. RECTIFICADO EL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO AL ORGANO DEADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.. Datos registrales. T 19626 , F 223, S 8, H M 13026, I/A 56 ( 1.03.10).
26 de Enero de 2010Revocaciones. Apoderado: SARTO ZUBERO DANIEL. Datos registrales. T 19626 , F 222, S 8, H M 13026, I/A 55 (15.01.10).
13 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: ARQUE FERRARI JORGE. Consejero: SARTO ZUBERO JOSE DANIEL;VIGURI FLORESVICTOR;TARANTULA SL. Datos registrales. T 19626 , F 222, S 8, H M 13026, I/A 54 ( 3.08.09).