Actos BORME de Vidrala Sa
12 de Diciembre de 2023Ampliación de capital. Suscrito: 1.567.064,76 Euros. Desembolsado: 1.567.064,76 Euros. Resultante Suscrito: 32.908.377,30 Euros.Resultante Desembolsado: 32.908.377,30 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 1756 , F 160, S 8, H VI 1551, I/A 207 (27.11.23).
22 de Noviembre de 2023Otros conceptos: Se acuerda la ampliación de capital social, SIN EJECUCION, de conformidad con el art. 508 de la LSC, en lacantidad de 1.567.064,76 euros. Datos registrales. T 1756 , F 159, S 8, H VI 1551, I/A 206 ( 7.11.23).
19 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: ERRANDONEA DELCLAUX ESTEBAN. Nombramientos. Consj.Domini: ERRANDONEADELCLAUX IÑIGO. Otros conceptos: Se hace constar que el nuevo consejero nombrado por cooptación ocupará el cargo vacantehasta que tenga lugar la primera junta general que se celebre con posterioridad a la reunión del consejo de administración.- Datosregistrales. T 1756 , F 158, S 8, H VI 1551, I/A 205 (25.08.23).
22 de Junio de 2023Ceses/Dimisiones. Consj.Domini: NORONHA GALLO S.A.R.L. Representan: SANTOS GALLO RITA MARIA DE NORONHA EMELO. Nombramientos. Consj.Domini: SANTOS GALLO RITA MARIA DE NORONHA E MELO. Reelecciones. Con.Ind.:GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO. Consj.Domini: DELCLAUX DE LA SOTA RAMON. Vicepresid.: GUMUZIO IÑIGUEZDE ONZOÑO FERNANDO. Datos registrales. T 1756 , F 157, S 8, H VI 1551, I/A 203 ( 8.06.23).
24 de Mayo de 2023Nombramientos. Vicepresid.: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO. Datos registrales. T 1756 , F 157, S 8, H VI 1551, I/A202 ( 4.05.23).
12 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: GUERRA PAULO. Apo.Man.Soli: GUERRA PAULO. Apo.Manc.: GUERRA PAULO;GUERRAPAULO;GUERRA PAULO;GUERRA PAULO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOYA SEGADO ORIOL. Apo.Manc.: GOMEZMERINO RAUL;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDEJORGE. Datos registrales. T 1756 , F 154, S 8, H VI 1551, I/A 201 (25.04.23).
27 de Enero de 2023Ampliación de capital. Suscrito: 1.492.442,58 Euros. Desembolsado: 1.492.442,58 Euros. Resultante Suscrito: 31.341.312,54 Euros.Resultante Desembolsado: 31.341.312,54 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos
22 de Diciembre de 2022Otros conceptos: Se acuerda la ampliación de capital social, SIN EJECUCION, de conformidad con el art. 508 de la LSC, en lacantidad de 1.521.912,42 euros. Datos registrales. T 1711 , F 99, S 8, H VI 1551, I/A 199 ( 9.12.22).
02 de Diciembre de 2022Reducción de capital. Importe reducción: 283.381,50 Euros. Resultante Suscrito: 29.848.869,96 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 1711 , F 98, S 8, H VI 1551, I/A 198 (15.11.22).
27 de Septiembre de 2022Reducción de capital. Importe reducción: 306.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 30.132.251,46 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 1711 , F 97, S 8, H VI 1551, I/A 197 (15.09.22).
06 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ADDVALIA CAPITAL S.A.;ZUBIZARRETA DELCLAUX TERESA. Con.Ind.: ASTRAND JAN G.Representan: SALEGUI ESCOLANO AITOR. Nombramientos. Consj.Domini: SALEGUI ESCOLANO AITOR. Con.Ind.: ANDRADEMORENO INES ELVIRA;WATSON GILLIAN ANNE. Reelecciones. Consejero: DELCLAUX MULLER LUIS;ZAVALA ORTIZ DE LATORRE EDUARDO. Datos registrales. T 1711 , F 96, S 8, H VI 1551, I/A 196 (27.06.22).
28 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: DIEGO MIGUEL GERARDO. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;SANGRONIZ BILBAOLUIS ALBERTO. Nombramientos. Apo.Sol.: ETXEBARRIA AYASTUY GORKA. Datos registrales. T 1711 , F 94, S 8, H VI 1551,I/A 195 ( 7.04.22).
18 de Enero de 2022Ampliación de capital. Suscrito: 1.449.440,40 Euros. Desembolsado: 1.449.440,40 Euros. Resultante Suscrito: 30.438.251,46 Euros.Resultante Desembolsado: 30.438.251,46 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.- . Datosregistrales. T 1711 , F 93, S 8, H VI 1551, I/A 194 (30.12.21).
10 de Diciembre de 2021Otros conceptos: Se acuerda la ampliación de capital social, SIN EJECUCION, de conformidad con el art. 508 de la LSC, en lacantidad de 1.449.440,40 euros. Datos registrales. T 1711 , F 92, S 8, H VI 1551, I/A 193 (22.11.21).
29 de Julio de 2021Reelecciones. Cons.Ext.Dom: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Presidente: DELCLAUX ZULUETA CARLOS. Datos registrales. T1711 , F 91, S 8, H VI 1551, I/A 192 (21.07.21).
17 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER;SCHIMITT ZALBIDEJORGE;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;GUTIERREZ MARTINEZ DECOMPAÑON JAVIER;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA;SCHIMITT ZALBIDE JORGE. Apo.Sol.: MARTINGARCIA OLGA;BERECIBAR MUTIOZABAL JOSE RAMON. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;ROLDAN MAIZ ANGEL;GUERRAPAULO;ITURBE ACHA ENRIQUE;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA;DELCLAUX ZULUETACARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Apo.Man.Soli: ITURBE ACHA ENRIQUE. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;GUERRAPAULO;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;ROLDAN MAIZ ANGEL;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDEFERNANDO MARIA;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;GOMEZMERINO RAUL;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA;GUERRA PAULO;ITURBE ACHA ENRIQUE;SANGRONIZBILBAO LUIS ALBERTO;GUERRA PAULO;ITURBE ACHA ENRIQUE;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDEJORGE;GOMEZ MERINO RAUL;ITURBE ACHA ENRIQUE;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;ROLDANMAIZ ANGEL;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;DELCLAUX ZULUETACARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;GOMEZ MERINO RAUL;ROLDAN MAIZ ANGEL;GUERRA PAULO;ITURBE ACHAENRIQUE;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1711 , F 90, S 8, H VI 1551, I/A 191 (29.01.21).
29 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG S.L. Datos registrales. T 1711 , F 90, S 8, H VI 1551,I/A 190 ( 9.12.20).
15 de Diciembre de 2020Ampliación de capital. Suscrito: 1.380.419,04 Euros. Desembolsado: 1.380.419,04 Euros. Resultante Suscrito: 28.988.811,06 Euros.Resultante Desembolsado: 28.988.811,06 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 1655 , F 144, S 8, H VI 1551, I/A 189 ( 2.12.20).
30 de Septiembre de 2020Reelecciones. Cons.Externo: URIGUEN VILLALBA VIRGINIA. Otros conceptos: Se reelige como miembro del Consejo deAdministración, por el periodo de cuatro años, es decir desde 02/07/2020 hasta el 02/07/2024, al consejero D. Jan G. Astrand, con elcarácter de Consejero Independiente.- Se reelige como miembro del Consejo de Administración, por el periodo de cuatro años, es decirdesde 02/07/2020 hasta el 02/07/2024, al consejero D. Esteban Errandonea Delclaux, con el carácter de Consejero Dominical.- Datosregistrales. T 1655 , F 142, S 8, H VI 1551, I/A 186 ( 4.09.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;CASADO CASUSO MARCOS. Apo.Manc.: GOMEZ MERINORAUL;GUERRA PAULO;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITTZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1655 , F 143, S 8, H VI 1551, I/A 187 (10.09.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: VELASCO ZULUETA ITZIAR. Datos registrales. T 1655 , F 144, S 8, H VI 1551, I/A 188 (10.09.20).
05 de Marzo de 2020Reducción de capital. Importe reducción: 274.084,20 Euros. Resultante Suscrito: 27.608.392,02 Euros. Modificacionesestatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 1655 , F 141, S 8, H VI 1551, I/A 185 (25.02.20).
20 de Diciembre de 2019Ampliación de capital. Suscrito: 1.327.736,04 Euros. Desembolsado: 1.327.736,04 Euros. Resultante Suscrito: 27.882.476,22 Euros.Resultante Desembolsado: 27.882.476,22 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 1655 , F 140, S 8, H VI 1551, I/A 184 (10.12.19).
17 de Octubre de 2019Nombramientos. Con.Ind.: GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO FERNANDO. Otros conceptos: Se reelige como miembro delConsejo de Administración, por el periodo de 4 años (hasta el 28/05/2023) al consejero Don Ramón Delclaux de la Sota, con carácterde Consejero Dominical.- Se reelige como miembro del Consejo de Administración, por 4 años (hasta el 28/05/2023) a "NORONHAGALLO, S.a.r.l."-antes denominada "NORONHA GALLO SGPS, S.A."-, con carácter de Consejero Dominical y se designa a DOÑARITA MARIA DE NORONHA E MELO SANTOS GALLO, como persona física representante.- Datos registrales. T 1655 , F 139, S 8,H VI 1551, I/A 183 ( 1.10.19).
12 de Julio de 2019Otros conceptos: Se aprueba la nueva redacción del Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía junto con suanexo.- Datos registrales. T 1655 , F 136, S 8, H VI 1551, I/A 182 ( 5.07.19).
30 de Noviembre de 2018Ampliación de capital. Suscrito: 1.264.512,36 Euros. Desembolsado: 1.264.512,36 Euros. Resultante Suscrito: 26.554.740,18 Euros.Resultante Desembolsado: 26.554.740,18 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 1655 , F 134, S 8, H VI 1551, I/A 181 (16.11.18).
15 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;CASADO CASUSO MARCOS. Apo.Manc.: GOMEZ MERINORAUL;GUERRA PAULO;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHIMITTZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1655 , F 133, S 8, H VI 1551, I/A 180 ( 6.11.18).
24 de Agosto de 2018Nombramientos. Representan: SALEGUI ESCOLANO AITOR. Reelecciones. Consejero: ADDVALIA CAPITAL S.A.;ZUBIZARRETADELCLAUX TERESA;ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE EDUARDO;DELCLAUX MULLER LUIS. Datos registrales. T 1655 , F 132, S 8,H VI 1551, I/A 179 ( 3.08.18).
27 de Julio de 2018Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG S.L. Datos registrales. T 1655 , F 132, S 8, H VI1551, I/A 178 (17.07.18).
15 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;ROLDAN MAIZ ANGEL;DELCLAUX ZULUETACARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;GOMEZ MERINO RAUL;GUERRA PAULO. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZDE MATAUCO JOSEBA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHIMITT ZALBIDE JORGE. Otrosconceptos: Revocadas en fecha 23-03-2018, las facultades conferidas a favor de Doña Belén EchagÕe Lacabe en el apartado B, delpoder otorgado en fecha 02-10- 2.015, ante el Notario de Bilbao, Don José Antonio Isasi Ezcurdia, nº 4.009 de protocolo, que causó laInsc. 161ª de esta hoja en el R.M. de Alava. Datos registrales. T 1619 , F 107, S 8, H VI 1551, I/A 170 ( 4.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ ARAUZO MARKEL. Datos registrales. T 1655 , F 127, S 8, H VI 1551, I/A 175 ( 4.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ECHAGUE LACABE BELEN. Datos registrales. T 1655 , F 129, S 8, H VI 1551, I/A 176 ( 4.06.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: DIEGO MIGUEL GERARDO. Datos registrales. T 1655 , F 131, S 8, H VI 1551, I/A 177 ( 4.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ MERINO RAUL. Apo.Manc.: GUERRA PAULO;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DEMATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1619 , F 111, S 8, H VI1551, I/A 171 ( 4.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRA PAULO. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;SCHIMITT ZALBIDE JORGE;DELCLAUXZULUETA CARLOS;FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Datos registrales. T 1655 , F 116, S 8, H VI1551, I/A 172 ( 4.06.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Apo.Manc.: GOMEZ MERINORAUL;GUERRA PAULO;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1655 , F 121, S 8, H VI
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROLDAN MAIZ ANGEL. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;GUERRA PAULO;FERNANDEZ DEMENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHIMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T1655 , F 126, S 8, H VI 1551, I/A 174 ( 4.06.18).
06 de Noviembre de 2017Otros conceptos: Se reelige el día 30 de Mayo de 2.017, como miembro del Consejo de Administración, por periodo de cuatro años,al Consejero DON CARLOS DELCLAUX ZULUETA, que tiene carácter de Consejero Dominical, quien continuará desempeñando lasfunciones de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.- Datos registrales. T 1619 , F 107, S 8, H VI 1551, I/A 169(19.10.17).
11 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1619 , F 106, S 8, H VI1551, I/A 167 (28.12.16).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1619 , F 106, S 8, H VI1551, I/A 168 (28.12.16).
16 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER. Nombramientos. Consejero: ASTRAND JAN G.Datos registrales. T 1619 , F 104, S 8, H VI 1551, I/A 164 ( 2.11.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: DELCLAUX ZUBIRIA ALVARO. Datos registrales. T 1619 , F 104, S 8, H VI 1551, I/A 165 ( 2.11.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Datos registrales. T 1619 , F 105, S 8,H VI 1551, I/A 166 ( 2.11.16).
29 de Julio de 2016Otros conceptos: Se reelige a DON ESTEBAN ERRANDONEA DELCLAUX y DOÑA Mª VIRGINIA URIGUEN VILLALBA, comomiembros del Consejo de Administración de la Sociedad, dentro de la categoria de Consejero Dominical el primero y la segunda dentrode la categoría de consejero externo. Datos registrales. T 1597 , F 134, S 8, H VI 1551, I/A 162 (15.07.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARATE GUTIERREZ ELENA. Datos registrales. T 1597 , F 134, S 8, H VI 1551, I/A 163 (18.07.16).
14 de Diciembre de 2015Otros conceptos: Se aprueba la nueva redacción del Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía con sus anexos.-Datos registrales. T 1592 , F 12, S 8, H VI 1551, I/A 159 ( 1.12.15).
Nombramientos. Consejero: NORONHA GALLO SGPS SA. Representan: SANTOS GALLO RITA MARIA DE NORONHA E MELO.Datos registrales. T 1592 , F 18, S 8, H VI 1551, I/A 160 ( 1.12.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ LABURU ANA. Nombramientos. Apo.Sol.: ECHAGUE LACABE BELEN. Datos registrales. T1592 , F 18, S 8, H VI 1551, I/A 161 ( 1.12.15).
24 de Septiembre de 2015Otros conceptos: Modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la compañía, con elfin de adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014 de 3 de Diciembre. Datosregistrales. T 1517 , F 92, S 8, H VI 1551, I/A 157 (19.08.15).
Reelecciones. Consejero: DELCLAUX DE LA SOTA RAMON. Datos registrales. T 1592 , F 12, S 8, H VI 1551, I/A 158 (19.08.15).
05 de Febrero de 2015Reducción de capital. Importe reducción: 384.540,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.290.227,82 Euros. Datos registrales. T 1517 ,F 92, S 8, H VI 1551, I/A 156 (23.01.15).
27 de Noviembre de 2014Ampliación de capital. Suscrito: 1.222.608,72 Euros. Desembolsado: 1.222.608,72 Euros. Resultante Suscrito: 25.674.767,82 Euros.Resultante Desembolsado: 25.674.767,82 Euros. Datos registrales. T 1517 , F 89, S 8, H VI 1551, I/A 154 (20.11.14).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1517 , F 91, S 8, H VI1551, I/A 155 (20.11.14).
09 de Octubre de 2014Nombramientos. Consejero: ZUBIZARRETA DELCLAUX TERESA. Otros conceptos: Se nombra a Doña Teresa ZubizarretaDelclaux consejero POR COOPTACION hasta que se reúna la primera Junta General siguiente. Datos registrales. T 1517 , F 88, S 8,H VI 1551, I/A 151 (26.09.14).
Reelecciones. Consejero: ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE EDUARDO;DELCLAUX MULLER LUIS. Otros conceptos: Se ratifica elnombramiento de Doña Teresa Zubizarreta como miembro del Consejo de Administración por el plazo de 5 años. Datos registrales. T1517 , F 88, S 8, H VI 1551, I/A 152 (26.09.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUIBERT DELCLAUX RAFAEL. Datos registrales. T 1517 , F 89, S 8, H VI 1551, I/A 153 (26.09.14).
17 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1517 , F 87, S 8, H VI1551, I/A 150 (26.12.13).
03 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: NORONHA SANTOS GALLO VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 1517 , F 87, S 8, H VI 1551,I/A 149 (18.11.13).
30 de Agosto de 2013Reelecciones. Consejero: ADDVALIA CAPITAL S.A. Otros conceptos: La Sociedad " ADDVALIA CAPITAL, S.A." designa como surepresentante persona física a Don Aitor Salegui Escolano.- Datos registrales. T 1517 , F 85, S 8, H VI 1551, I/A 148 (13.08.13).
11 de Diciembre de 2012Reducción de capital. Importe reducción: 561.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.452.159,10 Euros. Datos registrales. T 1517 ,F 85, S 8, H VI 1551, I/A 147 (16.11.12).
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1517 , F 84, S 8, H VI1551, I/A 146 (16.11.12).
08 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1517 , F 84, S 8, H VI1551, I/A 145 (19.10.12).
08 de Octubre de 2012Otros conceptos: Modificación de los artículos 4º, 11º, 12º, 13º, 17º, 18º, 24º, 27º y 29º de los Estatutos Sociales, modificación de losartículos 3º, 5º, 8º, 8º bis y 16º del Reglamento de la Junta General de Accionistas, y la aprobación de un nuevo textorefundido delcitado Reglamento. Datos registrales. T 1502 , F 87, S 8, H VI 1551, I/A 141 (21.09.12).
Reelecciones. Consejero: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;DELCLAUX ZUBIRIA ALVARO. Presidente: DELCLAUX ZULUETACARLOS. Datos registrales. T 1517 , F 83, S 8, H VI 1551, I/A 142 (21.09.12).
Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.vidrala.com. Datos registrales. T 1517 , F 83, S 8, H VI1551, I/A 143 (21.09.12).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA. Nombramientos. Apoderado:FERNANDEZ DE MENDIA GONZALEZ DE MATAUCO JOSEBA. Datos registrales. T 1517 , F 83, S 8, H VI 1551, I/A 144 (21.09.12).
14 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA. Apo.Manc.: DELCLAUX ZULUETACARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;GOMEZ MERINO RAUL;ROLDAN MAIZ ANGEL;GUERRA PAULO;ITURBE ACHAENRIQUE;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1502 , F 85, S 8, H VI 1551, I/A 140 (17.02.12).
17 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER;RUIZ PEÑAFIEL JESUS MARIA;SANGRONIZBILBAO LUIS ALBERTO;ITURBE ACHA ENRIQUE;BENGOECHEA OCIO JESUS;VALLEJO MOSLARES JESUS;ARBERASTORDABLE JAVIER;DE LACHA Y OTAÑES ANGEL;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑONJAVIER;RUIZ PEÑAFIEL JESUS MARIA;MANZANARES COSTE JOSE RAMON;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO;SCHMITTZALBIDE JORGE;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA. Apo.Man.Soli: GOMEZ MERINO RAUL;ROLDAN MAIZANGEL. Apo.Manc.: ROLDAN MAIZ ANGEL;GOMEZ MERINO RAUL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELCLAUX ZULUETACARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1494 , F 57, S 8, H VI 1551, I/A 133 (20.01.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ LABURU ANA;MARTIN GARCIA OLGA;BERECIBAR MUTIOZABAL JOSE RAMON. Datosregistrales. T 1494 , F 59, S 8, H VI 1551, I/A 134 (20.01.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;ROLDAN MAIZANGEL;GUERRA PAULO;ITURBE ACHA ENRIQUE;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA;DELCLAUX ZULUETACARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Apo.Man.Soli: GOMEZ MERINO RAUL. Apo.Manc.: GUERRA PAULO;ITURBE ACHAENRIQUE;DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE. Datos registrales. T 1494 , F 61, S 8, H VI 1551, I/A 136(20.01.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRA PAULO. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;ITURBE ACHA ENRIQUE;DELCLAUXZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;ROLDAN MAIZ ANGEL;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDOMARIA;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1494 , F 62, S 8, H VI 1551, I/A 137 (20.01.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ITURBE ACHA ENRIQUE. Apo.Manc.: GOMEZ MERINO RAUL;GUERRA PAULO;DELCLAUXZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDE JORGE;ROLDAN MAIZ ANGEL;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDOMARIA;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1502 , F 84, S 8, H VI 1551, I/A 138 (20.01.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROLDAN MAIZ ANGEL. Apo.Manc.: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;SCHMITT ZALBIDEJORGE;GOMEZ MERINO RAUL;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA;GUERRA PAULO;ITURBE ACHAENRIQUE;SANGRONIZ BILBAO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 1502 , F 85, S 8, H VI 1551, I/A 139 (20.01.12).
14 de Diciembre de 2011Ampliación de capital. Suscrito: 1.191.102,96 Euros. Desembolsado: 1.191.102,96 Euros. Resultante Suscrito: 25.013.159,10 Euros.Resultante Desembolsado: 25.013.159,10 Euros. Datos registrales. T 1494 , F 54, S 8, H VI 1551, I/A 132 ( 2.12.11).
13 de Octubre de 2011Otros conceptos: Modificados los artºs 1º,9º, 10º,12º,14º,18º,25º,26º,35º,43º de los Estatutos sociales; y artºs 2º,2º-bis,3º,5º,8º,8º-bis,y aprobación de un nuevo Capitulo VII del Reglamento de la Junta General de accionistas de la Compañía relativo al foro electrónicode accionistas y creación del artº 26º.- Datos registrales. T 1470 , F 21, S 8, H VI 1551, I/A 131 (21.09.11).
19 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ERRANDONEA DELCLAUX ESTEBAN;URIGUEN VILLALBA VIRGINIA. Nombramientos.Consejero: GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER;URIGUEN VILLALBA VIRGINIA;ERRANDONEA DELCLAUXESTEBAN. Datos registrales. T 1470 , F 21, S 8, H VI 1551, I/A 130 ( 1.08.11).
27 de Julio de 2011Reducción de capital. Importe reducción: 561.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.822.056,14 Euros. Datos registrales. T 1470 ,F 19, S 8, H VI 1551, I/A 129 (11.07.11).
16 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: FUENTES INCHAUSTI JON ANDER;DE LAS FUENTES INCHAUSTI JON ANDER. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GOMEZ MERINO RAUL. Apo.Manc.: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑONJAVIER;SCHIMITT ZALBIDE JORGE;DE SANTIAGO LOPEZ DE URALDE FERNANDO MARIA. Apo.Man.Soli: ROLDAN MAIZANGEL. Apo.Manc.: DELCLAUX ZULUETA CARLOS;GUTIERREZ MARTINEZ DE COMPAÑON JAVIER;DE SANTIAGO LOPEZ DEURALDE FERNANDO MARIA;SCHIMITT ZALBIDE JORGE;ROLDAN MAIZ ANGEL;GOMEZ MERINO RAUL. Datos registrales. T1470 , F 18, S 8, H VI 1551, I/A 128 (16.04.11).
22 de Marzo de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1470 , F 18, S 8, H VI1551, I/A 127 (25.02.11).
03 de Diciembre de 2010Ampliación de capital. Suscrito: 1.161.098,64 Euros. Desembolsado: 1.161.098,64 Euros. Resultante Suscrito: 24.383.056,14 Euros.Resultante Desembolsado: 24.383.056,14 Euros. Datos registrales. T 1282 , F 202, S 8, H VI 1551, I/A 126 (24.11.10).
28 de Septiembre de 2010Reelecciones. Consejero: DELCLAUX DE LA SOTA RAMON. Datos registrales. T 1282 , F 201, S 8, H VI 1551, I/A 125 ( 1.09.10).
30 de Diciembre de 2009Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1282 , F 201, S 8, H VI1551, I/A 124 (11.12.09).
15 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: NORONHA SANTOS GALLO VICTOR MANUEL;DELCLAUX MULLER LUIS;GUIBERT DELCLAUXRAFAEL;IRAZABAL PEREZ JOSE ANGEL;ZAVALA ORTIZ DE LA TORRE EDUARDO. Nombramientos. Consejero: ZAVALAORTIZ DE LA TORRE EDUARDO;DELCLAUX MULLER LUIS;GUIBERT DELCLAUX RAFAEL;NORONHA SANTOS GALLO VICTORMANUEL. Otros conceptos: Se ratifica el nombramiento por cooptación del Consejero " ADDVALIA CAPITAL, S.A.".- Datosregistrales. T 1282 , F 200, S 8, H VI 1551, I/A 123 (14.08.09).