Actos BORME de Vigo Fresh Port Sa
03 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROGECO VIGO SA. Liquidador: PROGECO VIGO SA. Nombramientos. Liquidador: PROGECOVIGO SA. Disolución. Voluntaria. Extinción. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 37, S 8, H PO 59118, I/A 11 (24.12.21).
21 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ PORTELA GARRIDO JORGE. Secretario: GONZALEZ PORTELA GARRIDO JORGE.Consejero: MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN. Nombramientos. Adm. Unico: PROGECO VIGO SA. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administración: Consejo de administración a Administrador único. SE SUPRIMEN LOS ARTICULOS 22º AL 29º DE LOSESTATUTOS, INCLUSIVE. SE MODIFICA EL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS. SE AÑADEN LOS ARTICULOS 22ºBIS Y 23º BIS.Datos registrales. T 4072, L 4072, F 35, S 8, H PO 59118, I/A 9 (14.01.21).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ PORTELA GARRIDO JORGE. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 36, S 8, H PO 59118,I/A 10 (14.01.21).
20 de Enero de 2021Declaración de unipersonalidad. Socio único: PROGECO VIGO SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN LIESHOUT TITUSJOHANNES;RODRIGUEZ REAL JOSE ANTONIO. Presidente: VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES. Datos registrales. T 4072, L4072, F 35, S 8, H PO 59118, I/A 8 (12.01.21).
19 de Noviembre de 2019Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 35, S 8, H PO 59118,I/A 7 (12.11.19).
23 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN. Secretario: VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES. Nombramientos.Presidente: VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES. Secretario: GONZALEZ PORTELA GARRIDO JORGE. Reelecciones. Consejero:GONZALEZ PORTELA GARRIDO JORGE;RODRIGUEZ REAL JOSE ANTONIO;MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN;VAN LIESHOUTTITUS JOHANNES. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 34, S 8, H PO 59118, I/A 6 (14.10.19).
07 de Noviembre de 2018Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 30.000,00 Euros. Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado:30.000,00 Euros. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 34, S 8, H PO 59118, I/A 5 (30.10.18).
07 de Agosto de 2018Reelecciones. Consejero: GONZALEZ PORTELA GARRIDO JORGE;RODRIGUEZ REAL JOSE ANTONIO;MARTINEZ DOMINGUEZJUAN;VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES. Presidente: MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN. Secretario: VAN LIESHOUT TITUSJOHANNES. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 34, S 8, H PO 59118, I/A 4 (31.07.18).
02 de Noviembre de 2017Reelecciones. Consejero: MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN;VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES;GONZALEZ PORTELA GARRIDOJORGE;RODRIGUEZ REAL JOSE ANTONIO. Presidente: MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN. Secretario: VAN LIESHOUT TITUSJOHANNES. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 33, S 8, H PO 59118, I/A 3 (24.10.17).
20 de Septiembre de 2016Reelecciones. Consejero: MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN;VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES;GONZALEZ PORTELA GARRIDOJORGE;RODRIGUEZ REAL JOSE ANTONIO. Presidente: MARTINEZ DOMINGUEZ JUAN. Secretario: VAN LIESHOUT TITUSJOHANNES. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 33, S 8, H PO 59118, I/A 2 (12.09.16).
29 de Octubre de 2015Constitución. Comienzo de operaciones: 25.06.15. Objeto social: La compra/venta, almacenamiento, embarque/desembarque,traspase, envío, traslado o transbordo de cualquier tipo de transporte (marítimo, aéreo, etc) -excepto el terrestre- relacionado conproductos perecederos como frutas, legumbres, hortalizas, frutos secos o deshidratados, flores, plantas, cualqui. Domicilio: MUELL DEGUIXAR S/N - PARROQUIA DE TEIS (VIGO). Capital suscrito: 240.000,00 Euros. Desembolsado: 120.000,00 Euros.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ PORTELA GARRIDO JORGE;VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES;MARTINEZDOMINGUEZ JUAN;RODRIGUEZ REAL JOSE ANTONIO. Secretario: VAN LIESHOUT TITUS JOHANNES. Presidente: MARTINEZDOMINGUEZ JUAN. Datos registrales. T 4072, L 4072, F 30, S 8, H PO 59118, I/A 1 (16.10.15).