Actos BORME de Villaciervos Sa
23 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES. Presidente: DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES. Nombramientos.Consejero: HILLGARTH SEBASTIAN ALAN HENRY PHILIP. Presidente: SERRANO GONZALO FERNANDO. Datos registrales. T34020 , F 2, S 8, H M 55037, I/A 25 (16.10.23).
23 de Junio de 2021Reelecciones. Consejero: RIVERO SANCHEZ TOMAS. Secretario: RIVERO SANCHEZ TOMAS. Datos registrales. T 34020 , F 2, S8, H M 55037, I/A 24 (16.06.21).
02 de Julio de 2019Reelecciones. Consejero: SERRANO GONZALO FERNANDO;DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES. Presidente: DEL BARRIOARRIBAS ANDRES. Datos registrales. T 34020 , F 2, S 8, H M 55037, I/A 23 (25.06.19).
09 de Febrero de 2017Revocaciones. Apoderado: VILLANUEVA IRIBAS TOMAS;CANO GONZALEZ JOSE;DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES;SERRANOGONZALO FERNANDO;RIVERO SANCHEZ TOMAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES;SERRANOGONZALO FERNANDO;RIVERO SANCHEZ TOMAS;HILLGART SEBASTIAN ALAN HENRY PHILIP. Datos registrales. T 34020 , F1, S 8, H M 55037, I/A 22 ( 2.02.17).
11 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CANO GONZALEZ JOSE. Presidente: CANO GONZALEZ JOSE. Secretario: DEL BARRIO ARRIBASANDRES. Nombramientos. Consejero: RIVERO SANCHEZ TOMAS. Presidente: DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES. Secretario:RIVERO SANCHEZ TOMAS. Datos registrales. T 3232 , F 163, S 8, H M 55037, I/A 21 ( 3.11.15).
19 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: GARCIA MATEU ALVARO. Datos registrales. T 3232 , F 163, S 8, H M 55037, I/A 20 (11.11.13).
13 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARTINEZ ANGEL;GARCIA MARTINEZ NORBERTO. Nombramientos. Apoderado:VILLANUEVA IRIBAS TOMAS;CANO GONZALEZ JOSE;DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES;SERRANO GONZALOFERNANDO;RIVERO SANCHEZ TOMAS. Datos registrales. T 3232 , F 162, S 8, H M 55037, I/A 19 ( 4.11.13).
12 de Noviembre de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MARCH JUAN JUAN. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIAMARTINEZ NORBERTO. Nombramientos. Consejero: CANO GONZALEZ JOSE;SERRANO GONZALO FERNANDO;DEL BARRIOARRIBAS ANDRES. Presidente: CANO GONZALEZ JOSE. Secretario: DEL BARRIO ARRIBAS ANDRES. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n.MODIFICADOS LOSARTICULOS 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de domicilio social. C/CASTELLO 77 (MADRID). Datos registrales. T 3232 , F 160, S 8, H M 55037, I/A 18 ( 4.11.13).
04 de Octubre de 2013Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GARCIA MARTINEZ NORBERTO. Datos registrales. T 3232 , F 160, S 8, H M55037, I/A 17 (27.09.13).
03 de Octubre de 2013Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA MARTINEZ NORBERTO. Modificaciones estatutarias. 4.. 8. . 13. . 15. . 17. . 18.. 19. . 20. .21. . Cambio de domicilio social. AVDA PIRINEOS 17 Y 19 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 3232 , F
02 de Julio de 2013Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Solid.: GARCIA GOMEZ ANGEL;GARCIA MARTINEZ NORBERTO. Datosregistrales. T 3232 , F 159, S 8, H M 55037, I/A 14-M (25.06.13).